MIPL-Logo

3decades

 

MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

487369

Report Date :

29.01.2018

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

WEBER-HYDRAULIK GMBH

 

 

Registered Office :

Industriegebiet 3+4 A-4460 Losenstein

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

31.12.2016

 

 

Date of Incorporation :

03.11.1976

 

 

Legal Form :

Limited Liability Company

 

 

Line of Business :

Manufacture of other pumps and compressors.

 

 

No. of Employees :

283 (approx.) (2018)

 

RATING & COMMENTS

(Mira Inform has adopted New Rating mechanism w.e.f. 23rd January 2017)

 

MIRA’s Rating :

A

 

Credit Rating

Explanation

Rating Comments

A

Acceptable Risk

Business dealings permissible with moderate risk of default

 

Status :

Satisfactory

 

 

Payment Behaviour :

No Complaints

 

 

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List

 

Country Name

Previous Rating

(30.06.2017)

Current Rating

(30.09.2017)

Austria

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low Risk

 

A2

Moderately Low Risk

 

B1

Moderate Risk

 

B2

Moderately High Risk

 

C1

High Risk

 

C2

Very High Risk

 

D

 


 

AUSTRIA - ECONOMIC OVERVIEW

 

Austria, with its well-developed market economy, skilled labor force, and high standard of living, is closely tied to other EU economies, especially Germany's. Its economy features a large service sector, a relatively sound industrial sector, and a small, but highly developed agricultural sector.

Economic growth has been relatively weak in recent years, approaching 1% in 2015, but rising to 2.3% in 2017. Austria's 5.8% unemployment rate, while low by European standards, is at its highest rate since the end of World War II, driven by an increased number of refugees and EU migrants entering the labor market. Without extensive vocational training programs and generous early retirement, the unemployment rate would be even higher.

Although Austria's fiscal position compares favorably with other euro-zone countries, it faces several external risks, such as unexpectedly weak world economic growth threatening the export market, Austrian banks' continued exposure to Central and Eastern Europe, repercussions from the Hypo Alpe Adria bank collapse, political and economic uncertainties caused by the European sovereign debt crisis, the current refugee crisis, and continued unrest in Russia/Ukraine. The budget deficit stood at 1% of GDP in 2016 and public debt reached a post-war high of 84.6% of the GDP in 2016.

 

Source : CIA

 


company name and address

 

Weber-Hydraulik GmbH

Industriegebiet 3+4

A-4460 Losenstein

 

 

Activities

 

ÖNACE 28130 100% Manufacture of other pumps and compressors

 

 

Financial data

 

Financial details can also be entered during the period, irrespective of the balance sheet date.

 

total turnover (total sales)

2017

EUR

69.200.000,00

(estimated)

total turnover (total sales)

2016

EUR

69.167.879,97

(exact)

total turnover (total sales)

2015

EUR

59.221.974,34

(exact)

total turnover (total sales)

2014

EUR

57.602.242,73

(exact)

total turnover (total sales)

2013

EUR

57.902.062,18

(exact)

 

total stock

2018

EUR

4.200.000,00

(approx.)

 

total investments

2016

EUR

1.577.848,73

(exact)

 

total company vehicles

2018

 

13

(approx.)

 

total employees

2018

 

283

(approx.)

 

 

General company information

 

Company name

Weber-Hydraulik GmbH

Year of incorporation

1976

Type of company

Manufacturing

Legal form

limited liability company since 1976-11-03

Companies house number

FN 118620 t Steyr since 1976-12-30

Import

Eastern Europe

European Union

 

Export

world-wide

 

ARA-number

7227

VAT number

ATU 24055705

number - Austrian National Bank

159450

Last balance sheet:

2016

Banking connection

UniCredit Bank Austria AG

BLZ 12000

main bank connection

Oberbank AG

BLZ 15000

main bank connection

Raiffeisenbank Ennstal eGen

BLZ 34080

secondary banking connection

 

 

Locations

 

operational

A-4460 Losenstein, Industriegebiet 3+4

registered office

operational

A-4460 Losenstein, Industriegebiet 3+4

registered headquarters, owned property

 

0043 7255 6237

office@weber-hydraulik.at

former

A-4460 Losenstein, Stiedelsbach 1

registered headquarters,

 

 

Private data

 

Surname

Date of birth

Address

Executive positions

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Ing. Bernhard Obermayr

1974-05-16

A-4451 Garsten

Klosterstraße 15

manager, head of sales, head of marketing

0

Dr. Reinhard Felix Pfendtner

1964-01-02

D-71543 Wüstenrot

Eichwaldstraße

manager

0

Alfred Rack

1962-01-05

A-4595 Waldneukirchen

Hörmühle 1

manager, head of accounting

0

Ing. Kurt Sperrer

1967-08-20

A-4461 Laussa

Plattenbergstraße 5

manager

0

Walter List

1964-03-20

A-4490 Markt St. Florian

Am Seisberg 54

joint signing clerk

1

Frank Schlosser

1962-08-26

D-72202 Nagold

Galgenbergstraße

joint signing clerk

0

 

 

 

 

Business unit manager

 

Surname

Date of birth

Address

Executive positions

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Ing. Willibald Pranzl

1964-04-04

A-4460 Losenstein

Industriegebiet 3 + 4(c/o)

head of purchasing

0

Ing. Johann Schmollngruber

 

A-4460 Losenstein

Industriegebiet 3 + 4(c/o)

technical director

0

Mag. Nina Laub

 

A-4460 Losenstein

Industriegebiet 3+4(c/o)

head of personnel

0

 

 

Ownership structure and related companies

 

Company name

Address

Shareholdings in %

Since

Commercial register no.

Shares in this company are held by:

Weber Hydraulik GmbH

D-74363 Güglingen

Heilbronner Straße 30

100 %

1994-09-23

 

 

 

Balance Sheet (absolute) all amounts in EUR

 

 

2016-12-31

Franchises, patents, licences, trademarks and similar rights and advantages

101.631,97

Sum intangible assets

101.631,97

 

Land and leasehold rights with buildings thereon including building on land owned by third parties

6.410.314,23

Other operating and business equipment

653.171,60

Technical plants and machines

2.210.422,94

Advanced payments and constructions in progress

1.342.734,54

Sum tangible assets

10.616.643,31

 

Sum fixed assets

10.718.275,28

 

Raw-, auxiliary materials and supplies

4.200.343,79

Unfinished products

2.389.016,39

Finished products

2.553.125,16

Sum stock

9.142.485,34

 

Claims from delivered goods and performed services

5.103.980,22

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

406.955,15

Other claims and assets

226.282,34

Sum claims

5.737.217,71

 

Latente Steuern

374.454,86

Cash on hand, cheques and bank deposits

3.640.013,62

Sum cash and bank

3.640.013,62

 

Sum current assets

18.519.716,67

 

Deferred charges

96.682,89

Sum deferred charges

96.682,89

Assets

29.709.129,70

 

Subscribed/declared capital

700.000,00

Legal reserves

70.000,00

Other reserves

1.101.519,47

Balance sheet profit/balance sheet loss

14.456.798,76

Thereof profit/loss carried forward

7.416.944,32

Sum equity capital

16.328.318,23

 

Special item investment contributions

6.251,64

Sum floor capital

6.251,64

 

Reserves for severance pays

3.498.869,00

Tax reserves

201.866,63

Other reserves

2.144.973,00

Sum reserves

5.845.708,63

 

Liabilities against credit institutes

3.800.000,00

Liabilities from delivered goods and performed services

2.186.305,82

Liabilities against related firms

274.164,91

Other liabilities

1.268.380,47

Sum liabilities

7.528.851,20

 

Liabilities and shareholders'equity

29.709.129,70

Balance sheet sum

29.709.129,70

 

 

 

P / L Account (absolute) all amounts in EUR

 

 

2016-12-31

Gross sales

69.167.879,97

Increase or decrease in finished and unfinished goods and in service claims

921.971,56

Total turnover or gross profit

70.089.851,53

 

Profits from retirement of fixed assets, except financial assets

5.100,00

Other operating profits

349.870,03

Other operating profits totally

354.970,03

 

Costs for obtained services

-4.788.977,85

Material costs

-30.747.342,42

Costs for obtained services totally

-35.536.320,27

 

Wages

-8.106.018,66

Salaries

-5.789.399,83

Other social fringe benefits

-4.253.345,00

Personnel expenses totally

-18.148.763,49

 

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation

-1.658.545,16

Depreciation tangible assets / intangible assets totally

-1.658.545,16

 

Other operating costs

-6.105.490,91

Administration costs

126.597,55

Total costs

-5.978.893,36

 

Operating result totally

9.122.299,28

 

Interest income, securties income and similar income

56.730,30

Interest and similar disbursements

-208.378,82

Financial profits totally

-151.648,52

 

Results from usual business activity totally

8.970.650,76

 

Taxes on income and profits

-1.930.796,32

Taxes on income and profits totally

-1.930.796,32

 

Annual surplus/annual deficit totally

7.039.854,44

 

Annual profit/annual loss totally

7.039.854,44

 

Profit and loss carried forward from previous year

7.416.944,32

Transfer of profits totally

7.416.944,32

 

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account

14.456.798,76

 

Key ratios

 

 

2016

Cashflow II

8.698.399,60

Debt amortisation period in years

1,12

Bank indebtedness

12,79

Equity capital share in %

54,98

Social capital share

11,78

Fixed assets coverage in %

185,04

Net profit ratio

12,80

Capital turnover

2,36

Return on investment in %

30,90

Cashflow in % of operating performance

12,41

Cashflow I

10.629.195,92

Gross productivity

3,86

Net productivity

1,90

Operating performance

70.089.851,53

Inventories in % of operating performance

13,04

Gross profit

34.553.531,26

 

 

Land Register

 

Last check

2018-01-25

 

Entry number

Cadastral community

Journal number

201

Losenstein                           O 49312

1020/2010

 

Section A – type of property:


GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
378/4     GST-Fläche        *    11851
Bauf.(10)               8434
Sonst(50)               3417  Industriegebiet 3
378/5     Sonst(40)               1720
378/12    GST-Fläche              8005
Bauf.(10)               1234
Sonst(40)               2357
Sonst(50)               4414  Industriegebiet 4
GESAMTFLÄCHE                     21576
Legende:
*: Fläche rechnerisch ermittelt
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude)
Sonst(40): Sonstige (Parkplätze)
Sonst(50): Sonstige (Betriebsflächen)


1  a 116/2008 Zuschreibung Gst 378/12 aus EZ 216
2  a 116/2008 Gemeinsamer Bauplatz auf Gst 378/4 378/5 378/12
(Gemeinde Losenstein 2008-01-21, Zl. Bau-417-1000-2008)
4  a 496/2009 Superädifikat auf Gst 378/4 378/12 (Bürogebäude) Uh 2/09
5  a 1020/2010 Superädifikat auf Gst 378/4 (Heizwerk) Uh 5/2010

Section B – ownership structure:


1 ANTEIL: 1/1
Weber-Hydraulik GmbH
ADR: Industriegebiet 3   4460
a 43/1978 Urkunde 1977-02-21 Eigentumsrecht
b 1030/1991 Namensänderung
c 687/2008 Vorkaufsrecht

Section C – encumbrances:


2  a 687/2008
BESTANDRECHT bis 2038-01-31
gemäß Pkt. II. Bestand- und Mietvertrag 2008-05-02
für Oberbank Immobilien-Leasing Gesellschaft m.b.H.
3  a 687/2008
VORKAUFSRECHT
gemäß Pkt. V. Bestand- und Mietvertrag 2008-05-02
für Oberbank Immobilien-Leasing Gesellschaft m.b.H.

 

 

Commercial register

 

Source of data from commercial register: Republic of Austria represented by the Federal Ministry of Justice

 

firm (style)

1 Weber-Hydraulik GmbH

legal form

1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

registered office

1 politischer Gemeinde Losenstein

business adress

1 Industriegebiet 3+4
4460 Losenstein

capital

10 EUR 700.000,00

reference date annual accounts

1 31.Dezember

annual accounts

38 zum 31.12.2016 eingereicht am 03.08.2017

power of representation

13 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer
bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten.
Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäfts-
führer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige
Vertretungsbefugnis erteilen.

 

proxy

Q    DI (FH) Walter List, geb. 20.03.1964
37    vertritt seit 21.12.2016 gemeinsam mit
einem weiteren Prokuristen oder einem Geschäftsführer
R    Frank Schlosser, geb. 26.08.1962
39    vertritt seit 01.09.2017 gemeinsam mit
einem weiteren Prokuristen oder einem Geschäftsführer

 

managing director

I    Alfred Rack, geb. 05.01.1962
040    vertritt seit 21.11.2017 gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
L    Ing Bernhard Obermayr, geb. 16.05.1974
040    vertritt seit 21.11.2017 gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
O    Dr. Reinhard Felix Pfendtner, geb. 02.01.1964
037    vertritt seit 05.10.2016 selbständig
P    Ing. Kurt Sperrer, geb. 20.08.1967
040    vertritt seit 21.11.2017 gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen

 

shareholder


C    WEBER HYDRAULIK GMBH
010    ........................................  EUR  700.000,00
010    ........................................................................................................................................  EUR  700.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                          EUR  700.000,00                                                                        EUR  700.000,00

 

general table


Landesgericht Steyr
1   eingetragen am 23.09.1994        Geschäftsfall 499 912 Fr 58/94 p
Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
2   eingetragen am 11.11.1994        Geschäftsfall 499 006 Fr 460/94 v
Berichtigung - Antrag  eingelangt am 03.10.1994
3   eingetragen am 26.08.1998        Geschäftsfall 499 021 Fr 1437/98 a
Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.08.1998
4   eingetragen am 22.10.1999        Geschäftsfall 499 021 Fr 2657/99 d
Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 29.09.1999
5   eingetragen am 14.06.2000        Geschäftsfall 499 021 Fr 1925/00 d
Einreichung Jahresabschluss 1999 eingelangt am 08.06.2000
6   eingetragen am 06.04.2001        Geschäftsfall 499 021 Fr 620/01 v
Antrag auf Änderung - Geschäftsführer und Prokurist
eingelangt am 30.03.2001
7   eingetragen am 19.06.2001        Geschäftsfall 499 021 Fr 1234/01 x
Antrag auf Änderung PR eingelangt am 11.06.2001
8   eingetragen am 12.10.2001        Geschäftsfall 499 021 Fr 2262/01 h
Einreichung Jahresabschluss 2000 eingelangt am 04.10.2001
9   eingetragen am 05.06.2002        Geschäftsfall 499 021 Fr 1585/02 x
Einreichung Jahresabschluss 2001 eingelangt am 04.06.2002
10  eingetragen am 19.07.2002        Geschäftsfall 499 021 Fr 1872/02 v
Antrag auf Änderung - Prokura und Euroanpassung mit Kap.Erh.
eingelangt am 10.07.2002
11  eingetragen am 22.07.2003        Geschäftsfall 499 021 Fr 1893/03 h
Einreichung Jahresabschluss 2002 eingelangt am 18.07.2003
12  eingetragen am 29.09.2004        Geschäftsfall 499 021 Fr 2502/04 m
Einreichung Jahresabschluss 2003 eingelangt am 21.09.2004
13  eingetragen am 04.01.2005        Geschäftsfall 499 021 Fr 3601/04 d
Antrag auf Änderung GVertrag und GF eingelangt am 23.12.2004
14  eingetragen am 20.04.2005        Geschäftsfall 499 021 Fr 1305/05 k
Antrag auf Änderung - GF eingelangt am 08.04.2005
15  eingetragen am 30.09.2005        Geschäftsfall 499 021 Fr 2753/05 s
Einreichung Jahresabschluss 2004 eingelangt am 28.09.2005
16  eingetragen am 12.10.2005        Geschäftsfall 499 021 Fr 2936/05 i
Antrag auf Änderung Geschäftsführer und Prokuristen
eingelangt am 07.10.2005
17  eingetragen am 21.09.2006        Geschäftsfall 499 021 Fr 2145/06 f
Einreichung Jahresabschluss 2005 eingelangt am 14.09.2006
18  eingetragen am 18.09.2007        Geschäftsfall 499 021 Fr 2171/07 b
Einreichung Jahresabschluss 2006 eingelangt am 14.09.2007
19  eingetragen am 29.03.2008        Geschäftsfall 499 021 Fr 809/08 h
Antrag auf Änderung Prokura eingelangt am 27.03.2008
20  eingetragen am 18.09.2008        Geschäftsfall 499 021 Fr 2185/08 g
Antrag auf Änderung 31.12.2007 eingelangt am 12.09.2008
21  eingetragen am 29.09.2009        Geschäftsfall 499 021 Fr 2650/09 z
Einreichung Jahresabschluss 31.12.2008 eingelangt am 25.09.2009
22  eingetragen am 24.09.2010        Geschäftsfall 499 021 Fr 2359/10 f
Einreichung Jahresabschluss 31.12.2009 eingelangt am 20.09.2010
23  eingetragen am 13.01.2011        Geschäftsfall 499 021 Fr 99/11 s
Antrag auf Änderung - Adressenänderung eingelangt am 12.01.2011
24  eingetragen am 02.09.2011        Geschäftsfall 499 021 Fr 3138/11 i
Antrag auf Änderung - Adresse eingelangt am 31.08.2011
25  eingetragen am 16.09.2011        Geschäftsfall 499 021 Fr 3402/11 y
Elektronische Einreichung Jahresabschluss 31.12.2010
eingelangt am 14.09.2011
26  eingetragen am 12.09.2012        Geschäftsfall 499 021 Fr 2295/12 d
Elektronische Einreichung Jahresabschluss 31.12.2011
eingelangt am 07.09.2012
27  eingetragen am 18.01.2013        Geschäftsfall 499 021 Fr 133/13 h
Antrag auf Änderung GF eingelangt am 16.01.2013
28  eingetragen am 18.09.2013        Geschäftsfall 499 021 Fr 2559/13 a
Elektronische Einreichung Jahresabschluss 31.12.2012
eingelangt am 16.09.2013
29  eingetragen am 02.07.2014        Geschäftsfall 499 021 Fr 1409/14 v
Antrag auf Änderung GF eingelangt am 23.06.2014
30  eingetragen am 30.08.2014        Geschäftsfall 499 021 Fr 2114/14 f
Elektronische Einreichung Jahresabschluss 31.12.2013
eingelangt am 28.08.2014
31  eingetragen am 05.09.2015        Geschäftsfall 499 021 Fr 1995/15 p
Elektronische Einreichung Jahresabschluss 31.12.2014
eingelangt am 25.08.2015
32  eingetragen am 05.09.2015        Geschäftsfall 499 021 Fr 2069/15 y
Antrag auf Änderung Prokura eingelangt am 31.08.2015
33  eingetragen am 09.09.2015        Geschäftsfall 499 021 Fr 2196/15 i
amtswegige Berichtigung Postleitzahl
34  eingetragen am 22.06.2016        Geschäftsfall 499 021 Fr 1300/16 a
Antrag auf Änderung Anschrift eingelangt am 17.06.2016
35  eingetragen am 07.09.2016        Geschäftsfall 499 021 Fr 2145/16 v
Elektronische Einreichung Jahresabschluss 31.12.2015
eingelangt am 05.09.2016
36  eingetragen am 22.12.2016        Geschäftsfall 499 021 Fr 3922/16 g
Antrag auf Änderung - Vorlage Umlaufbeschluss
eingelangt am 15.12.2016
37  eingetragen am 14.03.2017        Geschäftsfall 499 021 Fr 270/17 w
Antrag auf Änderung GF und PR eingelangt am 22.02.2017
38  eingetragen am 24.08.2017        Geschäftsfall 499 021 Fr 1788/17 b
Elektronische Einreichung Jahresabschluss 31.12.2016
eingelangt am 03.08.2017
39  eingetragen am 05.09.2017        Geschäftsfall 499 021 Fr 2083/17 k
Antrag auf Änderung PR eingelangt am 01.09.2017
40  eingetragen am 08.12.2017        Geschäftsfall 499 021 Fr 4044/17 w
Antrag auf Änderung GF und PR eingelangt am 04.12.2017


 

 

Historical development

 

Year of incorporation

1976

Date of registration

1976-12-30

 

 

Change in share capital

 

from

to

asset

 

1994-09-23

2002-07-19

ATS

9.350.000,00

 

 

Former executives

 

from

to

position

name

2013-01-18

2017-03-14

manager

Volker Plücker

2005-10-12

2017-03-14

joint signing clerk

Willibald Pranzl

2017-03-14

2017-12-08

joint signing clerk

Kurt Sperrer

2008-03-29

2017-12-08

joint signing clerk

Bernhard Obermayr

2005-10-12

2017-12-08

joint signing clerk

Alfred Rack

2005-10-12

2014-07-02

manager

Josef Nöbauer

2002-07-19

2005-10-12

individual signing clerk

Josef Nöbauer

2005-10-12

2015-09-05

joint signing clerk

Volker Oberhagemann

2001-04-06

2005-10-12

individual signing clerk

Volker Oberhagemann

1994-09-23

2005-10-12

manager

Martin Weber

2001-04-06

2005-04-20

manager

Lothar Haselmann

2001-04-06

2001-06-19

individual signing clerk

Fabian Budde

2008-03-29

2017-03-14

joint signing clerk

Leopold Brandner

2005-01-04

2013-01-18

manager

Bernhard Herzig

2014-07-02

2017-12-08

manager

Hans Kristian Kerwat

1994-09-23

2001-04-06

manager

Günther Gruber

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

INR 63.50

UK Pound

1

INR 90.92

Euro

1

INR 79.07

EURO

1

INR 79.02

 

Note : Above are approximate rates obtained from sources believed to be correct

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

NIY

 

 

Report Prepared by :

POJ

 


 

RATING EXPLANATIONS

 

Credit Rating

Explanation

Rating Comments

A++

Minimum Risk

Business dealings permissible with minimum risk of default

A+

Low Risk

Business dealings permissible with low risk of default

A

Acceptable Risk

Business dealings permissible with moderate risk of default

B

Medium Risk

Business dealings permissible on a regular monitoring basis

C

Medium High Risk

Business dealings permissible preferably on secured basis

D

High Risk

Business dealing not recommended or on secured terms only

NB

New Business

No recommendation can be done due to business in infancy stage

NT

No Trace

No recommendation can be done as the business is not traceable

 

NB is stated where there is insufficient information to facilitate rating. However, it is not to be considered as unfavourable.

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors are as follows:

 

·         Financial condition covering various ratios

·         Company background and operations size

·         Promoters / Management background

·         Payment record

·         Litigation against the subject

·         Industry scenario / competitor analysis

·         Supplier / Customer / Banker review (wherever available)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.