MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

497162

Report Date :

13.03.2018

 

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

CAROLL INTERNATIONAL

 

 

Registered Office :

Caroll Caroll Paris Ann, 38 Rue Du Hameau, 75740 Paris Cedex 15

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.08.2017

 

 

Date of Incorporation :

Jaunvary 1958

 

 

Legal Form :

Public limited company with board of directors

 

 

Line of Business :

Retail sale of clothing in specialized stores

 

 

No. of Employees :

953

 

 

RATING & COMMENTS

(Mira Inform has adopted New Rating mechanism w.e.f. 23rd January 2017)

 

MIRA’s Rating :

A

 

Credit Rating

Explanation

Rating Comments

A

Acceptable Risk

Business dealings permissible with moderate risk of default

 

Status :

Satisfactory

 

 

Payment Behaviour :

No Complaints

 

 

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List

 

Country Name

Previous Rating

(30.09.2017)

Current Rating

(31.12.2017)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low Risk

 

A2

Moderately Low Risk

 

B1

Moderate Risk

 

B2

Moderately High Risk

 

C1

High Risk

 

C2

Very High Risk

 

D

 


 

FRANCE - ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. France is the most visited country in the world with 83 million foreign tourists in 2016, including 530,000 visitors for the 2016 Euro Cup. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that mitigate economic inequality.

France's real GDP grew by 1.6% in 2017, up from 1.2% the year before. The unemployment rate (including overseas territories) increased from 7.8% in 2008 to 10.2% in 2015, before falling to 9.5% in 2017. Youth unemployment in metropolitan France decreased from 24.6% in the fourth quarter of 2014 to 24% in the fourth quarter of 2016.

France’s public finances have historically been strained by high spending and low growth. Despite measures to restore public finances, the budget deficit rose from 3.3% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009. In 2017, the budget deficit improved to 2.9% of GDP, bringing it in compliance with the EU-mandated 3% deficit target. Meanwhile, France's public debt rose from 89.5% of GDP in 2012 to 96.9% in 2017.

Since entering office in May 2017, President Emmanuel MACRON launched a series of economic reforms to improve competitiveness and boost economic growth. President MACRON campaigned on reforming France’s labor code and in late 2017 implemented a range of reforms to increase flexibility in the labor market by making it easier for firms to hire and fire and simplifying negotiations between employers and employees. In addition to labor reforms, President MACRON’s proposed 2018 budget cuts public spending, taxes, and social security contributions to spur private investment and increase purchasing power.

 

Source : CIA

 


Company Name And Address

SIRET

582 001 707 01699

Click to view full map.

Name

CAROLL INTERNATIONAL

Acronym

-

Trade name

CAROLL

Status

Economically active

Postal Address

CAROLL INTERNATIONAL
CAROLL CAROLL PARIS ANN
38 RUE DU HAMEAU
75740 PARIS CEDEX 15
FRANCE

Share Capital

9,931,887 Euros

Telephone

01 56 23 33 33

Activity (APE)

Retail sale of clothing in specialized stores(4771Z)

RCS Registration

RCS Paris B 582 001 707

Formation Date

01/1958

EUR VAT Number

FR89582001707

Deregistration Date

-

Last account Date

31/08/2017

Court Registry Number

19 5 8B00170

Incorporiation Date

01/1958

Registration Court

Paris (75)

Fax

02 41 52 70 32

Nationality

France

Legal form

Public limited company with board of directors

Currency

Euros

 

 

Key Financials

 

Year to date

Turnover

Gross operating surplus

Shareholder's equity

Net result

Employees

31/08/2017

202,887,029 €

8.96% Turnover

72,735,712 €

7,372,352 €

953 employees

31/08/2016

213,035,919 €

12.69% Turnover

65,401,848 €

13,556,283 €

931 employees

31/08/2015

205,345,125 €

13.88% Turnover

51,892,471 €

13,034,951 €

903 employees

View details

 

 

Directors

 

Current Directors

4

View Details

Ultimate Holding Company

Name

Safe Number

Country

Company Number

VIVARTE

FR00612169

308449024

Affiliation links. View Details

1 company in 1 country. View Details

Judgment and Preferential

Judgment

Last Judgement 11/04/2017

View details

Preferential Right

No social security and tax office preferential right to date

View details

 

 

Establishment Details

 

Type of Establishment

Head Office

Production Role

-

APE/NAF Code

7010Z

Activity

Activités des sièges sociaux

Formation Date

05/2000

Reason for Formation

Other

Closure Date

-

Reason for Closure

-

Reactivation Date

-

Seasonality

-

Activity Nature

-

Activity Location

Other

Trading Address

38 RUE DU HAMEAU
75015 PARIS 15

Department

Paris (75)

Location Surface

-

District

1

City

PARIS 15

Status

Economically active

Business Pages FT®

VETEMENTS POUR HOMMES ET DAMES (DETAIL)

Region

Ile-de-France

Area

-

Size of Urban Area

Paris conglomeration

Ultimate Parent(s)

1 ultimate parent company/companies for this company

Company Name

Activity (APE)

APE/NAF Code

City

Post Code

VIVARTE

Activités des sièges sociaux

7010Z

PARIS 19

75019

Other Establishment(s)

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas but no one grouping more than 50% of workforce

Mono-activity status

Legal unit with multiple establishments having main activities in many divisions, which one activity grouping from 50 to 80% of workforce

Branches

241 branch entities in this company

 

Company Name

Company Type

APE/NAF Code

Activity

City

Post Code

CAROLL INTERNATIONAL

Head Office

4771Z

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

PARIS 15

75015

CAROLL INTERNATIONAL

Branch

4771Z

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

NICE

06000

CAROLL INTERNATIONAL

Branch

4771Z

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

MARSEILLE 1

13001

CAROLL INTERNATIONAL

Branch

4771Z

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

MARSEILLE 16

13016

CAROLL INTERNATIONAL

Branch

4771Z

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

QUIMPER

29000

View Details

Workforces

Workforce at address

100 to 199 employees

Company workforce

1 000 to 1 999 employees

 

 

Workforce account

500 to 999 employees

 

 

31/08/2017

 

 

 

Commentary

 

The comments are ordered according to the class of risk. Companies are compared with regard to other companies of the same type. Thus a positive comment for one category can be negative for another or can change depending on its value. This is a purely statistical decision.

The company has 5 directors

The decrease in the gearing percentage over the last two accounting periods is 12 %

Low risk workforce size

The net turnover is 202,887,029 €

The pre-tax profit is 9,876,594 €

The total assets are 191,275,174 €

The shareholder's equity is 72,735,712 €

The risk provisions are 1,023,037 €

The liabilities are 117,516,425 €

The net current assets are 108,748,590 €

The return on total assets employed is 5.16

The creditor days are 62.29

The ratio total assets to total liabilities is 1.61

The stock to turnover ratio is 17.62

The sales to current assets ratio is 1.87

Industry comparison

Activity (APE)

Retail sale of clothing in specialized stores(4771Z)

 

Collective procedures

Courts

No recent judgment publication in court sources for the company

Rncs

No recent judgment publication in rncs sources for the company

Bodacc

Judgment

Homologation of Legal Settlement

Effective date

11/04/2017

Court

Paris

Parution date from Gazette

28/04/2017

Extrait de jugement

Jugement d'homologation de l'accord

Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Other sources

No recent judgment publication in other sources for the company

Preferential rights details and history

Summary of preferential rights

Company monitored since

17/09/2007

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

 

 

Preferential rights details and history

Summary of preferential rights

Company monitored since

17/09/2007

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

Group Data

Ultimate parent company

VIVARTE

Direct parent

VIVARTE - 99.99 %

Group – Number of companies

31

Linkages – Number of companies

1

Number of countries

1

Group Structure

Go directly to the current company

Rating Information

 

Name

Safe Number

SIREN

Parts

Last account published

 

1

VIVARTE

FR00612169

308449024

-

31/08/2017

VIVARTE

30844902400014

2

KOOKAI

FR19528242

399292994

100 %

31/08/2016

KOOKAI

39929299401872

3

KOOKAI LUXEMBOURG S.À R.L.

LU00151200

B52114

100 %

-

KOOKAI LUXEMBOURG S.à r.l.

-

KOOKAI DEUTSCHLAND GMBH

DE00870815

HRB 52322

100 %

31/08/2016

KOOKAI Deutschland GmbH

-

SC DES DUNES

FR18267556

394253819

50 %

31/12/2012

SC DES DUNES

39425381900046

SC LA FRANCAISE

FR18267554

394253264

50 %

31/12/2012

SC LA FRANCAISE

39425326400045

SMC SERVICES

FR06001196

432713063

100 %

31/08/2017

SMC SERVICES

43271306300027

MERKAL CALZADOS GROUP 2017

ES02331582

775344

100 %

31/08/2017

MERKAL CALZADOS GROUP 2017

-

2

MINELLI SAS

FR04620103

413157306

100 %

31/08/2017

MINELLI SAS

41315730601989

3

GIE COMMERCANTS CTRE COMMERCIAL ARCADES

FR00753839

313631269

0.10 %

-

GIE COMMERCANTS CTRE COMMERCIAL ARCADES

31363126900013

MINELLI DEUTSCHLAND GMBH

DE02716705

HRB 64192

100 %

31/08/2016

MINELLI DEUTSCHLAND GmbH

-

VIVARTE SERVICES

FR04619949

413157090

100 %

31/08/2017

VIVARTE SERVICES

41315709000015

SC DES SALINES

FR18267557

394253959

50 %

31/12/2012

SC DES SALINES

39425395900040

BESSON CHAUSSURES

FR00524156

304318454

100 %

31/08/2017

BESSON CHAUSSURES

30431845400499

SC LES BAS CHAMPS

FR18267555

394253710

50 %

31/12/2012

SC LES BAS CHAMPS

39425371000047

PARC DE COQUELLES

FR18271660

348281965

50 %

31/12/2016

PARC DE COQUELLES

34828196500056

LA HALLE

FR04617982

413151739

100 %

31/08/2014

LA HALLE

41315173900013

SNC FLANDRE SOISSONS

FR02571225

378913131

99.50 %

31/12/2016

SNC FLANDRE SOISSONS

37891313100025

2

SAN MARINA

FR01032527

321875205

100 %

31/08/2017

SAN MARINA

32187520500064

3

COSMOPARIS

FR15323242

352975056

99.80 %

31/08/2017

COSMOPARIS

35297505600339

VIVARTE MANAGEMENT SERVICES

FR05395900

424171759

100 %

31/08/2016

VIVARTE MANAGEMENT SERVICES

42417175900014

CAROLL INTERNATIONAL

FR11768920

582001707

99.99 %

31/08/2017

CAROLL INTERNATIONAL

58200170701699

EUROPEENNE DE NEGOCE ANDRE

FR02557653

378700819

100 %

31/08/2017

EUROPEENNE DE NEGOCE ANDRE

37870081900014

CIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE

FR04618927

413156795

100 %

31/08/2016

CIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE

41315679500010

BERYL

FR17643906

484190806

100 %

31/08/2017

BERYL

48419080601079

JOLICUIR

FR10354792

507492585

100 %

31/08/2017

JOLICUIR

50749258500017

2

VIVARTE HOLDING SUISSE SÀRL

CH01043852

142544

100 %

-

Vivarte Holding Suisse Sàrl

-

3

CAROLL INTERNATIONAL SUISSE SÀRL

CH01387057

4624480

100 %

-

CAROLL International Suisse Sàrl

-

FINANCIERE VIVARTE

FR10980284

514164979

100 %

31/08/2017

FINANCIERE VIVARTE

51416497900015

NNC SERVICES

FR10354777

507492460

100 %

31/08/2017

NNC SERVICES

50749246000021

HK BUYING OFFICE LIMITED

-

-

100 %

-

HK BUYING OFFICE LIMITED

-

LA HALLE AUX CHAUSSURES

FR06440311

439266826

Majority

-

LA HALLE AUX CHAUSSURES

43926682600015

Shareholders

 

VIVARTE

99.99

 

Undefined

0.01

 

Linkages

Rating Information

Company Name

Siren

Last Account Published

Turnover

CAROLL BELGIQUE SPRL

808605856

31/08/2016

11,155,223 €

 

 

Shareholder(s)

 

Name

VIVARTE

Name of representative

DOEBLIN JEAN JACQUES

Manager position

Administrator

Date of birth

02/10/1947

Place of birth

TREVES(ALLEMAGNE)

Type

Moral person

Name at birth

View Details

Name

VIVARTE SERVICES

Name of representative

HERVÉ STÉPHANIE

Manager position

Administrator

Date of birth

06/11/1980

Place of birth

CHÂTENAY-MALABRY

Type

Moral person

Name at birth

View Details

 

Director(s)

Name

Mme. LILIENFELD SANDRINE

Manager position

Chairman of the Board, Managing director

Date of birth

15/10/1964

Place of birth

ASNIÈRES-SUR-SEINE

Type

Individual

Name at birth

ROSENBERG

View Details

Statutory Auditor

Name

DELOITTE & ASSOCIES

Name of representative

Manager position

Statutory auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

 

Previous Directors

 

View the directors history for this company
If you want to view the directors history, please click on the link view details.

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

Chairman of the Board

M. APARISI JOSÉ ANTOINE

11/05/1960 - LYON (69006)

View Details

Chairman of the Board

M. APARISI JOSÉ ANTOINE

11/05/1960 - LYON (69006)

View Details

Chairman of the Board

Mme. BARRACHINA MARTINE

10/05/1960 - PITHIVIERS (45300)

View Details

Chairman of the Board

Mme. COLIN SYLVIE

30/07/1964 - GUÉRET (23000)

View Details

Chairman of the Board

Mme. COLIN SYLVIE

30/07/1964 - GUÉRET (23000)

View Details

Chairman of the Board

M. JAUGEAS THIERRY

03/01/1959 - PARIS (75015)

View Details

Chairman of the Board

Mme. LILIENFELD SANDRINE

15/10/1964 - ASNIÈRES-SUR-SEINE

View Details

Chairman of the Board

M. TETI NICOLA

23/09/1955 - TORRICELLA PELIGNA(ITALIE)

View Details

Managing director

M. APARISI JOSÉ ANTOINE

11/05/1960 - LYON (69006)

View Details

Managing director

M. APARISI JOSÉ ANTOINE

11/05/1960 - LYON (69006)

View Details

Managing director

Mme. BARRACHINA MARTINE

10/05/1960 - PITHIVIERS (45300)

View Details

Managing director

Mme. COLIN SYLVIE

30/07/1964 - GUÉRET (23000)

View Details

Managing director

Mme. COLIN SYLVIE

30/07/1964 - GUÉRET (23000)

View Details

Managing director

M. JAUGEAS THIERRY

03/01/1959 - PARIS (75015)

View Details

Managing director

Mme. LILIENFELD SANDRINE

15/10/1964 - ASNIÈRES-SUR-SEINE

View Details

Managing director

M. TETI NICOLA

23/09/1955 - TORRICELLA PELIGNA(ITALIE)

View Details

Administrator

EUROPEENNE DE NEGOCE ANDRE OU E N A

-

View Details

Administrator

EUROPEENNE DE NEGOCE ANDRE OU E N A

25/10/1963 - PERPIGNAN 66000

View Details

Administrator

EUROPEENNE DE NEGOCE ANDRE OU E N A

25/10/1963 - PERPIGNAN 66000

View Details

Administrator

EUROPEENNE DE NEGOCE ANDRE OU E N A

18/08/1958 - CLÉDER 29233

View Details

Administrator

EUROPEENNE DE NEGOCE ANDRE OU E N A

18/08/1958 - CLÉDER 29233

View Details

Administrator

EUROPEENNE DE NEGOCE ANDRE OU E N A

16/04/1970 - GANGES 34190

View Details

Administrator

EUROPEENNE DE NEGOCE ANDRE OU E N A

16/04/1970 - GANGES 34190

View Details

Administrator

EUROPEENNE DE NEGOCE ANDRE OU E N A

02/02/1963 - MALO-LES-BAINS 59240

View Details

Administrator

EUROPEENNE DE NEGOCE ANDRE OU E N A

23/09/1955 - TORRICELLA PELIGNA(ITALIE)

View Details

Administrator

FINANCIERE AGORA

-

View Details

Administrator

VIVARTE

-

View Details

Administrator

VIVARTE (SA)

-

View Details

Administrator

VIVARTE (SA)

20/04/1969 - BELVÈS 24170

View Details

Administrator

VIVARTE (SA)

09/07/1972 - SAINT-MAURICE 94410

View Details

1 2 next

 

Status history

No Status History

Recent publications in Gazettes

Publication date

Gazette Name

Description

Hide

09/03/2018

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2826 - 582001707 RCS. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Adresse : 38 rue du Hameau 75015 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/08/2017.

Hide

04/03/2018

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1216 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS. Capital : 9931887.05 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

Hide

16/02/2018

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Les Echos


Date de décision : 22/12/2017
La société 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, CTRE COMMERCIAL ROSNY 2, LOT 235, 93110 ROSNY SOUS BOIS
Fait l'objet du départ de BEAS

Hide

26/07/2017

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

06 - ALPES-MARITIMES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

11 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Capital : 9931887.05 EUR. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 100000 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : vente d'équipement de la personne. Adresse : route de Fréjus, Centre Commercial Géant Local 3, 6210 Mandelieu.
Précédent propriétaire : BRUNO CHRISTINE BEAUMANOIR. 340 423 938 RCS Antibes.
Date de commencement de l’activité : 01/02/2017. Publication légale : Nice Matin du 17/07/2017. Oppositions : Au Mandataire Maître FARINELLI Roland 293 avenue Janvier Pasero 06210 MANDELIEU LA NAPOULE pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc. Descriptif : - acte reçu par Maître GERARD Vincent le 01/02/2017 enregistré à PARIS (75016) le 06/02/2017 bordereau 2017-96 case 1 vendeur : SA BRUNO CHRISTINE BEAUMANOIR dont le siège social est à CAGNES SUR MER (06800) 64 avenue de la Gare. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

Hide

26/07/2017

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

06 - ALPES-MARITIMES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

9 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Capital : 9931887.05 EUR. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 300000 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : vente d'équipement de la personne. Adresse : route de Fréjus, Centre Commercial Géant Local 4, 6210 Mandelieu la Napoule.
Précédent propriétaire : BRUNO CHRISTINE BEAUMANOIR. 340 423 938 RCS Antibes.
Date de commencement de l’activité : 01/02/2017. Publication légale : Nice Matin du 17/07/2017. Oppositions : Au Mandataire Maître FARINELLI Roland 293 avenue Janvier Pasero 06210 MANDELIEU LA NAPOULE pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc. Descriptif : - acte reçu par Maître GERARD Vincent le 01/02/2017 enregistré à Paris le 06/02/2017 bordereau 2017-96 case 1 vendeur : SA BRUNO CHRISTINE BEAUMANOIR dont le siège social est à CAGNES SUR MER (06800) 64 avenue de la Gare. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

Hide

17/07/2017

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Nice Matin / Edition de Nice


Date de décision : 01/02/2017
Cédant : 340423938 - BRUNO CHRISTINE BEAUMANOIR, PANTASHOP, BCB, 10 AVENUE ROBERT SOLEAU, 06600 ANTIBES
Cessionnaire : 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, CTRE COMMERCIAL ROSNY 2, LOT 235, 93110 ROSNY SOUS BOIS
Prix de vente : 400000 €

Hide

06/07/2017

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

L'Essor / Edition du Rhône


Date de décision : 22/06/2017
Cédant : 753827096 - SARL HD2B, CAROLL, 8 RUE DE LA BARRE, 69002 LYON 2EME
Cessionnaire : 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, CTRE COMMERCIAL ROSNY 2, LOT 235, 93110 ROSNY SOUS BOIS
Prix de vente : 400000 €

Hide

06/07/2017

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

69 - RHONE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

1182 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société Anonyme à Conseil d'Administration. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Origine du fonds : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 400000 EUR. Etablissement : Etablissement principal. Activité : Fonds de commerce de prêt à porter. Adresse : 8 rue de la Barre, 69002 Lyon.
Précédent propriétaire : SARL HD2B. 753 827 096 RCS Lyon.
Date de commencement de l’activité : 22/06/2017. Publication légale : L'Essor du Rhône du 30/06/2017. Oppositions : Me Jean-Philippe ANDRIOT , notaire, 40 rue du Président Edouard Herriot 69001 LYON. Descriptif : Selon acte authentique en date du 22/06/2017 Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L.141-12 du code de commerce. Commentaires : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation.

Hide

30/05/2017

JAL

End of rent-management

Le Régional


Date de décision : 22/06/2015
Bailleur : 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, CTRE COMMERCIAL ROSNY 2, LOT 235, 93110 ROSNY SOUS BOIS
Locataire gérant : Non renseignée

Hide

28/04/2017

Bodacc A

Extrait de jugement

75 - PARIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2137 - Date : 2017-04-11. Jugement d'homologation de l'accord. 582 001 707 RCS Paris.
CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Activité : Exploitation de toutes affaires industrielles et/ou commerciales. L'importation, l'exportation, la distribution, la location, l'achat, la vente de toutes marchandises et en particulier de tous articles de bonneterie et de vêtements confectionnés et d'une manière générale de tous articles textiles et de tous articles de prêt à porter et accessoires ainsi que de tous articles similaires ou complémentaires. L'acquisition, l'exploitation, la concession de toutes licences de marques, modèles, dessins, de brevets et le Franchissage de ces marques. Fabrication, importation, exportation, distribution, achat et vente de produits de parfumerie, de cosmétiques et d'hygiène, ainsi que de tous articles similaires ou complémentaires. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Complément de jugement : Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Hide

21/02/2017

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2053 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Barrachina, Martine, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Rosenberg, nom d'usage : Lilienfeld, Sandrine. Capital : 9931887.05 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

Hide

08/02/2017

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

7553 - 582001707 RCS. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Adresse : 38 rue du Hameau 75015 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/08/2016.

Hide

09/12/2016

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2632 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : modification de l'Administrateur VIVARTE représenté par , Doeblin Jean Jacques Adresse : 16 rue du Pont du Diable 3963 Crans Montana. Capital : 9931887.05 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le représentant permanent.

Hide

25/09/2016

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

31 - HAUTE-GARONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

188 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société Anonyme. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Origine du fonds : Etablissement complémentaire acquis par achat au prix stipulé de 774000 EUR. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : A titre principal : Vente de prêt à porter et d'accessoires s'y rapportant et à titre accessoire : Vente de chaussures, de maroquinerie et d'accessoires s'y rapportant. Adresse : Centre Commercial Labège 2., Zac de la Grande Borde, 31670 Labège.
Précédent propriétaire : KOOKAI. 399 292 994 RCS Toulouse.
Date de commencement de l’activité : 01/07/2016. Oppositions : A l'adresse du fonds vendu : Zac de la Grande Borde, Centre Commercial Labège 2, 31670 Labège. Descriptif : Acte sous seing priv¿ en date du 31.08.2016 enregistr¿ au SIE de Toulouse Sud le 12.09.2016 -Est Bordereau 2016/1.304- case 37 - ext 6947.Domicile du pr¿c¿dent propri¿taire : KOOKAI, 1 6/10 Boulevard Foch- 93800 Epinay sur Seine Les oppositions seront re¿ues dans les dix jours suivant la publication pr¿vue ¿ l'article L.141-12 du code de commerce. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

Hide

23/09/2016

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

78 - YVELINES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

1921 - 582 001 707 RCS Versailles. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Capital : 9931887.05 EUR. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 250000 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : prêt à porter et/ou chaussures, maroquinerie, sacs, bonneterie, bijouterie fantaisie et accessoires. Adresse : 37 rue de la Paroisse, 78000 Versailles.
Précédent propriétaire : SAD. 488 070 798 RCS Versailles.
Date de commencement de l’activité : 31/08/2016. Oppositions : Au Mandataire en l'étude de Maître JACHEET Hubert, notaire, 18 avenue de St Germain 78160 Marly le roi pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc. Descriptif : - acte du 31/08/2016 enregistr¿ au SIE PARIS 16¿me le 12/09/2016 bordereau 2016/858 case 2, d¿lai d'oppositions de 10 jours ¿ compter de la parution au bodacc, adresse du vendeur 37 rue de la Paroisse 78000 Versailles adresse de l'acqu¿reur 38 rue du Hameau 75015 Paris. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

Hide

06/09/2016

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1421 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : modification de l'Administrateur VIVARTE SERVICES représenté par , Hervé Stéphanie nom d'usage : Henriquez Adresse : 135 boulevard Diderot 75012 Paris. Capital : 9931887.05 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le représentant permanent.

Hide

28/08/2016

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

13 - BOUCHES-DU-RHONE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

74 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Capital : 993188707 EUR. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 385000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : vente de prêt à porter femmes et accessoires s'y rapportant et à titre accessoire maroquinerie, bijouterie fantaisie. Adresse : Lot 154, C. C les Terrasses du Port, 13002 Marseille.
Précédent propriétaire : ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON. 316 643 170 RCS Bobigny.
Date de commencement de l’activité : 14/03/2016. Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc. Descriptif : - assp du 29/07/2016, enregistr¿ au sie Marseille 2/3/14/15/16 ARDT bordereau N 2016 /420 CASE N 5 EXT 3123, le montant des droits d'enregistrement s'¿l¿ve 14560 euros, le d¿lai d'opposition est de 10 jours ¿ compter de la publication au BODACC : le siege de la societe (vendeur) est 38 rue du hameau 75015 PARIS. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

Hide

24/06/2016

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

76 - SEINE-MARITIME

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

1051 - 399 292 994 RCS Bobigny. KOOKAI. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 15778194 EUR. Adresse : 6 boulevard Foch, 93800 Epinay-sur-Seine.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 655000 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Vente de tout commerce. Adresse : 60 rue du Gros Horloge, et 1 rue Thouret, 76000 Rouen.
Précédent propriétaire : CAROLL INTERNATIONAL. 582 001 707 RCS Paris.
Date de commencement de l’activité : 01/02/2016. Oppositions : A L'adresse du fonds cédé. Descriptif : Acte sous seing privé du 25/05/2016 enregistré le 07/06/2016 au SIE de ROUEN EST bordereau n° 2016/830 case n°22 Siège de l'ancien propriétaire : 38 rue du Hameau - 75015 PARIS Siège du nouveau propriétaire : 6 boulevard Foch - 93800 EPINAY SUR SEINE Délai d'opposition : 10 jours à compter de la publicité au BODACC. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

Hide

07/06/2016

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1919 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : modification de l'Administrateur VIVARTE représenté par , Maquaire Stéphane Adresse : 8 rue de l'Est 92500 Rueil-Malmaison. Capital : 9931887.05 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le représentant permanent.

Hide

20/05/2016

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

06 - ALPES-MARITIMES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

53 - 582 001 707 RCS Nice. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Capital : 9931887.05 EUR. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 540000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : prêt à porter, maroquinerie, bonneterie, chaussures, bijouterie fantaisie et accessoires s'y Rappotrtant. Adresse : 2 rue Masséna, 6000 Nice.
Précédent propriétaire : KOOKAI. 399 292 994 RCS Bobigny.
Date de commencement de l’activité : 01/02/2016. Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc. Descriptif : - Enregistr¿ ¿ P¿le enregistrement de Nice le 15/04/2016 Bordereau 2016/905 case 26 - D¿lai pour les oppositions : 10 jours ¿ compter de la pr¿sente insertion au Bodacc. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

Hide

18/05/2016

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE

505 - 582 001 707 RCS Lille Métropole. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Capital : 9931887.05 EUR. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Origine du fonds : Achat au prix stipulé de 722000,00 euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Fonds de commerce de vente de vêtements, de confection, de chaussures, et tissus et leurs accessoires. Adresse : 10/12 rue de Béthune, 59800 Lille.
Précédent propriétaire : KOOKAI. 399 292 994 RCS Bobigny.
Date de commencement de l’activité : 08/02/2016. Oppositions : Caroll International 10/12 rue de Béthune 598000 Lille pour la validité. Descriptif : Suivant acte SSP en date du 13/04/2016, enregistr¿ le 21/04/2016 au SIE du Grand Lille Est, Bord 2016/643, Case 12, Ext 2400.Si¿ge social ancien propri¿taire : 45 avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers.Si¿ge social nouveau propri¿taire : 38 rue du Hameau 75015 Paris.Les oppositions seront re¿ues dans les 10 jours de la derni¿re en date des publications pr¿vues par la loi pour la correspondance et la validit¿. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

Hide

19/04/2016

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

84 - VAUCLUSE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

1549 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 435000 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : Achat vente diffusion de tous vétementss articles et accessoires se rapportant à l'habillement en général à l'exclusion de toutes autres utilisation et activités. Adresse : 17 rue de la republique, 84000 Avignon.
Précédent propriétaire : KOOKAI. 399 292 994 RCS Bobigny.
Date de commencement de l’activité : 16/03/2016. Oppositions : Les oppositions seront reçues dans les 10 jours suivant la publication prévue à l'art L141-12 du code de commerce au fonds cédé. Descriptif : acte SSP en date du 16.03.2016 enregistr¿ au SIE d'AVIGNON en date du 30.03.2016 bord n¿ 2016/206 adresse du c¿dant : 45 avenue victor hugo 93300 Auberviliers. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

Hide

27/03/2016

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

816 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Capital : 9931887.05 EUR. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 509000,00 euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : un fonds de commerce de vente de tous articles concernant l'équipement de la personne et notamment chaussures et/ou vêtements, prêt à porter/sportwear, maroquinerie, bonneterie, bijouterie fantaisie, accessoires. Adresse : 8 rue des Rosiers, 75004 Paris.
Précédent propriétaire : KOOKAI. 399 292 994 RCS Bobigny.
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Oppositions : Au fonds cédé 8 rue des Rosiers 75004 Paris pour la validité. Descriptif : Adresse de l'ancien propri¿taire : 45 avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers Date de l'acte : 24/02/16 Enregistr¿ le 03/03/2016 ¿ SIE Paris 3EME ARRONDISSEMENT Bordereau : 2016/129 Case : 3 Ext : 685 Les oppositions seront re¿ues dans les dix jours suivant la publication pr¿vue ¿ l'article L.141-12 du code de commerce. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

Hide

10/03/2016

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

27 - EURE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVREUX

140 - Réctificatif.
Parution avis précédent : BODACC A. Numéro de parution : . Date de parution : 28 février 2016. Numéro d’annonce : 160. Cet avis est annulé et remplacé par le suivant.
582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Capital : 9931887.05 EUR. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 180000 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : prêt a porter et accessoires - tous articles textiles et ce sous toutes formes de distribution que ce soit en tant que grossiste, détaillant, dépositaire etc.... Adresse : 6 rue Chartraine, 27000 Evreux.
Précédent propriétaire : C. D. C. A. 402 283 774 RCS Evreux.
Date de commencement de l’activité : 01/02/2016. Oppositions : Chez Maitre Yann LEGROS, notaire, 1, square albert 1er 27400 Louviers pour la validité. et pour la correspondance cabinet 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES 2 Bis rue Georges Charpak 76825 MONT ST AIGNAN CEDEX. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc. Descriptif : - sie d'evreux le 03/02/2016 bordereau 2016/226 case 1 d¿lai pour les oppositions 10 jours ¿ compter de la pr¿sente insertion au bodacc. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

Hide

29/02/2016

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

76 - SEINE-MARITIME

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

1305 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 670000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Commerce de prêt-à-porter homme, femme et enfant, chaussures, maroquinerie et accessoires s'y rapportant. Adresse : 29/31 rue des Carmes, 76000 Rouen.
Précédent propriétaire : KOOKAI. 399 292 994 RCS Bobigny.
Date de commencement de l’activité : 01/02/2016. Oppositions : A l'adresse du fonds vendu : 29/31 rue des Carmes - 76000 ROUEN. Descriptif : Acte sous seing priv¿ du 11/02/2016 enregistr¿ le 11/02/2016 au SIE de ROUEN EST bordereau n¿2016/205 Case n¿16 Si¿ge de l'ancien propri¿taire : 45 avenue Victor Hugo - 93300 AUBERVILLIERS Si¿ge du nouveau propri¿taire : 38 rue du Hameau - 75015 PARIS D¿lai d'opposition : 10 jours ¿ compter de la publicit¿ au BODACC. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

Hide

28/02/2016

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

27 - EURE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVREUX

160 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Capital : 9931887.05 EUR. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 180000 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : prêt a porter et accessoires - tous articles textiles et ce sous toutes formes de distribution que ce soit en tant que grossiste, détaillant, dépositaire etc.... Adresse : 6 rue Chartraine, 27000 Evreux.
Précédent propriétaire : C. D. C. A. 402 283 774 RCS Evreux.
Date de commencement de l’activité : 01/02/2016. Oppositions : Chez Maitre Yann LEGROS notaire 1 square albert 1er pour la validité et pour la correspondance cabinet 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES 2 Bis rue Georges Charpak 76825 MONT ST AIGNAN CEDEX. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc. Descriptif : - sie d'evreux le 03/02/2016 bordereau 2016/226 case 1 d¿lai pour les oppositions 10 jours ¿ compter de la pr¿sente insertion au bodacc. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

Hide

05/02/2016

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

8719 - 582001707 RCS. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Adresse : 38 rue du Hameau 75015 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/08/2015.

Hide

04/12/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

822 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur partant : EUROPEENNE DE NEGOCE ANDRE OU E N A. Capital : 9931887.05 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

Hide

17/11/2015

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Echos (Les) / Le Publicateur Légal - La Vie Judiciaire


Date de décision : 22/10/2015
La société 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, CAROLL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15
Fait l'objet du départ de EUROPEENNE DE NEGOCE ANDRE

Hide

15/11/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1068 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : modification de l'Administrateur VIVARTE représenté par , Simonin Richard Adresse : Piazza Roosevelt,3 40123 Bologne. Capital : 9931887.05 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le représentant permanent.

Hide

06/09/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

794 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Simonin, Richard, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Barrachina, Martine. Capital : 9931887.05 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

Hide

04/09/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

390 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Jaugeas, Thierry, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Simonin, Richard. Capital : 9931887.05 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

Hide

18/08/2015

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Echos (Les) / Le Publicateur Légal - La Vie Judiciaire


Date de décision : 09/07/2015
La société 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, CAROLL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15
Fait l'objet du départ de Monsieur Thierry JAUGEAS,
De Monsieur Richard SIMONIN,
De Monsieur Thierry JAUGEAS,
De Monsieur Richard SIMONIN

Hide

18/08/2015

JAL

Appointment of the social representative

Echos (Les) / Le Publicateur Légal - La Vie Judiciaire


Date de décision : 09/07/2015
Société faisant l'objet d'une nomination : 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, CAROLL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15
Nominé : Monsieur Richard SIMONIN, 410123 BOLOGNE
En la fonction de : Président Directeur Général
Nominé : Madame Martine BARRACHINA, 92160 ANTONY
En la fonction de : Président Directeur Général
Nominé : Monsieur Richard SIMONIN, 410123 BOLOGNE
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Madame Martine BARRACHINA, 92160 ANTONY
En la fonction de : Administrateur

Hide

22/07/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2887 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : modification de l'Administrateur VIVARTE représenté par , Levy Karine nom d'usage : Voirin Adresse : 92 avenue Schneider 92190 Meudon. Capital : 9931887.05 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent.

Hide

23/06/2015

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

844 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Capital : 9931887.05 EUR. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 2218000,00 euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Vente d'articles d'équipement de la personne et notamment chaussures et/ou vêtements, prêt-à-porter, maroquinerie, bonneterie, bijouterie fantaisie, accessoires articles de puériculture, landaus/poussettes. Enseigne : CAROLL. Adresse : 21 avenue des Ternes / 1 rue Montenotte, 75017 Paris.
Précédent propriétaire : KOOKAI. 399 292 994 RCS Paris.
A dater du : 06/01/1958. Date de commencement de l’activité : 22/05/2015. Publication légale : Le Publicateur Légal du 11/06/2015. Oppositions : à l'adresse du fonds vendu 21 avenue des Ternes / 1 rue Montenotte 75017 Paris 21 avenue des Ternes / 1 rue Montenotte 75017 Paris pour la validité et la correspondance. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale. Date d’effet : 22/05/2015.

Hide

11/06/2015

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Echos (Les) / Le Publicateur Légal - La Vie Judiciaire


Date de décision : 26/03/2015
Cédant : 399292994 - KOOKAI, KOOKAI, 45 AV VICTOR HUGO, 93300 AUBERVILLIERS
Cessionnaire : 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, CAROLL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15
Prix de vente : 2218000 €
Date d’effet : 16/02/2015

Hide

26/05/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

864 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : modification de l'Administrateur EUROPEENNE DE NEGOCE ANDRE OU E N A représenté par , Teti Nicola Adresse : Les Roux 38610 Venon. Capital : 9931887.05 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le représentant permanent.

Hide

15/05/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2836 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Aparisi, José Antoine, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Jaugeas, Thierry. Capital : 9931887.05 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

Hide

15/05/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

3075 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : modification de l'Administrateur VIVARTE (SA) représenté par , Audran Pascale nom d'usage : Abdelli Adresse : 61 rue Degeyter 93600 Aulnay-sous-Bois. Capital : 9931887.05 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le représentant permanent.

Hide

28/04/2015

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Echos (Les) / Le Publicateur Légal - La Vie Judiciaire


Date de décision : 31/03/2015
La société 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, CAROLL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15
Fait l'objet du départ de Monsieur Jose-Antoine APARISI, 28 Avenue de Flandre, 75019, PARIS 19,
De Monsieur Jose-Antoine APARISI, 28 Avenue de Flandre, 75019, PARIS 19,
De Monsieur Jose-Antoine APARISI, 28 Avenue de Flandre, 75019, PARIS 19

Hide

28/04/2015

JAL

Appointment of the social representative

Echos (Les) / Le Publicateur Légal - La Vie Judiciaire


Date de décision : 31/03/2015
Société faisant l'objet d'une nomination : 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, CAROLL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15
Nominé : Monsieur Thierry JAUGEAS, 75016 PARIS 16
En la fonction de : Président du Conseil d'Administration
Nominé : Monsieur Thierry JAUGEAS, 75016 PARIS 16
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Monsieur Thierry JAUGEAS, 75016 PARIS 16
En la fonction de : Directeur général

Hide

14/03/2015

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

5783 - 582001707 RCS. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Adresse : 38 rue du Hameau 75015 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/08/2014.

Hide

13/08/2014

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2757 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Capital : 9931887.05 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

Hide

24/07/2014

JAL

Modification of the share capital

Echos (Les) / Le Publicateur Légal - La Vie Judiciaire


Date de décision : 12/06/2014
La société : 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, CAROLL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15 a subi une augmentation de son capital social désormais de 9 931 887 €
Date d'effet : 27/06/2014

Hide

04/04/2014

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1171 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : modification de l'Administrateur EUROPEENNE DE NEGOCE ANDRE OU E N A représenté par , Hauw Matthieu Georges Denis Adresse : 7 rue Montauban 75015 Paris. Capital : 8513251 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le représentant permanent.

Hide

16/02/2014

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

979 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Teti, Nicola, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Aparisi, José Antoine. Capital : 8513251 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

Hide

30/01/2014

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1085 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Lelache, nom d'usage : Colin, Sylvie, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Teti, Nicola. Capital : 8513251 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

Hide

23/01/2014

JAL

Appointment of the social representative

Echos (Les) / Le Publicateur Légal - La Vie Judiciaire


Date de décision : 17/01/2014
Société faisant l'objet d'une nomination : 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, CAROLL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15
Nominé : Monsieur José-Antoine APARISI, 75019 PARIS 19
En la fonction de : Président du Conseil d'Administration
Nominé : Monsieur José-Antoine APARISI, 75019 PARIS 19
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Monsieur José-Antoine APARISI, 75019 PARIS 19
En la fonction de : Directeur général

Hide

23/01/2014

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Echos (Les) / Le Publicateur Légal - La Vie Judiciaire


Date de décision : 17/01/2014
La société 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, CAROLL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15
Fait l'objet du départ de Monsieur Nicola TETI,
De Monsieur Nicola TETI,
De Monsieur Nicola TETI

Hide

20/01/2014

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

8689 - 582001707 RCS. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Adresse : 38 rue du Hameau 75015 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/08/2012.

Hide

20/01/2014

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

8690 - 582001707 RCS. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Adresse : 38 rue du Hameau 75015 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/08/2013.

Hide

28/12/2013

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Affiches parisiennes (Les)


Date de décision : 20/12/2013
La société 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, CAROLL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15
Fait l'objet du départ de Madame Sylvie COLIN, 28 Avenue de Flandre, 75019, PARIS 19,
De Madame Sylvie COLIN, 28 Avenue de Flandre, 75019, PARIS 19,
De Madame Sylvie COLIN, 28 Avenue de Flandre, 75019, PARIS 19

Hide

28/12/2013

JAL

Appointment of the social representative

Affiches parisiennes (Les)


Date de décision : 20/12/2013
Société faisant l'objet d'une nomination : 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, CAROLL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15
Nominé : Monsieur Nicola TETI, 38610 VENON
En la fonction de : Président du Conseil d'Administration
Nominé : Monsieur Nicola TETI, 38610 VENON
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Monsieur Nicola TETI, 38610 VENON
En la fonction de : Directeur général

Hide

24/03/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

461 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : modification de l'Administrateur VIVARTE SERVICES représenté par , Jaylac Diane Anne Adresse : 34 boulevard Victor Hugo 92200 Neuilly sur Seine. Capital : 8513251 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le représentant permanent.

Hide

21/03/2013

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

74 - HAUTE-SAVOIE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS

690 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Capital : 8513251 EUR. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris 15.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 280000 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : prêt à porter pour femme. Adresse : 2 avenue Pasteur, 74100 Annemasse.
Précédent propriétaire : SANTI (Alain). RCS non inscrit. Précédent propriétaire : LYARDET (Gisèle, Anne-Marie). Nom d’usage : SANTI. RCS non inscrit.
Date de commencement de l’activité : 01/02/2013. Oppositions : Me Bersot Cécile -2, rue du Petit Malbrande - 74100 Annemasse. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

Hide

10/03/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1362 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : modification de l'Administrateur VIVARTE (SA) représenté par , Makarian Véronique nom d'usage : Croce Adresse : 12 rue Popincourt 75011 Paris. Capital : 8513251 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur le représentant permanent.

Hide

22/02/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Eco des Pays de Savoie (L')


Date de décision : 08/02/2013
Cédant : 305651978 - MONSIEUR ALAIN SANTI, CONTACT LINE, 9 RUE DES ARTS, 74200 THONON LES BAINS
Cessionnaire : 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15
Prix de vente : 280000 €
Date d’effet : 01/02/2013

Hide

22/02/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Eco des Pays de Savoie (L')


Date de décision : 08/02/2013
Cédant : 305651978 - MONSIEUR ALAIN SANTI, CONTACT LINE, 9 RUE DES ARTS, 74200 THONON LES BAINS
Cessionnaire : 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15
Prix de vente : 280000 €
Date d’effet : 01/02/2013

Hide

08/12/2012

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

11752 - 582001707 RCS. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Adresse : 38 rue du Hameau 75015 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/08/2011.

Hide

03/07/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

567 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Capital : 8513251 EUR. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Oppositions : Article L.236-14 du code de commerce. Descriptif : Pour la soci¿t¿ absorb¿e: La soci¿t¿ CAROLL RENNES, SAS au capital de 62.000 EUR, dont le si¿ge social est sis 38 rue du Hameau, 75015 Paris, immatricul¿e sous le num¿ro 349 705 566 RCS Paris Aux termes d'un acte SSP en date ¿ Paris du 25/6/2012, il a ¿t¿ ¿tabli le projet de fusion par voie d'absorption de la soci¿t¿ CAROLL RENNES par la soci¿t¿ CAROLL INTERNATIONAL, ¿tabli sur les comptes arr¿t¿s au 31/12/2011. actif : 160.180 EUR passif : 44.426 EUR actif net apport¿ : 115.754 EUR Il est pr¿cis¿ que la pr¿sente Fusion aura un effet r¿troactif au 1er/1/2012. Le montant pr¿vu de la prime de fusion pour chaque soci¿t¿ participante : n¿ant La soci¿t¿ CAROLL INTERNATIONAL ¿tant propri¿taire de la totalit¿ des actions de la soci¿t¿ CAROLL RENNES, il n'a pas ¿t¿ ¿tabli de rapport d'¿change et il ne sera proc¿d¿ ¿ aucune augmentation de capital. La date du projet commun de fusion ou de scission : 25/6/2012 Les date et lieu du d¿p¿t au RCS au titre de chaque soci¿t¿ participante: le 26/6/2012 au RCS de Paris. Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

Hide

03/07/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

569 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Capital : 8513251 EUR. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Oppositions : Article L.236-14 du code de commerce. Descriptif : Pour la soci¿t¿ absorb¿e: La soci¿t¿ CAROLL COURCELLES, SAS au capital de 7.622,45 EUR, dont le si¿ge social est sis 38 rue du Hameau, 75015 Paris, immatricul¿e sous le num¿ro 393 836 796 RCS Paris Aux termes d'un acte SSP en date ¿ Paris du 25/6/2012, il a ¿t¿ ¿tabli le projet de fusion par voie d'absorption de la soci¿t¿ CAROLL COURCELLES par la soci¿t¿ CAROLL INTERNATIONAL, ¿tabli sur les comptes arr¿t¿s au 31/8/2011. actif : 222.099 EUR passif : 57.420 EUR actif net apport¿ : 164.679 EUR Il est pr¿cis¿ que la pr¿sente Fusion aura un effet r¿troactif au 1er/9/2011. Le montant pr¿vu de la prime de fusion pour chaque soci¿t¿ participante : n¿ant La soci¿t¿ CAROLL INTERNATIONAL ¿tant propri¿taire de la totalit¿ des actions de la soci¿t¿ CAROLL COURCELLES, il n'a pas ¿t¿ ¿tabli de rapport d'¿change et il ne sera proc¿d¿ ¿ aucune augmentation de capital. La date du projet commun de fusion ou de scission : 25/6/2012 Les date et lieu du d¿p¿t au RCS au titre de chaque soci¿t¿ participante: le 26/6/2012 au RCS de Paris. Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

Hide

05/03/2012

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

12127 - 582001707 RCS. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Adresse : 38 rue du Hameau 75015 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/08/2010.

Hide

06/12/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

56 - MORBIHAN

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

1214 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Capital : 8513251 EUR. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris 15.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 301662,48 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Un fonds de commerce de confection et de vêtements (équipement de la personne) et accessoires s'y rapportant. Adresse : 3 rue du Port, 56100 Lorient.
Précédent propriétaire : NANOUCHA. 325 203 511 RCS Quimper.
Date de commencement de l’activité : 04/11/2011. Publication légale : Ouest-France du 19/11/2011. Oppositions : Etude de Maître Loïc BRISSET - 25, place Jules Ferry - 56100 Lorient. Descriptif : . Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

Hide

19/11/2011

JAL

Activity or goodwill cession

Ouest France/Edition du Morbihan


Date de décision : 04/11/2011
Cédant : 325203511 - NANOUCHA, 10 RUE FEUNTEUNIC AR LEZ, 29000 QUIMPER
Cessionnaire : 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15
Prix de vente : 301662 €
Date d’effet : 04/11/2011

Hide

30/06/2011

JAL

Proposed merger

Affiches parisiennes (Les)


Date de décision : 21/06/2011
Absorbant : 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15
Absorbé : 499590610 - FLORE, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15

Hide

20/05/2011

JAL

Activity or goodwill cession

Echos Judiciaires Girondins (Les)


Date de décision : 03/05/2011
Cédant : 484638598 - SARL JAMET, 302 BD DE LA PLAGE, 33120 ARCACHON
Cessionnaire : 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15
Prix de vente : 150000 €
Date d’effet : 31/03/2011

Hide

28/01/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1154 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Cottet, Alain, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Lelache, nom d'usage : Colin, Sylvie. Capital : 8513251 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

Hide

02/01/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

693 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : nomination de l'Administrateur : VIVARTE SERVICES représentée par NOUVION, Christian, Adresse : Cours de l'Ours 95 rue du Fg Saint Antoine 75011 Paris. Capital : 8513251 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

Hide

31/12/2010

JAL

Appointment of the social representative

Affiches parisiennes (Les)


Société faisant l'objet d'une nomination : 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15
Nominé : Madame Sylvie COLIN
En la fonction de : Président du Conseil d'Administration
Nominé : Madame Sylvie COLIN
En la fonction de : Directeur général
Date d'effet : 17/12/2010

Hide

13/12/2010

JAL

Appointment of the social representative

Affiches parisiennes (Les)


Société faisant l'objet d'une nomination : 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15
Nominé :
En la fonction de : Administrateur
Date d'effet : 08/11/2010

Hide

13/12/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

10080 - 582001707 RCS. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Adresse : 38 R DU HAMEAU 75015 PARIS. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/08/2009.

Hide

08/08/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

556 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur partant : FINANCIERE AGORA représentée par NOUVION, CHRISTIAN, Adresse : Demeurant : 28 avenue de Flandre 75019 Paris. Capital : 8513251 EUR. Activité : .
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

Hide

07/07/2010

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Date de décision : 18/06/2010
La société 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15
Fait l'objet du départ de La société FINANCIERE AGORA

Hide

21/12/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

9872 - 582001707 RCS. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Adresse : 38 R DU HAMEAU 75015 PARIS. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/08/2008.

Hide

10/12/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1406 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Administration : nomination du Directeur général délègué : Lelache, nom d'usage : Colin, Sylvie. Capital : 8513251 EUR.
Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

Hide

20/11/2009

JAL

Appointment of the social representative

AFFICHES PARISIENNES ET DEPARTEMENTALES


Société faisant objet d'une nomination : 582001707 - CAROLL INTERNATIONAL, 38 RUE DU HAMEAU, 75015 PARIS 15
Nominé : Madame Sylvie COLIN, 28 AVENUE 28 AVENUE DE FLANDRE, 75019 PARIS
En la fonction de : Directeur général délégué

Hide

06/03/2009

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

45 - LOIRET

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

284 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris 15.
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 675000 Euros. Etablissement : Établissement secondaire. Activité : confection vêtements et accessoires. Adresse : 322-324 et 326 rue de Bourgogne, 45000 Orléans.
Précédent propriétaire : UNIC PANTALON. 085 581 395 RCS Orléans.
Date de commencement de l’activité : 01/02/2009. Publication légale : Le Journal de Gien du 19/02/2009. Oppositions : Marceau Conseil -8, rue de la République - 45000 Orléans. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

Hide

01/02/2009

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

68 - HAUT-RHIN

GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR

912 - 582 001 707 RCS Paris. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 8513251 EUR. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Origine du fonds : fonds secondaire acquis par achat au prix stipulé de 316 000 euros. Activité : confection, vêtements et accessoires s'y rapportant. Adresse : Galerie Marchande « Saint-Martin » faisant partie d'un d'immeubles reliant la rue des Serruriers et la rue Saint-Nicolas, 68000 Colmar.
Précédent propriétaire : SF EXPANSION. RCS non inscrit.
Date de commencement de l’activité : 23/12/2008. Publication légale : Le Journal des Ménagères du 04/01/2009. Oppositions : étude de KEMPF-BERTRAND (Christine), notaire, 7, rue des Boulangers, 68000 Colmar. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

Hide

20/11/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

8409 - 582001707 RCS. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Adresse : 38 rue du Hameau 75015 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/08/2007.

Hide

29/02/2008

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

83 - VAR

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON

3039 - 582 001 707 RCS Toulon. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : Société anonyme. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce. Etablissement : Etablissemennt complémentaire. Activité : achat, vente d'articles bonneterie, vêtements confectionnés, Pap et accessoires, produits de parfumerie. Adresse : Centre Commercial Grand Var, Local N° 23, 83160 la Valette-du-Var.
Précédent propriétaire : D2J. RCS non inscrit.
Date de commencement de l’activité : 26/10/2007. Publication légale : La marseillaise du 03/10/2007. Oppositions : Au Mandataire Me Michel Boyer 60 Rue Jean Jaurès 83000 TOULON pour la validité et pour la correspondance Me Michel Boyer 60 rue Jean Jaurès 83000 TOULON. Descriptif : Etablissement secondaire/complémentaire acquis par achat au prix stipulé de 710000 Euros. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

Hide

15/02/2008

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

53 - MAYENNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL

1310 - 381 389 170 RCS Laval. SOCIETE CORBEL. Forme : Société à responsabilité limitée. Adresse : 17 rue Croix Belle Porte, 2100 Saint-Quentin.
Origine du fonds : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 50000 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Vente au détail de prêt à porter. Enseigne : CAROLL. Adresse : 14 et 16 rue de la Paix, 53000 Laval.
Précédent propriétaire : CAROLL INTERNATIONAL. 582 001 707 RCS Paris.
Date de commencement de l’activité : 05/10/2007. Publication légale : L'OUEST FRANCE du 22/11/2007. Oppositions : Cabinet de Maître RIGOT - Avocat rue Albert Einstein - Bâtiment L Parc Technopolis 53000 Laval. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

Hide

27/12/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

8626 - 582 001 707. RCS Paris CAROLL INTERNATIONAL. Forme: Société anonyme. Adresse du siège social: 38 rue du Hameau 75015 Paris. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 août 2006.

Hide

25/12/2007

Bodacc A

Vente et cession

223 - RCS Saint-Quentin 381 389 170. SOCIETE CORBEL. Forme : S.A.R.L. Capital : 25 000 euros. Adresse du siège social : 17 rue Croix-Belle-Porte, 02100 Saint-Quentin. Etablissement principal - Enseigne : Caroll. Activité : vente au détail de prêt-à-porter. Adresse : 14-16 rue de la Paix, 53000 Laval. Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 50 000 euros. Date de début d'activité : 5 octobre 2007. Précédent propriétaire : S.A. CAROLL INTERNATIONAL. RCS Paris 582 001 707. Publication légale : Ouest France du 22 novembre 2007. Oppositions : Cabinet de Me Rigot, avocat, parc Technopolis, bâtiment L, rue Albert-Einstein, Change, B.P. 70632, 53006 Laval Cedex.

Hide

11/11/2007

Bodacc A

Vente et cession

783 - RCS Paris B 582 001 707. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 8 513 251 euros. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris. Administration : P.D.G. : COTTE (Alain). Etablissement secondaire - Activité : vente de vêtements, de prêt-à-porter féminin et d'accessoires s'y rapportant. Adresse : centre commercial Auchan, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 341 012 euros. Date de début d'activité : 1er octobre 2007. Précédent propriétaire : SOCADEX S.A.R.L. RCS Le Mans B 379 061 740. Publication légale : L'Informateur judiciaire du 26 octobre 2006. Oppositions : au fonds, pour la validité, centre commercial Auchan, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire et Etude de Me Glaud (Christophe), 52 boulevard des Pas-Enchantés, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, pour la correspondance.

Hide

26/10/2007

Bodacc A

Vente et cession

1076 - RCS B 582 001 707. RC 95-B 583. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris. Etablissement secondaire - Activité : achat et vente d'articles de bonneterie, vêtements confectionnés, prêt à porter et accessoires, produits de parfumerie. Adresse : 4 rue Gambetta et 3 rue Mazagran, 64200 Biarritz. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 285 000 euros. Date d'effet : 1er février 2007. Précédent propriétaire : DA.BE.OL.PA. S.A.R.L.. RCS B 403 688 526. Publication légale : Les Petites Affiches Béarnaises des Pyrénées-Atlantiques du 13 février 2007. Oppositions : Me Lacaze (Benoît), 20 rue Victor-Hugo, 64200 Biarritz.

Hide

25/10/2007

Bodacc A

Vente et cession

1098 - RCS Toulon B 582 001 707. RC AP-B 41231. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 8 513 251 euros. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris. Etablissement principal - Activité : vente de prêt-à-porter pour hommes et femmes, d'accessoires s'y rapportant à titre accessoire, vente de tout produit diffusé par la marque > New Man < . Adresse : centre commercial Grand-Var, 83160 La Valette-du-Var. Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 710 000 euros. Date d'effet : 18 septembre 2007. Précédent propriétaire : D2J. RCS 313 413 908. Publication légale : Marseillaise du 3 octobre 2007. Oppositions : Me Boyer (Michel), 60 rue Jean-Jaurès, 83000 Toulon, pour la validité et la correspondance.

Hide

25/10/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

2153 - RCS Paris B 582 001 707. RC 58-B 170. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 8 513 251 euros. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau,, 75015 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président du conseil d'administration et directeur général partant : RUBINI (Marie, José). Nomination du président du conseil d'administration et directeur général : COTTET (Alain).

Hide

14/06/2007

Bodacc A

Vente et cession

0816 - RCS 582 001 707. A dater du : 17 février 2002. RC 02-B 00698. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. à conseil d'administration. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris. Etablissement secondaire - Activité : achat, vente de tous articles de bonneterie, de vêtements confectionnés, de prêt-à-porter, d'accessoires et de tous produits de parfumerie. Adresse : 6 rue Félix-Poulat, 38000 Grenoble. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 1 300 000 euros. Date d'effet : 3 janvier 2005. Précédent propriétaire : BEAUTE ESTHETIQUE. RCS Grenoble 311 233 472. Publication légale : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 12 janvier 2007. Oppositions : S.C.P. Mollet et Petiot, 641 avenue de Stalingrad, 38340 Voreppe.

Hide

14/03/2007

Bodacc A

Vente et cession

1317 - RCS Paris B 582 001 707. A dater du : 22 février 2007. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris. Etablissement principal - Activité : prêt-à-porter, vêtements pour femmes et accessoires. Adresse : 4 rue Gambetta et 3 rue Mazagran, 64200 Biarritz. Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 285 000 euros. Date de début d'activité : 31 janvier 2007. Précédent propriétaire exploitant : DA.BE.OL.PA. RCS Bayonne 403 688 526. Publication légale : Les Petites affiches béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques du 13 février 2007. Oppositions : Me Lacaze (Benoît), notaire, 20 avenue Victor-Hugo, 64200 Biarritz.

Hide

15/10/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

3143 - RCS Paris B 582 001 707. RC 58-B 170. CAROLL INTERNATIONAL. Forme: S.A. Adresse du siège social: 38, R du Hameau,Paris, 75015 Paris. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 août 2005.

Hide

11/06/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1565 - RCS Paris B 582 001 707. RC 58-B 170. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 8 513 251 euros. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau,, 75015 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU S.A. Commissaire aux comptes suppléant partant : VASSOR (Philippe). Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : BEAS.

Hide

18/03/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

4972 - RCS Paris B 582 001 707. RC 58-B 170. CAROLL INTERNATIONAL. Forme: S.A. Adresse du siège social: 38, R du Hameau,75015 Paris. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 août 2004.

Hide

09/04/2004

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 582001707 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 8 513 251 euros. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : droit au bail. Adresse : 21-23 rue de l' Etape, 51100 Reims Droit au bail acquis par achat au prix stipulé de 360 000 euros. Date d'effet : 27 février 2004 Précédents propriétaires ROGER Gilbert ROGER Jean-Michel. RCS Reims A 378744569 Publication légale: Les Petites affiches Matot-Braine du 10 mars 2004. Oppositions : M e Ponce, notaire associé, 5 boulevard Déseubeau, 51100 Reims.

Hide

06/01/2004

Bodacc A

Vente et cession

RCS non encore inscrit. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 8 513 251 euros. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente de pret-à-porter et d'accessoires de mode masculins ou féminins. Adresse : 1 rue Royale, 74000 Annecy Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 1 219 592 euros Date de début d'activité: 1 e r décembre 2003. Précédent propriétaire : ARMAND THIERY S.A.S. RCS Nanterre 380622332 Publication légale: Eco des Pays de Savoie du 12 décembre 2003. Oppositions : M e Naz (Jean-Marc), 43 rue Vaugelas, 74000 Annecy et M e Vincent Gérard, 29 avenue Georges- Mandel, 75016 Paris, pour la correspondance.

Hide

22/05/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 582001707 RC 58-B 170 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification du président du conseil d' administration et directeur général : RUBINI (Marie-José).

Hide

29/04/2003

Bodacc A

Création d'établissement

RCS 582001707 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 8 513 251 euros. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente au détail d' articles de pret-à-porter, de vetements et d'accessoires. Adresse : 21 rue du Moulin, 14000 Caen Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 434 479,70 euros Date de début d'activité: 1 e r février 2003. Précédent propriétaire : B.L. RCS Caen 413152646 Publication légale: Ouest France du 17 février 2003. Oppositions : S.C.P. B. Helleboid V. Helleboid P. Meuleman et R. Bekaert, 6 rue Guillaume- le-Conquérant, B.P. 160, 14010 Caen.

Hide

21/03/2003

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 582001707 A dater du: 21 octobre 2002 RC 02-B 1089 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. à conseil d'administration. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, Paris 75015 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente au détail de pret-à-porter pour hommes, femmes et enfants, chaussures, maroquinerie et accessoires. Adresse : centre commercial Colombia, lots n° s 20 et 4319, 40 place du Colombir, 35000 Rennes Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 564 061,36 euros Date de début d'activité: 5 octobre 1957. Date d'effet : 10 mars 2003. Précédent propriétaire : MAGGIE MAY. RCS B 328705157 Publication légale: Le Pays malouin du 31 octobre 2002. Oppositions : S.C.P. Depasse et Godefroy, 10 rue de la Santé, 35000 Rennes.

Hide

20/12/2002

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 582001707 RC 02-B 246 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente au détail de pret-à-porter pour hommes, femmes ou enfants, de chaussures, d'articles de maroquinerie et d'accessoires. Adresse : centre commercial de la Madeleine, 35400 Saint- Malo Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 280 506,19 F Date de début d'activité: 1 e r avril 2002. Précédent propriétaire : SOCIETE PAULINE. RCS B 410146468 Publication légale: Le Pays malouin du 11 avril 2002. Oppositions : M e s Vogel et Gautron, notaires associés, 10 boulevard Porée, 35400 Saint-Malo.

Hide

19/12/2002

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 582001707 RC 02-B 651 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente au détail de pret-à-porter pour hommes, femmes, enfants, de chaussures, de maroquinerie et d'accessoires. Adresse : 76-78 rue du Bourg, 21000 Dijon Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 457 347,05 euros Date de début d'activité: 3 septembre 2002. Précédent propriétaire : E. U.R.L. MOD DESIGN DIJON. RCS 342367182 Publication légale: Les Terres de Bourgogne du 27 septembre 2002. Oppositions : M e Prieur, notaire associé, 5 avenue Garibaldi, 21000 Dijon.

Hide

18/12/2002

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 582001707 RC 02-B 393 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris. Administration : président du conseil d'administration : RUBINI ( Marie, José) ( Nom d'usage : RUBINI) ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente au détail de pret-à-porter pour hommes, femmes et enfants, de chaussures, de maroquinerie et d' accessoires. Adresse : 79 rue Bernardin- de-Saint-Pierre, 76600 Le Havre Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 97 567,37 euros Date de début d'activité: 22 avril 2002. Précédent propriétaire : MALDIVES. RCS B 383173028 Publication légale: L'Union agricole du 25 avril 2002 et rectificatif du 21 novembre 2002. Oppositions : Cabinet Juri Consult, 22 place Albert-René, 76600 Le Havre.

Hide

28/11/2002

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 582001707 A dater du: 16 septembre 1994 RC 94-B 291 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. à conseil d' administration. Adresse du siège social : 166 rue du Landy, 93200 Saint-Denis ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente de pret-à-porter pour hommes, femmes ou enfants, de chaussures, de maroquinerie et d'accessoires. Adresse : 41 rue des Trois-Cailloux, 80000 Amiens Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 304 898,03 euros Date de début d'activité: 26 juillet 1990. Date d'effet : 1 e r avril 2002. Précédent propriétaire : S.A.R.L. PAULINE. RCS B 410146468 Publication légale: Picardie-la gazette du 10 avril 2002. Oppositions : Office notarial, 26 rue de Noyon, 80000 Amiens.

Hide

27/11/2002

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 582001707 A dater du: 21 octobre 2002 RC 02-B 1089 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. à conseil d'administration. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente au détail de pret-à-porter pour hommes, femmes ou enfants, de chaussures, de maroquinerie et d'accessoires. Adresse : centre commercial Rallye, Grang-quartier, 35760 Saint-Grégoire Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 518 326,66 euros Date de début d'activité: 5 octobre 1957. Date d'effet : 1 e r avril 2002. Précédent propriétaire : S.A.R.L. PAULINE. RCS B 410146468 Publication légale: Le Pays malouin du 11 avril 2002. Oppositions : S. C.P. Bitouze le Moux Mallevre, 11 rue Rallier-du-Baty, 35000 Rennes.

Hide

26/11/2002

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 582001707 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 8 513 251 euros. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente de vetements, de pret-à-porter féminin et d'accessoires. Adresse : centre commercial Colombia, locaux n° s 20 et 4319, 40 place du Colombier, 35000 Rennes Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 564 061,36 euros. Date d'effet : 15 octobre 2002. Précédent propriétaire : MAGGIE MAY. RCS Rennes B 328705157 Publication légale: Le Pays Malouin du 31 octobre 2002. Oppositions : S.C.P. Dépasse et Godefroy, huissiers de justice, 10 rue de la Santé, 35000 Rennes et pour la correspondance, Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats, 11 place Dauphine, 75053 Paris Louvre R.P.-S.P.

Hide

10/10/2002

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 582001707 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 8 513 251 euros. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris Etablissement Complémentaire. Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente de pret-à-porter, de chaussures et d'accessoires. Adresse : 76-78 rue du Bourg, 21000 Dijon Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 457 347,05 euros. Date d'effet : 2 septembre 2002. Précédent propriétaire : MOD DESIGN DIJON. RCS Dijon B 342367182 RC 87-B 387 Publication légale: Les Terres de Bourgogne du 27 septembre 2002. Oppositions : M e Prieur, notaire associé, 5 avenue Garibaldi, 21000 Dijon.

Hide

16/04/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 582001707 RC 58-B 170 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification d'un administrateur : VIVARTE.

Hide

07/03/2002

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 582001707 RC AP-B 661 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 8 513 251 euros. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris Etablissement principal: Adresse : centre commercial Auchan, 78370 Plaisir Droit au bail acquis par cession au prix stipulé de 144 826,57 euros. Date d'effet : 1 e r février 2002. Précédent propriétaire : DYNASTIE. RCS 352617252 Publication légale: La Croix du 15 février 2002. Oppositions : M e Huber, 17 rue Hoche, 78000 Versailles pour la validité et pour la correspondance.

Hide

15/02/2002

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Bordeaux B 398330357 RC AP-B 35 C.L. DISTRIBUTION. Forme : S.A.S. Capital : 3 600 000 euros. Adresse du siège social : quai Vergy, 70100 Gray Etablissement principal: Activité : pret-à-porter féminin. Adresse : Centre commercial Rives-d'Arcins, lot n° 14, 33324 Bègles Cedex Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 259 163,33 euros. Date d'effet : 31 décembre 2001. Précédent propriétaire : CAROLL INTERNATIONAL. RCS 582001707 Publication légale: Les Echos judiciaires girondins du 8 janvier 2002. Oppositions : mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, pour la validité et pour la correspondance, M e Yaigre, 14 rue de Grassi 33000 Bordeaux.

Hide

14/02/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 582001707 RC 58-B 170 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification du président du conseil d' administration : RUBINI (Marie, José).

Hide

22/04/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 582001707 RC 58-B 170 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 8 513 251 euros. Commentaires : modification survenue sur le capital ( augmentation) et l'administration. Administration : commissaire aux comptes titulaire partant : STE K.P.M.G. AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant partant : RIVIERE (Gérard).

Hide

25/01/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 582001707 RC 58-B 170 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateurs partants : VANNER, née SEYER (Francine, Anny) CARDON ( Philippe, André, François).

Hide

27/12/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Epernay B 582001707 RC 94-B 112 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. à conseil d'administration. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.

Hide

30/09/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 582001707 RC 58-B 170 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président du conseil d'administration partant : PEIS (Yves). Nomination du président du conseil d'administration : MEULLE, née RUBINI (Marie-José). Modification d'un administrateur : GROUPE ANDRE S.A. Nomination d' administrateurs : FINANCIERE AGORA EUROPEENNE DE NEGOCE ANDRE-E.N.A. S.A. Nomination du commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU S. A. Nomination du commissaire aux comptes suppléant : VASSOR (Philippe).

Hide

10/09/2000

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 421784240 RC 00-B 14256 S.A.R.L. M.K. DISTRIBUTION. Forme : S.A.R.L Nom commercial: Mary Kimberley. Adresse du siège social : 36 rue du Général-de- Gaulle, 95880 Enghien Etablissement principal: Activité : vente au détail de pret-à-porter féminin. Adresse : 26 rue Saint-Placide, 75006 Paris Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 800 000 F Date de début d'activité: 23 mai 2000. Précédent propriétaire : CAROLL INTERNATIONAL. RCS B 582001707 Publication légale: Journal spécial des sociétés françaises par actions du 7 juin 2000. Oppositions : M e Normand ( Jean-Michel), 29 avenue Georges-Mandel, 75016 Paris.

Hide

10/08/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

*. RCS Bobigny B 582 001 707 RC 90-B 2245 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : 166, rue du Landy 93200 Saint-Denis Date de radiation: 26 juillet 2000.

Hide

27/06/2000

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Metz B 431 301 100 A dater du: 9 mai 2000 RC 2000-B 353 FERLUX. Forme : S. A.R.L. Capital : 8 000 euros (fixe). Adresse du siège social : 46 en Chaplerue, 57000 Metz. Administration : gérante : Mme MAIA (Paulina), nom d' usage : FERNADES Fonds principal acquis par achat, au prix stipulé de 500 000 F Etablissement principal: Activité : pret- à-porter femmes, hommes, enfants, lingerie fine, chaussures, accessoires, bijoux fantaisie, et tout ce qui concerne l'habillement de la personne en général. Adresse : 46 en Chaplerue, 57000 Metz. Date d'effet : 18 mars 2000 Précédente propriétaire CAROLL INTERNATIONAL. RCS B 582 001 707 RC 96-B 325 Publication légale: Les Affiches Moniteur des Soumissions du 28 mars 2000. Oppositions : S.C.P. Doyen et Mourer, 11 rue Chatillon, 57000 Metz.

Hide

21/05/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 582001707 RC 58-B 170 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : 38 rue du Hameau, 75015 Paris. Commentaires : modification survenue sur l'adresse du siège social et l'adresse de l'établissement principal Etablissement principal: Adresse : 38 rue du Hameau, 75015 Paris.

Hide

04/05/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

*. RCS Paris B 582 001 707 RC 58-B 170 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : 30, rue de Cambrai 75019 Paris Date de radiation: 18 avril 2000.

Hide

25/04/2000

Bodacc A

Vente et cession

RCS non encore inscrite. FERLUX. Forme : S.A.R.L. Capital : 8 000 euros. Adresse du siège social : 46 En Chaplerue, 57000 Metz Fonds principal acquis par achat, au prix stipulé de 500 000 F Etablissement principal: Activité : pret- à-porter. Adresse : 46 En Chaplerue, angle, 31 rue de la Chèvre, 57000 Metz. Date d'effet : 18 mars 2000 Précédente propriétaire CAROLL INTERNATIONAL. RCS Paris B 582 001 707 RC 96-B 325 Publication légale: Les Affiches Moniteur des Soumissions du 28 mars 2000. Oppositions : Mes Doyen et Mourer, 11 rue Chatillon, 57000 Metz.

Hide

09/04/2000

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Bordeaux B 582001707 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 55 843 260 F. Adresse du siège social : 30 rue de Cambrai, 75019 Paris Etablissement principal: Activité : vente au détail de pret-à-porter. Adresse : centre commercial Mérignac Soleil, local n° 83, 33700 Mérignac Etablissement principal acquis par cession au prix stipulé de 7 025 000 F. Date d'effet : 21 février 2000. Précédent propriétaire : KOOKAI DISTRIBUTION. RCS B 399292994 Publication légale: Le Courrier français du 17 mars 2000. Oppositions : S.C.P. J. Bernard, 2 rue Vital-Carles, Bordeaux et Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats, 11 place Dauphine, 75053 Paris Louvre R.P.- S.P.

Hide

14/03/2000

Bodacc A

Vente et cession

RCS non encore inscrite. S.A. CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 55 843 260 F. Adresse du siège social : 30 rue de Cambrai, 75019 Paris Fonds secondaire acquis par achat, au prix stipulé de 4 000 000 de F ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Enseigne : Caroll et la City. Activité : pret-à-porter dames. Adresse : 24 rue Louis-Blanc, 66000 Perpignan. Date d'effet : 28 janvier 2000 Précédente propriétaire S.A. MEJEAN. RCS Perpignan B 594 200 313 Publication légale: La Dépeche du 8 février 2000. Oppositions : S.C.P. de Besombes, Singla, Padrixe, notaires, 6 rue des Jotglars, 66000 Perpignan.

Hide

27/01/2000

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 410620520 RC 97-B 1296 DAVIMAR. Forme : S.A.R.L. Capital : 50 000 F. Adresse du siège social : 68, rue Bonaparte 75006 Paris Etablissement principal: Activité : toute activité commerciale et industrielle intéressant la diffusion en gros, demi-gros et au détail, de vetements, survetements et sous-vetements, de pret-à-porter sous toutes ses formes et en toute matière, importation et exportation des articles et produits ci-dessus, vente de tous accessoires de vetements, commerce éventuellement de toutes matières premières, ainsi que tous articles et fournitures s'y rapportant. Adresse : 68, rue Bonaparte 75006 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente de pret-à- porter féminin. Adresse : 91, rue Saint- Dominique 75007 Paris Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 880 000 F Date de début d' activité: 1 e r janvier 1997. Précédent propriétaire : CAROLL INTERNATIONAL. RCS B 582001707 Publication légale: Spécial des Sociétés Françaises par Actions du 11 janvier 2000. Oppositions : M e Carel, 29, avenue Georges-Mandel, 75116 Paris.

Hide

25/04/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 582 001 707 RC 58-B 170 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification du président du conseil d' administration : PEIS (Yves). Nomination du directeur général non administrateur : RUBINI (Marie-José). Modification d'un administrateur : CARDON (Philippe, André, François).

Hide

09/04/1999

Bodacc A

Création d'établissement

RCS *. RCS Cannes B 393 210 661 RC RC 93- B 688 MEDIA SUD. Forme : S.A.R.L. Capital : 50 000 F. Adresse du siège social : 60, rue d'Antibes 06400 Cannes Etablissement principal: Activité : pret- à-porter féminin et accessoires. Adresse : 60, rue d'Antibes 06400 Cannes Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 1 000 000 de F. Commentaires : prise d'activité Date de début d'activité: 1er décembre 1993. Précédent propriétaire : : CAROLL INTERNATIONAL. RCS RCS B 582 001 707 Publication légale: L'Avenir du 13 mars 1999. Oppositions : Me Darmon Jean-Claude, 22, rue Jean-Jaurès, 06400 Cannes.

Hide

04/04/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 582 001 707 RC 58-B 170 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : commissaire aux comptes titulaire partant : SEFIGEST-STE D'ETUDES FINANCIERES ET DE GESTION. Commissaire aux comptes suppléant partant : CARRE ( Bernard).

Hide

14/01/1999

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 582 001 707 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : 30 rue de Cambrai, 75019 Paris Droit au bail dépendant du fonds secondaire acquis par achat, au prix stipulé de 3 063 931 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Clermont-Ferrand 98-B 521. Enseigne : Caroll. Activité : vente au détail d' articles textiles , hommes, femmes, enfants, lingerie, et produits parfumants. Adresse : centre commercial, place de Jaude, 63000 Clermont-Ferrand Date de début d'activité: 26 septembre 1998 Précédente propriétaire DEPAILLER Michèle. RCS A 319 780 169 RC 80-A 466 Publication légale: L'Annonceur Légal du 17 septembre 1998. Oppositions : étude de Me Maymat, 35 rue Gonod à Clermont- Ferrand (63).

Hide

17/10/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 582 001 707 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : 30 rue de Cambrai 75019 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : droit au bail. Adresse : centre commercial de Clermont-Jaude 63000 Clermont-Ferrand Droit au bail acquis par achat au prix stipulé de 3 063 931 F Date de début d'activité: 7 aout 1998. Précédent propriétaire : HUOT Michèle, Edmée. RCS Clermont-Ferrand A 319 780 169 RC 80-A 466 Publication légale: L' Annonceur légal du 17 septembre 1998. Oppositions : Me Maymat, 35 rue Gonod, 63000 Clermont-Ferrand.

Hide

16/10/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS *. RCS Bordeaux B 582 001 707 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 55 843 260 F. Activité : droit au bail. Adresse du siège social : 30, rue de Cambrai 75019 Paris Etablissement principal: Adresse : angle 10, rue Porte- Dijeaux et impasse de la Vieille-Tour 33000 Bordeaux Droit au bail acquis par cession au prix stipulé de 5 500 000 F. Date d'effet : 10 septembre 1998. Précédent propriétaire : : PARAPHARMA DISTRIBUTION. RCS RCS B 401 310 800 Publication légale: Les Echos Judiciaires Girondins du 10 septembre 1998. Oppositions : Me Hau Pale, 12, rue du Palais-de-l'Ombrière, 33000 Bordeaux.

Hide

24/09/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Créteil B 389 730 599 MARC ORIAN. Forme : S.A. Capital : 65 628 100 F. Adresse du siège social : 1 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 94130 Nogent-sur-Marne Fonds principal acquis par achat, au prix stipulé de 650 000 F Etablissement principal: Activité : vente de vetements femmes et accessoires s'y rapportant. Adresse : centre commercial Villiers-en-Bière, route nationale 7, 77190 Dammarie-les- Lys. Date d'effet : 1er aout 1998 Précédente exploitante CAROLL INTERNATIONAL. RCS Paris B 582 001 707 Publication légale: La Marne du 20 aout 1998. Oppositions : étude de Me Carel, 29 avenue Georges-Mandel, 75016 Paris et chez Me Aubry, 31 rue Saint-Ambroise, 77000 Melun.

Hide

02/06/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 582 001 707 RC 58-B 170 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un administrateur : PEIS ( Yves).

Hide

12/05/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Nice B 417 880 010 S.M.D. Forme : S.A. R.L. Capital : 50 000 F. Adresse du siège social : 9 rue de la Liberté 06000 Nice Etablissement principal: Activité : vente de pret-à-porter féminin et d' accessoires. Adresse : 9 rue de la Liberté 06000 Nice Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 1 500 000 F. Date d'effet : 27 mars 1998. Précédent propriétaire : CAROLL INTERNATIONAL. RCS B 582 001 707 Publication légale: L'Avenir du 11 avril 1998. Oppositions : Me Carel, 29 avenue Georges-Mandel, 75016 Paris et pour la validité chez Me Barrière, 28 avenue Saint-Sylvestre, 06000 Nice.

Hide

28/12/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 582 001 707 RC 58-B 170 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président du conseil d'administration partant : PEIS (Yves, Maurice, Jacques). Nomination du président du conseil d' administration : CARDON (Philippe, André, François).

Hide

04/10/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS. RCS B 582 001 707 RC RC 90-B 2245 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 24 876 750 F. Adresse du siège social : 166, rue du Landy 93200 Saint-Denis Etablissement principal: Activité : exploitation de toutes affaires industrielles et/ou commerciales, importation, exportation, distribution, location, achat, vente de toutes marchandises et en particulier de tous articles de bonneterie et de vetements confectionnés, et d'une manière générale de tous articles textiles et de tous articles de pret-à-porter et accessoires, ainsi que de tous articles similaires ou complémentaires, acquisition, exploitation, concession de toutes licences de marques, modèles, dessins, brevets et franchissage de ces marques, fabrication, importation, exportation, distribution, achat et vente de produits de parfumerie, cosmétiques et d'hygiène, ainsi que de tous articles similaires ou complémentaires. Adresse : 166, rue du Landy 93200 Saint-Denis ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente de pret-à- porter. Adresse : centre commercial Rosny 2 93110 Rosny-sous-Bois Etablissement secondaire acquis par apport au montant évalué à 41 139 661 F. Date d'effet : 26 février 1997. Précédent propriétaire : : CAROLL INTERNATIONAL BOUTIQUES. RCS RCS B 314 441 239 Publication légale: La Vie Judiciaire du 7 avril 1997 déclaration de créances: au greffe du tribunal de commerce de Bobigny.

Hide

19/08/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 582 001 707 A dater du: 12 juillet 1997 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : 30 rue de Cambrai, 75019 Paris Fonds secondaire acquis par fusion-absorption au montant évalué à 31 451 233,66 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Carcassonne 97-B 121. Enseigne : Caroll. Activité : vente de pret-à-porter. Adresse : 26-28- 30 rue Georges-Clemenceau, 11000 Carcassonne Date de début d'activité: 31 aout 1996 Précédente propriétaire CAROLL INTERNATIONAL BOUTIQUES. RCS Carcassonne B 314 441 239 RC 89-B 124 Publication légale: La Vie judiciaire du 13 avril 1997. Oppositions : au siège social de la société.

Hide

13/08/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Reims B 329 478 275 REIMS SPORTSWEAR. Forme : S.A.R.L. Capital : 50 000 F. Adresse du siège social : 13 rue Marx-Dormoy, 51100 Reims. Administration : gérant : EVRAT (Jean- Claude) Fonds secondaire acquis par achat au prix stipulé de 700 000 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente de vetements au détail. Adresse : 10 rue Théodore-Dubois, 51100 Reims. Date d'effet : 28 avril 1997 Précédente propriétaire S.A. CAROLL INTERNATIONAL. RCS Paris B 582 001 707 Publication légale: La Marne Agricole du 9 mai 1997. Oppositions : S.C.P. Ciret-Mobuchon, notaires associés, 29 boulevard Foch, 51100 Reims.

Hide

06/08/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 582 001 707 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : . Adresse du siège social : 30 rue de Cambrai 75019 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC 97-B 95. Adresse : 6 rue du Maréchal-Joffre 64000 Pau Etablissement Complémentaire. Activité : vente de pret-à -porter. Adresse : centre commercial Carrefour, route de Bayonne 64 - Lescar Etablissement complémentaire acquis par fusion-absorption au montant global de l'actif net de 31 451 233 F. Date d'effet : 26 février 1997. Précédent propriétaire : SOCIETE CAROLL INTERNATIONAL BOUTIQUES Publication légale: La Vie judiciaire du 7 au 13 avril 1997.

Hide

27/07/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS. RCS B 582 001 707 RC RC 89-B 1449 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 24 750 000 F. Adresse du siège social : 30, rue de Cambrai 75019 Paris Fonds secondaire acquis par apport au montant évalué à 41 139 661 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Adresse : centre commercial Auchan 78370 Plaisir. Activité : vente de pret-à-porter. Date d'effet : 26 février 1997. Précédent propriétaire : : CAROLL INTERNATIONAL BOUTIQUES S.A.R.L. RCS RCS B 314 441 239 Publication légale: La Vie Judiciaire, du 13 avril 1997 déclaration de créances: au tribunal de commerce de Versailles.

Hide

25/07/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 582 001 707 A dater du: 4 juin 1997 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S. A. Adresse du siège social : 30, rue de Cambrai, 75019 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE Alençon RC 97-B 47. Activité : vente de pret-à-porter. Enseigne : Caroll. Adresse : 2-4, Grande-Rue et 1, cours Clemenceau, 61000 Alençon Fonds secondaire acquis par fusion-absorption au montant évalué à 41 139 661,15 F Etablissement principal: Adresse : 30, rue de Cambrai, 75019 Paris Date de début d'activité: 26 février 1997 Précédente propriétaire CAROLL INTERNATIONAL BOUTIQUES. RCS Alençon B 314 441 239 RC 89-B 108 Publication légale: La Vie Judiciaire du 7 au 13 avril 1997 déclaration de créances: au tribunal de Paris.

Hide

13/07/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS *. RCS Evry B 582 001 707 RC RC 97-B 1336 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : 30, rue de Cambrai 75019 Paris Etablissement principal: Activité : vente de pret-à- porter. Adresse : centre commercial Evry II 91000 Evry Etablissement principal acquis par apport au montant évalué à 3 112 273 F Date de début d'activité: 26 février 1997. Précédent propriétaire : : DELVAL. RCS RCS B 324 215 912 Publication légale: La Vie Judiciaire du 7 avril 1997 déclaration de créances: au greffe du tribunal de commerce d' Evry.

Hide

29/06/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 582 001 707 A dater du: 16 juin 1997 RC 97-B 109 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : . Adresse du siège social : 30 rue de Cambrai 75019 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente de pret-à-porter. Adresse : 43 rue Charles-de-Gaulle 42300 Roanne Etablissement secondaire acquis par fusion-absorption au montant évalué à 41 139 661 F. Date d'effet : 26 février 1997. Précédent propriétaire : CAROLL INTERNATIONAL BOUTIQUES. RCS B 314 441 239 Publication légale: La Vie judiciaire du 7 au 13 avril 1997.

Hide

27/06/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 582 001 707 RC 97-B 349 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : . Adresse du siège social : 30 rue de Cambrai 75019 Paris Etablissement principal: Activité : vente de pret-à- porter. Adresse : rue d'Antibes, Le Gray d'Albion 06400 Cannes Etablissement principal acquis par apport au montant évalué à 1 302 355 F Date de début d' activité: 26 février 1997. Précédent propriétaire : CAROLL INTERNATIONAL BOUTIQUE. RCS B 314 441 239 Publication légale: La Vie judiciaire du 13 avril 1997. Oppositions : au fonds.

Hide

04/04/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Marseille B 582 001 707 RC 94-B 1165 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : 30 rue de Cambrai 75019 Paris Etablissement principal: Activité : exploitation de toutes affaires industrielles et/ou commerciales, importation, exportation, distribution, location, achat, vente de toutes marchandises et en particulier de tous articles de bonneterie et de vetements confectionnés d'une manière générale, de tous articles textiles et de tous articles de pret-à-porter et d' accessoires ainsi que de tous articles similaires ou complémentaires. Acquisition, exploitation, concession de toutes licences, de marques, de modèles, de dessins, de brevets et franchissage de ces marques. Fabrication, importation, exportation, distribution, achat, vente de produits de parfumerie, de cosmétiques et d' hygiène ainsi que de tous articles similaires ou complémentaires. Adresse : 34 rue Saint-Ferréol 13001 Marseille ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : pret- à-porter. Adresse : 36 rue Emile-Zola 13009 Marseille Etablissement secondaire reçu en location-gérance. Commentaires : réunion de toutes les parts Date de début d'activité: 1er novembre 1990. Date d'effet : 1er décembre 1994 Propriétaire SEVRINE. RCS B 327 919 775.

Hide

21/03/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Paris B 582 001 707 RC RC 58- B 170 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Administration : suppression : président- directeur général : COTTARD (Raymond, André). Modification : président du conseil d'administration : PEIS (Yves, Maurice, Jacques). Commentaires : modification survenue sur l' administration.

Hide

29/10/1996

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 582 001 707 A dater du: 31 mai 1996 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S. A. Adresse du siège social : 30 rue de Cambrai, 75019 Paris Fonds secondaire acquis par achat, au prix stipulé de 800 000 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Metz 96-B 325. Enseigne : Caroll. Activité : pret-à-porter féminin. Adresse : angle du 46 En Chaplerue et du 31 rue de la Chèvre, 57000 Metz Date de début d' activité: 29 janvier 1994 Précédente propriétaire MESSY. RCS B 324 653 872 Publication légale: Les Affiches Moniteur des Soumissions du 8 mars 1994. Oppositions : Me Grandidier, 26 rue du Coetlosquet, 57000 Metz.

Hide

01/09/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 582 001 707 RC 58-B 170 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 55 843 260 F. Commentaires : modification survenue sur le capital.

Hide

02/06/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 582 001 707 RC 58-B 170 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 8 461 100 F. Commentaires : modification survenue sur le capital.

Hide

30/03/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Paris B 582 001 707 RC RC 58- B 170 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Administration : président-directeur général : COTTARD (Raymond, André) Administrateurs : GROUPE ANDRE S.A. Mme VANNER, née SEYER (Francine, Anny) PEIS (Yves, Maurice, Jacques). Commissaires aux comptes titulaires : SOCIETE K.P.M.G. AUDIT SEFIGEST SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET DE GESTION. Commissaires aux comptes suppléants : CARRE (Bernard) RIVIERE (Gérard). Commentaires : modification survenue sur l' administration.

Hide

21/10/1995

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 582 001 707 RC 92-B 102 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.C.C.D. ( société anonyme coopérative de commerçants détaillants). Capital : 24 876 750 F. Adresse du siège social : 30, rue Cambrai, 75019 Paris Fonds principal acquis par achat au prix stipulé de : 1 950 000 F Etablissement principal: Adresse : 24, rue Lafayette, 31000 Toulouse. Activité : vente de pret-à -porter et accessoires s'y rapportant, au détail. Date d'effet : 1er septembre 1995. Précédent propriétaire : CRISTAL. RCS Toulouse B 397 452 186 RC 94-B 1260 Publication légale: La Gazette des Tribunaux du Midi du 16 septembre 1995. Oppositions : pour la validité : étude de Me Bares, 5, rue Rivals, 31000 Toulouse pour la correspondance : étude de Me Vidal, 22, avenue de la Gare, 34660 Cournonterral.

Hide

27/09/1995

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 582 001 707 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Capital : 24 876 750 F. Adresse du siège social : 30 rue de Cambrai, 75019 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente au détail de confection et accessoires féminins. Adresse : centre commercial Espace Réunion, 25 place de la Réunion, 68100 Mulhouse Fonds secondaire acquis par achat, au prix stipulé de 700 000 F. Date d'effet : 1er juillet 1995 Précédente propriétaire DHE S.A.R.L. Publication légale: Les Petites Affiches du Haut-Rhin du 16 juillet 1995. Oppositions : Me Goetschy, notaire, 5 rue Alfred-Engel, 68100 Mulhouse.

Hide

09/06/1995

Bodacc A

Création d'établissement

RCS. RCS Paris B 582 001 707 A dater du: 9 mai 1995 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : 30, rue de Cambrai 75019 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE Vannes RC RC 95-B 161. Activité : pret-à-porter féminin. Enseigne : Caroll. Adresse : centre commercial Le Fourchene 56000 Vannes Fonds secondaire acquis par achat au prix stipulé de 1 800 000 F Date de début d'activité: 1er janvier 1995 Précédent propriétaire-exploitant : JAHIER SPORTS CAMPING. RCS RCS B 877 180 273 RC RC 71-B 23 Publication légale: Ouest-France du 17 janvier 1995. Oppositions : au fonds.

Hide

28/05/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 582 001 707 RC 58-B 00170 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Administration : P.-D.G. : COTTARD ( Raymond, André). Administrateurs : BIGIO (Joseph) GROUPE ANDRE S.A. VANNER, née SEYER (Francine, Anny). Commissaires aux comptes titulaires : STE K.P.M.G. AUDIT SEFIGEST-STE D' ETUDES FINANCIERES ET DE GESTION. Commissaires aux comptes suppléants : CARRE (Bernard) RIVIERE (Gérard). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

Hide

25/03/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 582 001 707 RC 58-B 170 CAROLL INTERNATIONAL. Forme : S.A. Administration : P.-D.G. : COTTARD ( Raymond, André). Administrateurs : BIGIO (Joseph) GROUPE ANDRE S.A. Commissaires aux comptes titulaires : STE K.P.M.G. AUDIT SEFIGEST. Commissaires aux comptes suppléants : CARRE (Bernard) RIVIERE (Gérard). Commentaires : modification survenue sur l'administration.

 

 

Company events history

 

Date

Description

09/03/2018

Bodacc C : Deposit accounts notice

04/03/2018

Bodacc B: Various editing or changing

23/02/2018

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

22/02/2018

Minutes of general meeting of shareholders

22/02/2018

Changes to the Board of Directors

22/02/2018

Amendment

22/02/2018

New auditor

16/02/2018

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

31/08/2017

New accounts available

26/07/2017

Bodacc A : Sale and transfer

06/07/2017

Bodacc A : Sale and transfer

22/06/2017

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer

28/04/2017

New collective procedure

21/03/2017

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

03/03/2017

Disengagement in other companies

03/03/2017

New ultimate parent

21/02/2017

Bodacc B: Various editing or changing

09/02/2017

New chairman (CEO, CoB)

09/02/2017

Changes to the Board of Directors

09/02/2017

Amendment

08/02/2017

Bodacc C : Deposit accounts notice

01/02/2017

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer

09/12/2016

Bodacc B: Various editing or changing

29/11/2016

Appointment/resignation of company officers

29/11/2016

Amendment

25/09/2016

Bodacc A : Sale and transfer

23/09/2016

Bodacc A : Sale and transfer

06/09/2016

Bodacc B: Various editing or changing

31/08/2016

New accounts available

28/08/2016

Bodacc A : Sale and transfer

25/08/2016

Appointment/resignation of company officers

24/06/2016

Bodacc A : Sale and transfer

07/06/2016

Bodacc B: Various editing or changing

26/05/2016

Appointment/resignation of company officers

20/05/2016

Bodacc A : Sale and transfer

18/05/2016

Bodacc A : Sale and transfer

19/04/2016

Bodacc A : Sale and transfer

27/03/2016

Bodacc A : Sale and transfer

10/03/2016

Bodacc A : Sale and transfer

29/02/2016

Bodacc A : Sale and transfer

28/02/2016

Bodacc A : Sale and transfer

05/02/2016

Bodacc C : Deposit accounts notice

08/01/2016

Update Rating

08/01/2016

Update Limit

08/01/2016

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

04/12/2015

Bodacc B: Various editing or changing

20/11/2015

Changes to the Board of Directors

20/11/2015

Amendment

17/11/2015

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

15/11/2015

Bodacc B: Various editing or changing

30/10/2015

Appointment/resignation of company officers

06/09/2015

Bodacc B: Various editing or changing

04/09/2015

Bodacc B: Various editing or changing

31/08/2015

New accounts available

20/08/2015

Amendment

20/08/2015

New chairman (CEO, CoB)

19/08/2015

Amendment

19/08/2015

New chairman (CEO, CoB)

18/08/2015

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

22/07/2015

Bodacc B: Various editing or changing

09/07/2015

Legal Gazette: Appointment of the social representative

07/07/2015

Appointment/resignation of company officers

23/06/2015

Bodacc A : Sale and transfer

22/06/2015

Legal Gazette: End of rent-management

26/05/2015

Bodacc B: Various editing or changing

15/05/2015

Bodacc B: Various editing or changing

11/05/2015

Amendment

11/05/2015

Appointment/resignation of company officers

28/04/2015

Amendment

28/04/2015

Changes to the Board of Directors

28/04/2015

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

28/04/2015

New chairman (CEO, CoB)

28/04/2015

Appointment/resignation of company officers

31/03/2015

Legal Gazette: Appointment of the social representative

26/03/2015

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer

14/03/2015

Bodacc C : Deposit accounts notice

21/02/2015

Update Rating

21/02/2015

Update Limit

21/02/2015

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

06/10/2014

Payment incident closed

31/08/2014

New accounts available

13/08/2014

Bodacc B: Various editing or changing

12/08/2014

Appointment/resignation of company officers

29/07/2014

Amendment

29/07/2014

Minutes of general meeting of shareholders

29/07/2014

Updated articles of association

29/07/2014

Capital increase

12/06/2014

Legal Gazette: Modification of the share capital

04/04/2014

Bodacc B: Various editing or changing

20/03/2014

Appointment/resignation of company officers

16/02/2014

Bodacc B: Various editing or changing

31/01/2014

Changes to the Board of Directors

31/01/2014

Appointment/resignation of company officers

31/01/2014

Amendment

31/01/2014

New chairman (CEO, CoB)

30/01/2014

Bodacc B: Various editing or changing

23/01/2014

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

20/01/2014

Bodacc C : Deposit accounts notice

17/01/2014

Amendment

17/01/2014

Appointment/resignation of company officers

17/01/2014

Legal Gazette: Appointment of the social representative

17/01/2014

New chairman (CEO, CoB)

17/01/2014

Changes to the Board of Directors

11/01/2014

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

28/12/2013

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

20/12/2013

Legal Gazette: Appointment of the social representative

20/12/2013

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

31/08/2013

New accounts available

03/05/2013

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

24/03/2013

Bodacc B: Various editing or changing

21/03/2013

Bodacc A : Sale and transfer

10/03/2013

Bodacc B: Various editing or changing

08/03/2013

Appointment/resignation of company officers

08/03/2013

Amendment

22/02/2013

Amendment

22/02/2013

Appointment/resignation of company officers

08/02/2013

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer

08/12/2012

Bodacc C : Deposit accounts notice

01/10/2012

Power of attorney

01/10/2012

Minutes of Board meeting

01/10/2012

Merger

01/10/2012

Declaration of conformity

01/10/2012

Amendment

31/08/2012

New accounts available

03/08/2012

Formation of Establishment

03/07/2012

Bodacc A : Sale and transfer

26/06/2012

Private document

26/06/2012

Planned merger

05/03/2012

Bodacc C : Deposit accounts notice

09/02/2012

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

19/01/2012

Updated articles of association

19/01/2012

Amendment

07/12/2011

Payment incident detected

06/12/2011

Bodacc A : Sale and transfer

04/11/2011

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

03/11/2011

Minutes of general meeting of shareholders

03/11/2011

Updated articles of association

02/09/2011

New ultimate parent

31/08/2011

New accounts available

29/08/2011

Amendment

29/08/2011

Declaration of conformity

29/08/2011

Merger

29/08/2011

Minutes of general meeting of shareholders

29/08/2011

Updated articles of association

23/06/2011

Legal Gazette: Proposed merger

23/06/2011

Planned merger

14/06/2011

Appointment/resignation of company officers

07/06/2011

Closure of Establishment

06/06/2011

Amendment

06/06/2011

Appointment/resignation of company officers

03/05/2011

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

28/01/2011

Bodacc B: Various editing or changing

21/01/2011

New ultimate parent

13/01/2011

Amendment

13/01/2011

Changes to the Board of Directors

13/01/2011

Changes to the Board of Directors

13/01/2011

Minutes of Board meeting

13/01/2011

New chairman (CEO, CoB)

13/01/2011

New chairman (CEO, CoB)

02/01/2011

Bodacc B: Various editing or changing

17/12/2010

Appointment/resignation of company officers

17/12/2010

Amendment

17/12/2010

Legal Gazette: Appointment of the social representative

13/12/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

08/11/2010

Legal Gazette: Appointment of the social representative

31/08/2010

New accounts available

08/08/2010

Bodacc B: Various editing or changing

20/07/2010

Changes to the Board of Directors

20/07/2010

Amendment

20/07/2010

Minutes of Board meeting

07/07/2010

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

01/02/2010

Formation of Establishment

21/12/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

10/12/2009

Bodacc B: Various editing or changing

20/11/2009

Changes to the Board of Directors

20/11/2009

Amendment

28/10/2009

Legal Gazette: Appointment of the social representative

31/08/2009

New accounts available

06/03/2009

Bodacc A : Sale and transfer

06/03/2009

New Bodacc A ads detected

01/02/2009

New Bodacc A ads detected

01/02/2009

Formation of Establishment

20/11/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

31/08/2008

New accounts available

29/02/2008

Bodacc A : Sale and transfer

29/02/2008

New Bodacc A ads detected

15/02/2008

Bodacc A : Sale and transfer

15/02/2008

New Bodacc A ads detected

26/10/2007

Formation of Establishment

01/10/2007

Formation of Establishment

28/09/2007

Appointment/resignation of company officers

28/09/2007

Appointment/resignation of company officers

28/09/2007

Amendment

28/09/2007

Minutes of Board meeting

28/09/2007

Private document

28/09/2007

Minutes of Board meeting

28/09/2007

New chairman (CEO, CoB)

17/09/2007

Collection of preferential rights activated for this company

31/08/2007

New accounts available

31/08/2006

New accounts available

07/02/2006

Appointment/resignation of company officers

07/02/2006

Minutes of general meeting of shareholders

07/02/2006

Private document

07/02/2006

Updated articles of association

07/02/2006

Amendment

07/02/2006

New auditor

31/08/2005

New accounts available

31/08/2004

New accounts available

17/05/2004

Private document

17/05/2004

Amendment

17/05/2004

Appointment/resignation of company officers

19/02/2004

Updated articles of association

19/02/2004

Amendment

18/02/2004

Updated articles of association

18/02/2004

Private document

18/02/2004

Minutes of general meeting of shareholders

19/11/2003

Amendment

19/11/2003

Appointment/resignation of company officers

19/11/2003

Private document

16/09/2003

Private document

16/09/2003

Minutes of general meeting of shareholders

16/09/2003

Minutes of Board meeting

16/09/2003

Merger

16/09/2003

Declaration of conformity

16/09/2003

Amendment

16/09/2003

Updated articles of association

31/08/2003

New accounts available

24/07/2003

Private document

24/07/2003

Appointment/resignation of company officers

24/07/2003

Amendment

20/06/2003

Private document

20/06/2003

Planned merger

05/05/2003

Minutes of Board meeting

05/05/2003

Private document

05/05/2003

Amendment

28/04/2003

Application and court order

28/04/2003

Amendment

16/04/2003

Minutes of Board meeting

16/04/2003

Minutes of general meeting of shareholders

16/04/2003

Updated articles of association

16/04/2003

Merger

16/04/2003

Declaration of conformity

16/04/2003

Amendment

01/04/2003

Amendment

01/04/2003

Declaration of conformity

01/04/2003

Minutes of general meeting of shareholders

01/04/2003

Private document

01/04/2003

Updated articles of association

28/03/2003

Appointment/resignation of company officers

28/03/2003

Amendment

28/03/2003

Private document

24/01/2003

Planned merger

24/01/2003

Private document

10/12/2002

Amendment

10/12/2002

Application and court order

03/10/2002

Private document

03/10/2002

Sale of shares

02/04/2002

Declaration of conformity

02/04/2002

Amendment

02/04/2002

Merger

02/04/2002

Minutes of general meeting of shareholders

02/04/2002

Private document

02/04/2002

Updated articles of association

02/04/2002

Minutes of Board meeting

21/01/2002

Planned merger

21/01/2002

Private document

16/01/2002

Amendment

16/01/2002

Application and court order

06/04/2001

New auditor

06/04/2001

Updated articles of association

06/04/2001

Minutes of general meeting of shareholders

06/04/2001

Minutes of Board meeting

06/04/2001

Conversion of equity to euro

06/04/2001

Capital increase

06/04/2001

Private document

06/04/2001

Amendment

06/04/2001

Appointment/resignation of company officers

10/01/2001

Minutes of Board meeting

10/01/2001

Changes to the Board of Directors

10/01/2001

Appointment/resignation of company officers

10/01/2001

Amendment

10/01/2001

Private document

30/11/2000

Amendment

30/11/2000

Private document

30/11/2000

Appointment/resignation of company officers

15/09/2000

New chairman (CEO, CoB)

15/09/2000

New auditor

15/09/2000

Minutes of general meeting of shareholders

15/09/2000

Minutes of Board meeting

15/09/2000

Changes to the Board of Directors

15/09/2000

Appointment/resignation of company officers

15/09/2000

Private document

15/09/2000

Amendment

05/05/2000

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

05/05/2000

Private document

05/05/2000

Minutes of Board meeting

05/05/2000

Amendment

05/05/2000

Updated articles of association

12/04/1999

Appointment/resignation of company officers

12/04/1999

Changes to the Board of Directors

12/04/1999

Minutes of Board meeting

12/04/1999

Private document

12/04/1999

Amendment

12/04/1999

New chairman (CEO, CoB)

22/03/1999

Amendment

22/03/1999

Appointment/resignation of company officers

22/03/1999

Minutes of general meeting of shareholders

22/03/1999

New auditor

22/03/1999

Private document

12/12/1997

Amendment

12/12/1997

Private document

12/12/1997

New chairman (CEO, CoB)

12/12/1997

Minutes of general meeting of shareholders

12/12/1997

Minutes of Board meeting

12/12/1997

Changes to the Board of Directors

12/12/1997

Appointment/resignation of company officers

16/04/1997

Merger

16/04/1997

Private document

16/04/1997

Winding up

16/04/1997

Declaration of conformity

14/04/1997

Planned merger

14/04/1997

New chairman (CEO, CoB)

14/04/1997

Merger

14/04/1997

Minutes of Board meeting

14/04/1997

Private document

14/04/1997

Amendment

14/04/1997

Appointment/resignation of company officers

14/04/1997

Changes to the Board of Directors

14/04/1997

Declaration of conformity

14/04/1997

Minutes of general meeting of shareholders

04/03/1997

Amendment

04/03/1997

Appointment/resignation of company officers

04/03/1997

Changes to the Board of Directors

04/03/1997

Minutes of Board meeting

04/03/1997

New chairman (CEO, CoB)

04/03/1997

Private document

19/02/1997

Audit or Management Report

19/02/1997

Private document

23/01/1997

Merger

23/01/1997

Private document

26/11/1996

Private document

26/11/1996

Application and court order

16/08/1996

Private document

16/08/1996

Reconstitution of net assets

16/08/1996

Updated articles of association

16/08/1996

Minutes of general meeting of shareholders

16/08/1996

Partial contribution

16/08/1996

Declaration of conformity

16/08/1996

Capital reduction

16/08/1996

Capital increase

16/08/1996

Audit or Management Report

16/08/1996

Amendment

19/07/1996

Audit or Management Report

19/07/1996

Amendment

28/06/1996

Private document

28/06/1996

Merger

28/06/1996

Amendment

31/05/1996

Application and court order

15/05/1996

Updated articles of association

15/05/1996

Reconstitution of net assets

15/05/1996

Minutes of general meeting of shareholders

15/05/1996

Capital increase

15/05/1996

Capital reduction

15/05/1996

Continuation of business despite loss of equity

15/05/1996

Amendment

12/03/1996

Changes to the Board of Directors

12/03/1996

Minutes of general meeting of shareholders

12/03/1996

Updated articles of association

12/03/1996

Appointment/resignation of company officers

12/03/1996

Amendment

02/10/1995

Minutes of general meeting of shareholders

02/10/1995

Merger

02/10/1995

Declaration of conformity

02/10/1995

Amendment

02/10/1995

Updated articles of association

18/08/1995

Audit or Management Report

18/08/1995

Amendment

28/07/1995

Amendment

28/07/1995

Planned merger

28/07/1995

Private document

07/06/1995

Application and court order

09/03/1995

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

09/03/1995

New auditor

09/03/1995

Minutes of general meeting of shareholders

09/03/1995

Changes to the Board of Directors

09/03/1995

Appointment/resignation of company officers

09/03/1995

Amendment

19/09/1994

Capital increase

19/09/1994

Amendment

19/09/1994

Updated articles of association

25/08/1994

Updated articles of association

25/08/1994

Registration after transfer

25/08/1994

New auditor

25/08/1994

Minutes of Board meeting

25/08/1994

Articles of association

05/08/1994

Minutes of Board meeting

05/08/1994

Minutes of general meeting of shareholders

05/08/1994

Registered office transferred outside jurisdiction of the Commercial Court

07/04/1994

Minutes of Board meeting

07/04/1994

Changes to the Board of Directors

07/04/1994

Appointment/resignation of company officers

07/04/1994

Amendment

07/04/1994

New chairman (CEO, CoB)

01/02/1994

Minutes of general meeting of shareholders

01/02/1994

Capital increase

01/02/1994

Amendment

01/04/1993

Amendment

01/04/1993

Minutes of Board meeting

01/04/1993

Changes to the Board of Directors

01/04/1993

Appointment/resignation of company officers

01/04/1993

New chairman (CEO, CoB)

23/02/1993

Minutes of general meeting of shareholders

23/02/1993

Changes to the Board of Directors

23/02/1993

Appointment/resignation of company officers

23/02/1993

Amendment

31/08/1992

Merger

31/08/1992

Declaration of conformity

31/08/1992

Amendment

31/08/1992

Minutes of general meeting of shareholders

16/07/1992

Audit or Management Report

16/07/1992

Amendment

16/06/1992

Amendment

19/03/1992

Minutes of Board meeting

19/03/1992

Changes to the Board of Directors

19/03/1992

Appointment/resignation of company officers

19/03/1992

Amendment

19/03/1992

Minutes of general meeting of shareholders

 

 

Establishment events history

 

Date

Description

05/05/2017

Update of phone numbers

26/03/2017

Update of phone numbers

22/01/2017

Update of phone numbers

20/11/2016

Update of phone numbers

05/08/2016

Update of phone numbers

01/05/2016

Update of phone numbers

31/03/2016

Update of phone numbers

25/12/2014

Update of phone numbers

29/10/2014

Update of phone numbers

27/06/2014

Modification of Head office

12/01/2013

Update of phone numbers

03/08/2012

Modification of Head office

18/05/2012

Update of phone numbers

07/06/2011

Modification of Head office

01/02/2010

Modification of Head office

01/02/2009

Modification of Head office

22/02/2008

Update of phone numbers

26/10/2007

Modification of Head office

01/10/2007

Modification of Head office

 

 

Finaciles

 

Synthesized Accounts

Annual Accounts

31/08/2017

31/08/2016

31/08/2015

Account period (month)

12

12

12

Account Type

Normal

Normal

Normal

Date of capture

22/02/2018

20/03/2017

07/01/2016

Activity Code

4771Z

4771Z

4771Z

Employees

953

931

903

Active account

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Sector Average 2017

Sector Median 2017

Capital not called

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

55.24 0.06 K

0%

0 0 K

0%

Total fixed assets

82,526,584 82,527 K

0.7%

81,932,845 81,933 K

12.9%

72,592,518 72,593 K

564,527.94 564.53 K

14518.7%

85,060 85 K

96921.6%

Intangible assets

56,286,991 56,287 K

0.0%

56,270,053 56,270 K

14.9%

48,993,294 48,993 K

284,170.46 284.17 K

19707.5%

44,815 45 K

125498.6%

Tangible assets

13,682,330 13,682 K

1.5%

13,473,597 13,474 K

22.0%

11,039,593 11,040 K

190,183.84 190.18 K

7094.3%

10,712 11 K

127629.0%

Financial assets

12,557,264 12,557 K

3.0%

12,189,195 12,189 K

-2.9%

12,559,631 12,560 K

90,630.43 90.63 K

13755.5%

1,492 1 K

841539.7%

Net current assets

108,748,590 108,749 K

4.2%

104,327,790 104,328 K

16.2%

89,747,968 89,748 K

629,362.27 629.36 K

17179.2%

105,435 105 K

103042.8%

Stocks

35,744,281 35,744 K

-5.7%

37,916,522 37,917 K

11.1%

34,121,654 34,122 K

252,491.09 252.49 K

14056.7%

46,062 46 K

77500.4%

Advanced payments

1,800 2 K

-97.1%

62,795 63 K

-52.6%

132,554 133 K

1,795.15 1.80 K

0.3%

0 0 K

0%

Receivables

68,902,010 68,902 K

4.2%

66,106,269 66,106 K

20.2%

55,018,651 55,019 K

220,023.26 220.02 K

31215.8%

10,468 10 K

658115.6%

Securities and cash

4,100,499 4,100 K

1593.0%

242,203 242 K

-49.0%

475,109 475 K

154,320.07 154.32 K

2557.1%

17,877 18 K

22837.3%

Prepaid expenses

- -

-

- -

-

- -

2,197.90 2.20 K

-

629 1 K

-

Accounts of regularization

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

432.57 0.43 K

0%

0 0 K

0%

Total Assets

191,275,174 191,275 K

2.7%

186,260,633 186,261 K

14.7%

162,340,486 162,340 K

1,194,217.88 1,194.22 K

15916.8%

211,399 211 K

90380.6%

Passive Account

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Sector Average 2017

Sector Median 2017

Shareholders' equity

72,735,712 72,736 K

11.2%

65,401,848 65,402 K

26.0%

51,892,471 51,892 K

453,907.16 453.91 K

15924.4%

67,624 68 K

107459.0%

Share capital

9,931,887 9,932 K

0%

9,931,887 9,932 K

0%

9,931,887 9,932 K

117,110.20 117.11 K

8380.8%

8,000 8 K

124048.6%

Other capital resources

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

200.14 0.20 K

0%

0 0 K

0%

Risk Provisions

1,023,037 1,023 K

-45.4%

1,874,448 1,874 K

36.0%

1,378,051 1,378 K

9,192.65 9.19 K

11028.9%

0 0 K

0%

Liabilities

117,516,425 117,516 K

-1.2%

118,984,338 118,984 K

9.1%

109,069,960 109,070 K

730,403.43 730.40 K

15989.2%

118,224 118 K

99301.5%

Financial liabilities

58,339,363 58,339 K

-1.2%

59,051,148 59,051 K

0.1%

58,998,896 58,999 K

347,002.01 347.00 K

16712.4%

40,199 40 K

145026.4%

Advanced payments received

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

4,316.82 4.32 K

0%

0 0 K

0%

Trade account payables

34,623,536 34,624 K

-8.4%

37,791,928 37,792 K

15.0%

32,863,360 32,863 K

228,664.50 228.66 K

15041.6%

26,082 26 K

132648.8%

Tax and social liabilities

13,225,944 13,226 K

49.1%

8,873,151 8,873 K

25.2%

7,087,774 7,088 K

129,419.72 129.42 K

10119.4%

17,080 17 K

77335.3%

Other debts and fixed assets liabilities

11,327,582 11,328 K

-14.6%

13,268,111 13,268 K

31.1%

10,119,930 10,120 K

49,567.13 49.57 K

22753.0%

3,197 3 K

354219.1%

Account regularization

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

22,463.63 22.46 K

0%

0 0 K

0%

Total liabilities

191,275,174 191,275 K

2.7%

186,260,634 186,261 K

14.7%

162,340,482 162,340 K

1,194,241.06 1,194.24 K

15916.5%

211,399 211 K

90380.6%

Results

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Sector Average 2017

Sector Median 2017

Sales of Goods

206,825,889 206,826 K

-5.3%

218,357,854 218,358 K

4.9%

208,238,633 208,239 K

57,025,590.81 57,025.59 K

262.7%

254,106 254 K

81293.5%

Net turnover

202,887,029 202,887 K

-4.8%

213,035,919 213,036 K

3.7%

205,345,125 205,345 K

56,978,460.55 56,978.46 K

256.1%

249,443 249 K

81236.0%

of which net export turnover

25,837,503 25,838 K

-7.5%

27,939,719 27,940 K

7.7%

25,934,487 25,934 K

80,916.93 80.92 K

31830.9%

0 0 K

0%

Operating charges

191,439,001 191,439 K

-0.7%

192,817,437 192,817 K

3.7%

185,855,890 185,856 K

44,194,487.30 44,194.49 K

333.2%

247,048 247 K

77390.6%

Operating profit/loss

15,386,888 15,387 K

-39.8%

25,540,417 25,540 K

14.1%

22,382,743 22,383 K

12,831,103.46 12,831.10 K

19.9%

6,114 6 K

251566.5%

Financial income

246,835 247 K

680.6%

31,622 32 K

-90.3%

327,155 327 K

7,763.29 7.76 K

3079.5%

1 0 K

24683400.0%

Financial charges

4,704,956 4,705 K

-10.6%

5,265,649 5,266 K

18.8%

4,432,438 4,432 K

14,681.99 14.68 K

31945.8%

955 1 K

492565.5%

Financial profit/loss

-4,458,121 -4,458 K

14.8%

-5,234,027 -5,234 K

-27.5%

-4,105,283 -4,105 K

-6,951.99 -6.95 K

-64027.3%

-646 -1 K

-690011.6%

Pretax net operating income

10,928,767 10,929 K

-46.2%

20,306,390 20,306 K

11.1%

18,277,460 18,277 K

12,824,240.11 12,824.24 K

-14.8%

5,161 5 K

211656.8%

Extraordinary income

1,911,799 1,912 K

2.4%

1,867,866 1,868 K

-60.3%

4,709,725 4,710 K

43,004.09 43.00 K

4345.6%

0 0 K

0%

Extraordinary charges

2,505,487 2,505 K

13.1%

2,215,145 2,215 K

-46.1%

4,110,404 4,110 K

51,160.01 51.16 K

4797.4%

58 0 K

4319705.2%

Extraordinary profit/loss

-593,688 -594 K

-71.0%

-347,279 -347 K

-157.9%

599,321 599 K

-8,155.92 -8.16 K

-7179.2%

0 0 K

0%

Net result

7,372,352 7,372 K

-45.6%

13,556,283 13,556 K

4.0%

13,034,951 13,035 K

5,703.67 5.70 K

129156.3%

5,243 5 K

140513.2%

 

Accounts - Active

Normal Account

31/08/2017

31/08/2016

31/08/2015

Months

12

12

12

Grand Total - Active Accounts (I to VI)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Grand Total (I to VI)

Net

191,275,174 191,275 K

2.7%

186,260,633 186,261 K

14.7%

162,340,486 162,340 K

Gross

CO

245,219,982 245,220 K

3.2%

237,633,928 237,634 K

11.9%

212,291,662 212,292 K

Amortisation

1A

53,944,808 53,945 K

5.0%

51,373,295 51,373 K

2.8%

49,951,176 49,951 K

Non declared distributed capital (I)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Non declared distributed capital (I)

AA3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

AA

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Active fixed asset (II)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Total Active fixed asset (II)

Net

82,526,584 82,527 K

0.7%

81,932,845 81,933 K

12.9%

72,592,518 72,593 K

Gross

BJ

133,784,229 133,784 K

2.5%

130,471,957 130,472 K

11.1%

117,485,967 117,486 K

Amortisation

BK

51,257,645 51,258 K

5.6%

48,539,112 48,539 K

8.1%

44,893,449 44,893 K

Intangible fixed assets

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Start-up cost

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

AB

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

AC

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

R&D expenses

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

CX

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

CQ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Distributorships, patents

Net

1,896,575 1,897 K

-0.9%

1,912,947 1,913 K

-7.5%

2,068,024 2,068 K

Gross

AF

6,962,108 6,962 K

4.4%

6,668,586 6,669 K

4.0%

6,412,342 6,412 K

Amortisation

AG

5,065,532 5,066 K

6.5%

4,755,639 4,756 K

9.5%

4,344,318 4,344 K

Goodwill

Net

54,087,703 54,088 K

-0.3%

54,227,220 54,227 K

15.6%

46,925,270 46,925 K

Gross

AH

55,259,703 55,260 K

0.5%

54,972,868 54,973 K

15.0%

47,814,270 47,814 K

Amortisation

AI

1,172,000 1,172 K

57.2%

745,648 746 K

-16.1%

889,000 889 K

Other intangible fixed assets

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

AJ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

AK

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Pre-payments and downpayments

Net

302,713 303 K

133.1%

129,886 130 K

0%

0 0 K

Gross

AL

302,713 303 K

133.1%

129,886 130 K

0%

0 0 K

Amortisation

AM

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Sub Total Intangible asset

Net

56,286,991 56,287 K

0.0%

56,270,053 56,270 K

14.9%

48,993,294 48,993 K

Tangible fixed assets

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Lands

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

AN

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

AO

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Buildings

Net

7,498,991 7,499 K

4.0%

7,207,378 7,207 K

10.4%

6,530,414 6,530 K

Gross

AP

31,951,265 31,951 K

4.7%

30,527,745 30,528 K

8.1%

28,242,979 28,243 K

Amortisation

AQ

24,452,274 24,452 K

4.9%

23,320,367 23,320 K

7.4%

21,712,565 21,713 K

Plant

Net

849,618 850 K

0.3%

847,030 847 K

5.0%

806,963 807 K

Gross

AR

2,249,515 2,250 K

9.8%

2,049,257 2,049 K

10.7%

1,851,830 1,852 K

Amortisation

AS

1,399,897 1,400 K

16.4%

1,202,227 1,202 K

15.1%

1,044,867 1,045 K

Other tangible fixed assets

Net

3,831,898 3,832 K

23.1%

3,111,616 3,112 K

8.6%

2,865,898 2,866 K

Gross

AT

20,280,840 20,281 K

7.2%

18,918,847 18,919 K

6.4%

17,775,481 17,775 K

Amortisation

AU

16,448,942 16,449 K

4.1%

15,807,231 15,807 K

6.0%

14,909,583 14,910 K

Fixed assets in construction

Net

1,501,823 1,502 K

-34.9%

2,307,573 2,308 K

175.9%

836,318 836 K

Gross

AV

1,501,823 1,502 K

-34.9%

2,307,573 2,308 K

175.9%

836,318 836 K

Amortisation

AW

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Advances and payments on account

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

AX

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

AY

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Sub Total Tangible asset

Net

13,682,330 13,682 K

1.5%

13,473,597 13,474 K

22.0%

11,039,593 11,040 K

Financial assets

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Associates at equity

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

CS

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

CT

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other participations

Net

9,882,613 9,883 K

3.9%

9,508,613 9,509 K

-7.0%

10,223,496 10,223 K

Gross

CU

12,601,613 12,602 K

3.2%

12,216,613 12,217 K

0.0%

12,216,612 12,217 K

Amortisation

CV

2,719,000 2,719 K

0.4%

2,708,000 2,708 K

35.9%

1,993,116 1,993 K

Inter-company receivables

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

BB

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

BC

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other investment securities

Net

2,287 2 K

0%

2,287 2 K

0.0%

2,286 2 K

Gross

BD

2,287 2 K

0%

2,287 2 K

0.0%

2,286 2 K

Amortisation

BE

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Loans

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

BF

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

BG

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other financial assets

Net

2,672,364 2,672 K

-0.2%

2,678,295 2,678 K

14.8%

2,333,849 2,334 K

Gross

BH

2,672,364 2,672 K

-0.2%

2,678,295 2,678 K

14.8%

2,333,849 2,334 K

Amortisation

BI

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Sub Total Financial assets

Net

12,557,264 12,557 K

3.0%

12,189,195 12,189 K

-2.9%

12,559,631 12,560 K

Current Assets (III)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Total Current Assets

Net

108,748,590 108,749 K

4.2%

104,327,790 104,328 K

16.2%

89,747,968 89,748 K

Gross

CJ

111,435,753 111,436 K

4.0%

107,161,972 107,162 K

13.0%

94,805,695 94,806 K

Amortisation

CK

2,687,162 2,687 K

-5.2%

2,834,182 2,834 K

-44.0%

5,057,727 5,058 K

Stocks

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Raw materials

Net

4,147,810 4,148 K

-3.6%

4,303,300 4,303 K

63.0%

2,640,032 2,640 K

Gross

BL

4,181,483 4,181 K

-3.6%

4,338,708 4,339 K

62.3%

2,673,915 2,674 K

Amortisation

BM

33,672 34 K

-4.9%

35,408 35 K

4.5%

33,883 34 K

Work in progress (goods)

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

BN

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

BO

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Work in progress (services)

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

BP

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

BQ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Semi-finished and finished products

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

BR

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

BS

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Goods for resale

Net

31,596,471 31,596 K

-6.0%

33,613,222 33,613 K

6.8%

31,481,622 31,482 K

Gross

BT

33,752,471 33,752 K

-6.1%

35,957,279 35,957 K

-0.3%

36,062,739 36,063 K

Amortisation

BU

2,156,000 2,156 K

-8.0%

2,344,057 2,344 K

-48.8%

4,581,117 4,581 K

Sub Total Stocks

Net

35,744,281 35,744 K

-5.7%

37,916,522 37,917 K

11.1%

34,121,654 34,122 K

Advance payments to suppliers

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Advance payments to suppliers

Net

1,800 2 K

-97.1%

62,795 63 K

-52.6%

132,554 133 K

Gross

BV

1,800 2 K

-97.1%

62,795 63 K

-52.6%

132,554 133 K

Amortisation

BW

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Debtors

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Trade accounts receivable

Net

14,899,421 14,899 K

13.7%

13,103,175 13,103 K

11.1%

11,793,291 11,793 K

Gross

BX

14,965,299 14,965 K

14.0%

13,125,141 13,125 K

11.2%

11,800,017 11,800 K

Amortisation

BY

65,878 66 K

199.9%

21,965 22 K

226.6%

6,726 7 K

Other debtors

Net

51,649,760 51,650 K

2.3%

50,469,594 50,470 K

25.3%

40,270,252 40,270 K

Gross

BZ

52,081,372 52,081 K

2.3%

50,902,346 50,902 K

25.0%

40,706,253 40,706 K

Amortisation

CA

431,612 432 K

-0.3%

432,752 433 K

-0.7%

436,001 436 K

Capital subscribed and called up

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

CB

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

CC

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Sub Total debtors

Net

66,549,181 66,549 K

4.7%

63,572,769 63,573 K

22.1%

52,063,543 52,064 K

Divers

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Investment securities

Net

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

CD

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Amortisation

CE

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Cash and cash equivalents

Net

4,100,499 4,100 K

1593.0%

242,203 242 K

-49.0%

475,109 475 K

Gross

CF

4,100,499 4,100 K

1593.0%

242,203 242 K

-49.0%

475,109 475 K

Amortisation

CG

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Sub Total Divers

Net

4,100,499 4,100 K

1593.0%

242,203 242 K

-49.0%

475,109 475 K

Prepaid expenses

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Prepaid expenses

Net

2,352,829 2,353 K

-7.1%

2,533,500 2,534 K

-14.3%

2,955,108 2,955 K

Gross

CH

2,352,829 2,353 K

-7.1%

2,533,500 2,534 K

-14.3%

2,955,108 2,955 K

Amortisation

CI

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Equalization accounts (IV to VI)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Expenses of loan issue to be spread

CW3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Premiums on redemption of bonds

CM3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Currency differential gain

CN3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

References

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Due within one year

CP

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Due after one year

CR

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Accounts - Passive

Grand Total - Passive Accounts (I to V)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Grand Total (I to V)

EE

191,275,174 191,275 K

2.7%

186,260,634 186,261 K

14.7%

162,340,482 162,340 K

Shareholder Equity (I)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Total shareholders' equity (Total I)

DL

72,735,712 72,736 K

11.2%

65,401,848 65,402 K

26.0%

51,892,471 51,892 K

Equity and shareholders' equity

DA

9,931,887 9,932 K

0%

9,931,887 9,932 K

0%

9,931,887 9,932 K

Issue and merger premiums

DB

6,992,916 6,993 K

0%

6,992,916 6,993 K

0%

6,992,916 6,993 K

Revaluation differentials

DC

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Of which equity differential

EK

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Legal reserve

DD

993,189 993 K

0%

993,189 993 K

0.0%

993,188 993 K

Statutory or contractual reserve

DE

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Special regulated reserves

DF

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other reserves

DG

1,723 2 K

0%

1,723 2 K

0.1%

1,722 2 K

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Profits or losses brought forward

DH

46,536,545 46,537 K

41.1%

32,980,262 32,980 K

65.4%

19,945,310 19,945 K

Profit or loss for the period

DI

7,372,352 7,372 K

-45.6%

13,556,283 13,556 K

4.0%

13,034,951 13,035 K

Investment grants

DJ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Special tax-allowable reserves

DK

907,101 907 K

-4.1%

945,588 946 K

-4.7%

992,497 992 K

Other capital resources (II)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Total other capital resources (Total II)

DO

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Income from participating securities

DM

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Conditional loans

DN

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Provisions for risks and charges (III)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

1,023,037 1,023 K

-45.4%

1,874,448 1,874 K

36.0%

1,378,051 1,378 K

Risk provisions

DP

323,404 323 K

-72.3%

1,166,103 1,166 K

28.1%

910,334 910 K

Reserves for charges

DQ

699,633 700 K

-1.2%

708,345 708 K

51.4%

467,717 468 K

Liabilities (IV)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Total Liabilities (Total IV)

EC

117,516,425 117,516 K

-1.2%

118,984,338 118,984 K

9.1%

109,069,960 109,070 K

Convertible debentures

DS

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other debentures

DT

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Bank loans and liabilities

DU

0 0 K

0%

411,631 412 K

0%

0 0 K

Sundry loans and financial liabilities

DV

58,339,363 58,339 K

-0.5%

58,639,517 58,640 K

-0.6%

58,998,896 58,999 K

Of which participating loans

EI

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Advance payments received for current orders

DW

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Trade accounts payables

DX

34,623,536 34,624 K

-8.4%

37,791,928 37,792 K

15.0%

32,863,360 32,863 K

Tax and social security liabilities

DY

13,225,944 13,226 K

49.1%

8,873,151 8,873 K

25.2%

7,087,774 7,088 K

Fixed asset liabilities

DZ

1,619,313 1,619 K

-55.5%

3,636,061 3,636 K

91.0%

1,903,658 1,904 K

Other debts

EA

9,708,269 9,708 K

0.8%

9,632,050 9,632 K

17.2%

8,216,272 8,216 K

Translation loss (V)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Translation loss (Total V)

ED

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Equalization accounts

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Deferred income

EB

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

References

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Of which tax-allowable reserve

EF

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Deferred income and liabilities

EG

0 0 K

0%

0 0 K

0%

49,624,342 49,624 K

Of which current bank facilities

EH

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Result account

1 - Operating result (I-II)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Operating result (Total I-II)

GG

15,386,888 15,387 K

-39.8%

25,540,417 25,540 K

14.1%

22,382,743 22,383 K

2 - Financial result (V-VI)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Financial result (Total V-VI)

GV

-4,458,121 -4,458 K

14.8%

-5,234,027 -5,234 K

-27.5%

-4,105,283 -4,105 K

3 - Pre-tax net operating income result (I to VI)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

10,928,767 10,929 K

-46.2%

20,306,390 20,306 K

11.1%

18,277,460 18,277 K

4 - Extraordinary result (VII-VIII)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

-593,688 -594 K

-71.0%

-347,279 -347 K

-157.9%

599,321 599 K

Profit or loss

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Profit or loss

HN

7,372,352 7,372 K

-45.6%

13,556,283 13,556 K

4.0%

13,034,951 13,035 K

Total Income (I+III+V+VII)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Total Income (Total I+III+V+VII)

HL

208,984,523 208,985 K

-5.1%

220,257,342 220,257 K

3.3%

213,275,513 213,276 K

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

201,612,172 201,612 K

-2.5%

206,701,059 206,701 K

3.2%

200,240,559 200,241 K

Operating income (I)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Total operating income (Total I)

FR

206,825,889 206,826 K

-5.3%

218,357,854 218,358 K

4.9%

208,238,633 208,239 K

Operating income (details)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Sale of goods for resale

FC

200,799,278 200,799 K

-4.8%

210,840,740 210,841 K

3.8%

203,031,888 203,032 K

France

FA

175,887,460 175,887 K

-4.5%

184,156,068 184,156 K

3.2%

178,460,386 178,460 K

Export

FB

24,911,818 24,912 K

-6.6%

26,684,672 26,685 K

8.6%

24,571,502 24,572 K

Sale of goods produced

FF

179,539 180 K

-10.2%

199,861 200 K

2139.1%

8,926 9 K

France

FD

11,832 12 K

15.2%

10,271 10 K

15.1%

8,926 9 K

Export

FE

167,707 168 K

-11.5%

189,591 190 K

0%

0 0 K

Sale of services

FI

1,908,212 1,908 K

-4.4%

1,995,318 1,995 K

-13.4%

2,304,311 2,304 K

France

FG

1,150,234 1,150 K

23.7%

929,863 930 K

-1.2%

941,326 941 K

Export

FH

757,978 758 K

-28.9%

1,065,456 1,065 K

-21.8%

1,362,985 1,363 K

Net turnover

FL

202,887,029 202,887 K

-4.8%

213,035,919 213,036 K

3.7%

205,345,125 205,345 K

France

FJ

177,049,527 177,050 K

-4.3%

185,096,202 185,096 K

3.2%

179,410,638 179,411 K

Export

FK

25,837,503 25,838 K

-7.5%

27,939,719 27,940 K

7.7%

25,934,487 25,934 K

Stocked production

FM

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Self-constructed assets

FN

54,347 54 K

55.1%

35,042 35 K

-33.4%

52,599 53 K

Operating grants

FO

2,367 2 K

-61.6%

6,162 6 K

-65.5%

17,864 18 K

Release of reserves and provisions

FP

3,874,071 3,874 K

-26.1%

5,241,376 5,241 K

92.6%

2,722,078 2,722 K

Other income

FQ

8,076 8 K

-79.5%

39,355 39 K

-61.0%

100,967 101 K

Operating charges (II)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Total operating charges (Total II)

GF

191,439,001 191,439 K

-0.7%

192,817,437 192,817 K

3.7%

185,855,890 185,856 K

Exploitation charges

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Purchase of goods for resale

FS

59,660,167 59,660 K

-11.8%

67,665,071 67,665 K

-3.3%

69,981,156 69,981 K

Change in stocks of goods for resale

FT

2,206,231 2,206 K

13373.0%

-16,622 -17 K

-101.7%

993,601 994 K

Purchase of raw materials

FU

15,377,534 15,378 K

-5.1%

16,198,229 16,198 K

37.4%

11,790,200 11,790 K

Change in stocks of raw materials

FV

157,225 157 K

109.4%

-1,664,793 -1,665 K

-470.3%

449,625 450 K

Other external purchases and charges

FW

67,770,724 67,771 K

1.4%

66,813,139 66,813 K

12.7%

59,285,083 59,285 K

Tax, duty and similar payments

FX

3,284,549 3,285 K

-10.1%

3,655,389 3,655 K

15.6%

3,161,392 3,161 K

Payroll

FY

26,608,005 26,608 K

9.8%

24,236,794 24,237 K

6.8%

22,686,638 22,687 K

Social security costs

FZ

9,693,721 9,694 K

6.0%

9,148,704 9,149 K

6.9%

8,558,950 8,559 K

Depreciation

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Depreciation of fixed assets

GA

3,710,396 3,710 K

-3.9%

3,860,124 3,860 K

-6.2%

4,117,456 4,117 K

Amortisation of fixed assets

GB

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Depreciation/amortisation of current assets

GC

2,328,751 2,329 K

-4.1%

2,428,584 2,429 K

-46.2%

4,516,427 4,516 K

Provisions for risks and charges

GD

321,590 322 K

-2.3%

329,154 329 K

285.5%

85,378 85 K

Other charges

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Other charges

GE

320,108 320 K

95.6%

163,664 164 K

-28.8%

229,984 230 K

Operating charges (III-IV)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Financial income (V)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Total financial income (Total V)

GP

246,835 247 K

680.6%

31,622 32 K

-90.3%

327,155 327 K

Share financial income

GJ

201,475 201 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other investment income & capitalised receivables

GK

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other interest and similar income

GL

1,498 1 K

0%

0 0 K

0%

1,907 2 K

Released provisions and transferred charges

GM

43,862 44 K

0%

0 0 K

0%

325,248 325 K

Exchange gains

GN

0 0 K

0%

31,622 32 K

0%

0 0 K

Net income from disposal of investment securities

GO

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Financial charge (VI)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Total financial charge (Total VI)

GU

4,704,956 4,705 K

-10.6%

5,265,649 5,266 K

18.8%

4,432,438 4,432 K

Financial reserves and provisions

GQ

0 0 K

0%

106,035 106 K

824.7%

11,467 11 K

Interest and similar charges

GR

4,695,206 4,695 K

-9.0%

5,158,980 5,159 K

16.7%

4,419,309 4,419 K

Exchange losses

GS

9,750 10 K

1437.9%

634 1 K

-61.9%

1,662 2 K

Net loss from disposal of investment securities

GT

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Extraordinary income (VII)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Total extraordinary income (Total VII)

HD

1,911,799 1,912 K

2.4%

1,867,866 1,868 K

-60.3%

4,709,725 4,710 K

Extraordinary operating income

HA

357,737 358 K

745.2%

42,327 42 K

-97.8%

1,889,802 1,890 K

Extraordinary income from capital transactions

HB

0 0 K

0%

655,000 655 K

9976.9%

6,500 7 K

Released provisions and transferred charges

HC

1,554,062 1,554 K

32.8%

1,170,538 1,171 K

-58.4%

2,813,423 2,813 K

Extraordinary charges (VIII)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

2,505,487 2,505 K

13.1%

2,215,145 2,215 K

-46.1%

4,110,404 4,110 K

Extraordinary operating charges

HE

764,150 764 K

597.7%

109,521 110 K

-94.6%

2,013,604 2,014 K

Extraordinary charges from capital transactions

HF

456,236 456 K

-1.4%

462,504 463 K

-50.1%

926,958 927 K

Extraordinary reserves and provisions

HG

1,285,101 1,285 K

-21.8%

1,643,120 1,643 K

40.5%

1,169,842 1,170 K

Employee profit sharing (IX)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

458,486 458 K

179.7%

163,931 164 K

-22.0%

210,293 210 K

Tax on profits (X)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Tax on profits (Total X)

HK

2,504,242 2,504 K

-59.9%

6,238,897 6,239 K

10.8%

5,631,534 5,632 K

References

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Of which equipment leases

HP

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Of which property leases

HQ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Of which transferred charges

A1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

1,189,958 1,190 K

Of which trader's own contributions

A2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other incomes tax return forms

Fixed Assets

Grand Total Fixed Assets (I to IV)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Gross value at begin of period

OG

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increasess due to revaluation

OH

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by budget item transfer

OK1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by transfers

OK2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross value at the end of period

OL

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Research and development Charge (Total I)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Gross value at begin of period

CZ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increasess due to revaluation

KB

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by budget item transfer

CO1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by transfers

CO2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross value at the end of period

DO

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Gross value at begin of period

KD

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increasess due to revaluation

KE

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by budget item transfer

LV1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by transfers

LV2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross value at the end of period

LW

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Tangible fixed assets (Total III)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Gross value at begin of period

LN

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increasess due to revaluation

LO

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by budget item transfer

NG1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by transfers

NG2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross value at the end of period

NH

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Financial assets (Total IV)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Gross value at begin of period

LQ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increasess due to revaluation

LR

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by transfers

NJ2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Gross value at the end of period

NK

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Reserve for depreciation

Situation and movement of reserve for depreciation - Grand total (I-II-III)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Reserve for depreciation value at begin of period

ON

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increases

OP

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess

OQ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Reserve for depreciation value at the end of period

OR

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Research and development charge (Total I)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increases

PB

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess

PC

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by budget item transfer

PD

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other intangible assets (Total II)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increases

PF

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess

PG

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by budget item transfer

PH

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Total fixed assets amotisation (Total III)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increases

QV

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreases

QW

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by budget item transfer

QX

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Movements during period affecting charge allocated over several period

Deferred charges and debt issuance costs

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Gross value at begin of period

Z91

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increases

Z92

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreasess by budget item transfer

B1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Premium refund of obligations

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Net value at begin of period

SP1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increases

SP2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Depreciation of fixed assets during period

SP

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Net value at the end of period

SR

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Provisions included in balance sheet

Grand Total (I-II-III)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Value at begining of period

7C

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increases

UB

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreases

UC

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Value at the end of period

UD

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Includes Total allocations

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Operating

UE

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Financial

UG

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Exceptional

UJ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Includes Total Withdrawal

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Operating

UF

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Financial

UH

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Exceptional

UK

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Total regulated provisions (Total I)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Value at begining of period

3Z

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increases

TS

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreases

TT

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Value at the end of period

TU

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Total risk and charge provisions (Total II)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Value at begining of period

5Z

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increases

TV

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreases

TW

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Value at the end of period

TX

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Total Provision for depreciation (Total III)

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Value at begining of period

7B

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Increases

TY

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Decreases

TZ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Value at the end of period

UA

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

State deadlines claims and debts at the end of period

State claims

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Gross value

VT

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

VU

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than one year

VV

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

State of loans

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Claims related to holdings (gross)

UL

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Loans (gross)

UP

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Loans (1 year at most)

UR

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other financial assets (gross)

UT

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other financial assets (1 year at most)

UV

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Receivables statement of assets

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Customers doubtful or disputed

VA

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other claims customer

UX

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Receivables represent Loaned Securities

UU

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Provision for depreciation previously established

UQ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Personnel and associated accounts

UY

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Social Security and other social organizations

UZ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Income taxes

VM

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Value added tax

VB

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other taxes and payments assimilated

VN

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

State and other public - Miscellaneous

VP

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Group and Associates

VC

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Prepaid

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Prepaid

VS

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

State Debt

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Total debt (gross)

VY

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

VZ2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 5 years

VZ4

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Details

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Convertible bonds (gross)

7Y1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

7Y2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other bonds (gross)

7Z1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

7Z2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

VG2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

VH2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

8A2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

8A3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

8B2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

8B3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

8C2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

8D2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Taxes on profits (gross)

8E1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

8E2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

VAT (Gross)

VW1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

VW2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Backed Obligations (gross)

VX1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

VX2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

VQ2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

8J2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 5 years

8J4

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Groups and associates (gross)

VI1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

VI2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 5 years

V14

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other liabilities (gross)

8K1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

8K2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

SZ2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Products in advance (gross)

8L1

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

1 year at most

8L2

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

References

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Loans made during the period

VJ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Debt repaid during the period

VK

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Table allocation results and other information

Dividends distributed

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Dividends

ZE

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Commitments

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Commitments leasing furniture

YQ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Commitments Real Estate Leasing

YR

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other charges Externes

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Subcontracting

YT

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Staff outside the company

YU

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Fees, commissions and brokerage

YV

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other accounts

ST

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Total Other purchases and external

ZJ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Taxes and Fees

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Business tax

YW

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Other taxes and payments assimilated

9Z

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Total taxes and fees

YX

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

VAT

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Amount VAT collected

YY

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Total VAT on goods and services

YZ

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

Average number of employees

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Average number of employees

YP

953 1 K

2.4%

931 1 K

3.1%

903 1 K

Groups and Shareholders

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Groups and Shareholders

ZR

0 0 K

-

- -

-

- -

 

 

Ratios

Synthetic financial performance indicators

31/08/2017

31/08/2016

31/08/2015

Score

Situation

Score

Situation

Score

Situation

Hide AFDCC 2

-

-

-

-

-

-

Description

The AFDCC 2 score uses sectors of activity and company sizes for companies with a turnover of 150 000 to 75 million euros. This calculation allows a classification of the companies in three levels:

-

Healthy: the higher the score value is, the more the company is healthy.

-

Undetermined: it’s impossible to determine the situation.

-

Fragility/Failure: the lower the score value is, the more the company is in danger.

The status are completed which “+/-“ signs.

Hide Conan & Holder

0.13

20%

0.15

10%

0.16

0%

Description

The Conan and Holder (1979) is a recommended method for industrial companies with a turnover of 150 000 to 75 million euros. It is based only on a balance sheet. This calculation allows a classification of the most perilous situation (Score lower than 0.002) to the healthiest situation (score greater than 0.16):

-

Healthy situation: companies which maintain or develop their activity level.

-

Situation to monitor: companies which has to follow remedial measures or find a new strategy.

-

Perilous situation: companies which could have important cash difficulties and have a failure risk.

Hide Altman

-

-

-

-

-

-

Description

The Altman score is a method based only on a complete balance sheet, this calculation allows a classification of the companies in three levels:

-

Good shape: companies which have a low risk (with a score value higher than 2.99).

-

Warning signs: companies which should be approached with caution and with a high risk in the next two years for bankruptcy (with a score value between 2.99 and 1.81).

-

Bankruptcy: companies which are in immediate risk (with a score value lower than 1.81).

Structure and Liquidity

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Sector Average 2017

Sector Median 2017

Fixed Asset Financing

1.37

2.2%

1.34

0%

1.34

20.79

-93.4%

1.33

3.0%

Global Debt

209 days

4.0%

201 days

5.2%

191 days

283.45 days

-26.3%

157 days

33.1%

Working Capital Fund overall net

88 days

17.3%

75 days

7.1%

70 days

282.06 days

-68.8%

56 days

57.1%

Financial independence

124.68 %

12.6%

110.75 %

25.9%

87.95 %

9,590.20 %

-98.7%

96.51 %

29.2%

Solvability

38.03 %

8.3%

35.11 %

9.8%

31.97 %

-231.52 %

116.4%

35.40 %

7.4%

Capacity debt futures

-

-

-

-

-

51,830.54 %

-

763.64 %

-

Coverage of current assets by net working capital overall

45.44 %

7.1%

42.43 %

-1.8%

43.20 %

-48.81 %

193.1%

42.79 %

6.2%

General Liquidity

-

-

-

-

-

1.73

-

0.11

-

Restricted Liquidity

-

-

-

-

-

2.74

-

0.41

-

Management or rotation

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Sector Average 2017

Sector Median 2017

Need background in operating working capital

5 days

-28.6%

7 days

-36.4%

11 days

26.75 days

-81.3%

21 days

-76.2%

Treasury

7 days

0%

0 days

0%

1 days

167.32 days

-95.8%

5 days

40.0%

Inventory turnover of goods

196 days

2.6%

191 days

4.4%

183 days

246.57 days

-20.5%

160 days

22.5%

Average length of credit granted to customers

27 days

22.7%

22 days

4.8%

21 days

6.73 days

301.2%

0 days

0%

Average length of credit obtained suppliers

86 days

-5.5%

91 days

9.6%

83 days

263.60 days

-67.4%

49 days

75.5%

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

37 days

2.8%

36 days

38.5%

26 days

133.31 days

-72.2%

0 days

0%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

-

-

-

-

-

1,704.07 days

-

468 days

-

Rotation tangible assets

-

-

-

-

-

650,297.13 %

-

441.99 %

-

Profitability of the business

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Sector Average 2017

Sector Median 2017

Margin trading

68.48 %

1.9%

67.22 %

4.5%

64.31 %

37.36 %

83.3%

42.91 %

59.6%

Profitability of the business

8.96 %

-29.4%

12.69 %

-8.6%

13.88 %

-7.25 %

223.6%

4.82 %

85.9%

Net profit

3.63 %

-42.9%

6.36 %

0.2%

6.35 %

10.42 %

-65.2%

2.11 %

72.0%

Growth rate of turnover (excluding VAT)

-4.76 %

-226.9%

3.75 %

175.0%

-5.00 %

22,908.84 %

-100.0%

-1.95 %

-144.1%

Rates integration

28.47 %

-5.4%

30.08 %

-1.8%

30.63 %

18.27 %

55.8%

25.33 %

12.4%

Rate leasing furniture

0.00 %

0%

0.00 %

0%

0.00 %

0.03 %

0%

0.00 %

0%

Work Factor

62.84 %

20.6%

52.10 %

4.9%

49.68 %

84.70 %

-25.8%

72.23 %

-13.0%

Weight interests

2.32 %

-6.1%

2.47 %

14.4%

2.16 %

0.80 %

190.0%

0.39 %

494.9%

Return on capital

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Sector Average 2017

Sector Median 2017

Cash flow from the overall profitability

6.32 %

-29.1%

8.91 %

-5.0%

9.38 %

5,606.43 %

-99.9%

4.57 %

38.3%

Rates of economic profitability

14.00 %

-36.4%

22.00 %

-15.4%

26.00 %

33,305.32 %

-100.0%

9.00 %

55.6%

Financial profitability

72,735,712.00 %

11.2%

65,401,848.00 %

26.0%

51,892,471.00 %

432,090.07 %

16733.5%

22,440.00 %

324034.2%

Return on investment

9.21 %

-39.1%

15.12 %

-4.0%

15.75 %

24.77 %

-62.8%

5.72 %

61.0%

Management intermediate balances

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Sector Average 2017

Sector Median 2017

Turnover

202,887,029 202,887 K

-4.8%

213,035,919 213,036 K

3.7%

205,345,125 205,345 K

56,978,460.55 56,978.46 K

256.1%

249,443 249 K

81236.0%

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Sector Average 2017

Sector Median 2017

Sales of goods

200,799,278 200,799 K

-4.8%

210,840,740 210,841 K

3.8%

203,031,888 203,032 K

-

-

- Purchase of goods

59,660,167 59,660 K

-11.8%

67,665,071 67,665 K

-3.3%

69,981,156 69,981 K

-

-

+/- Stock of goods variation

2,206,231 2,206 K

13373.0%

-16,622 -17 K

-101.7%

993,601 994 K

-

-

Trading margin

138,932,880 € 138,933 K €

-3.0%

143,192,291 € 143,192 K €

8.4%

132,057,131 € 132,057 K €

15,172,435.94 € 15,172.44 K €

815.7%

104,265 € 104 K €

133149.8%

68.48 % CA 68.48 % CA

1.9%

67.22 % CA 67.22 % CA

4.5%

64.31 % CA 64.31 % CA

38.34 % CA 38.34 % CA

78.6%

43.20 % CA 43.20 % CA

58.5%

 

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Sector Average 2017

Sector Median 2017

Sale of goods produced

2,087,751 2,088 K

-4.9%

2,195,179 2,195 K

-5.1%

2,313,237 2,313 K

-

-

+/- Stocked production

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

-

-

+ Self-constructed assets

54,347 54 K

55.1%

35,042 35 K

-33.4%

52,599 53 K

-

-

Period production

2,142,098 € 2,142 K €

-4.0%

2,230,221 € 2,230 K €

-5.7%

2,365,836 € 2,366 K €

185,442.04 € 185.44 K €

1055.1%

0 € 0 K €

0%

1.06 % CA 1.06 % CA

1.0%

1.05 % CA 1.05 % CA

-8.7%

1.15 % CA 1.15 % CA

13.89 % CA 13.89 % CA

-92.4%

0.00 % CA 0.00 % CA

0%

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Sector Average 2017

Sector Median 2017

Trading margin

138,932,880 138,933 K

-3.0%

143,192,291 143,192 K

8.4%

132,057,131 132,057 K

15,172,435.94 15,172.44 K

815.7%

104,265 104 K

133149.8%

+ Period Production

2,142,098 2,142 K

-4.0%

2,230,221 2,230 K

-5.7%

2,365,836 2,366 K

185,442.04 185.44 K

1055.1%

0 0 K

0%

- Purchase of raw materials

15,377,534 15,378 K

-5.1%

16,198,229 16,198 K

37.4%

11,790,200 11,790 K

-

-

+/- Change in stocks of raw materiels

157,225 157 K

109.4%

-1,664,793 -1,665 K

-470.3%

449,625 450 K

-

-

- Other external purchases and charges

67,770,724 67,771 K

1.4%

66,813,139 66,813 K

12.7%

59,285,083 59,285 K

-

-

Added value

57,769,495 € 57,769 K €

-9.8%

64,075,937 € 64,076 K €

1.9%

62,898,059 € 62,898 K €

14,054,016.67 € 14,054.02 K €

311.1%

68,218 € 68 K €

84583.7%

28.47 % CA 28.47 % CA

-5.4%

30.08 % CA 30.08 % CA

-1.8%

30.63 % CA 30.63 % CA

18.26 % CA 18.26 % CA

55.9%

25.33 % CA 25.33 % CA

12.4%

 

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Sector Average 2017

Sector Median 2017

Added value

57,769,495 € 57,769 K €

-9.8%

64,075,937 € 64,076 K €

1.9%

62,898,059 € 62,898 K €

14,054,016.67 € 14,054.02 K €

311.1%

68,218 € 68 K €

84583.7%

+ Operating grants

2,367 2 K

-61.6%

6,162 6 K

-65.5%

17,864 18 K

-

-

- Tax, duty and similar payments

3,284,549 3,285 K

-10.1%

3,655,389 3,655 K

15.6%

3,161,392 3,161 K

-

-

- Personal charges

36,301,726 36,302 K

8.7%

33,385,498 33,385 K

6.8%

31,245,588 31,246 K

-

-

Gross operating surplus

18,185,587 € 18,186 K €

-32.7%

27,041,212 € 27,041 K €

-5.1%

28,508,943 € 28,509 K €

12,887,987.73 € 12,887.99 K €

41.1%

10,762 € 11 K €

168879.6%

8.96 % CA 8.96 % CA

-29.4%

12.69 % CA 12.69 % CA

-8.6%

13.88 % CA 13.88 % CA

-7.25 % CA -7.25 % CA

223.6%

4.82 % CA 4.82 % CA

85.9%

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Sector Average 2017

Sector Median 2017

Gross operating surplus

18,185,587 € 18,186 K €

-32.7%

27,041,212 € 27,041 K €

-5.1%

28,508,943 € 28,509 K €

12,887,987.73 € 12,887.99 K €

41.1%

10,762 € 11 K €

168879.6%

+ Release of reserves and provisions

3,874,071 3,874 K

-26.1%

5,241,376 5,241 K

92.6%

2,722,078 2,722 K

-

-

+ Other operating income

8,076 8 K

-79.5%

39,355 39 K

-61.0%

100,967 101 K

-

-

- Depreciation/ Amortisation

6,360,737 6,361 K

-3.9%

6,617,862 6,618 K

-24.1%

8,719,261 8,719 K

-

-

- Other charges

320,108 320 K

95.6%

163,664 164 K

-28.8%

229,984 230 K

-

-

Operating result

15,386,889 € 15,387 K €

-39.8%

25,540,417 € 25,540 K €

14.1%

22,382,743 € 22,383 K €

12,831,068.10 € 12,831.07 K €

19.9%

6,114 € 6 K €

251566.5%

7.58 % CA 7.58 % CA

-36.8%

11.99 % CA 11.99 % CA

10.0%

10.90 % CA 10.90 % CA

-7.99 % CA -7.99 % CA

194.9%

2.58 % CA 2.58 % CA

193.8%

 

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Sector Average 2017

Sector Median 2017

Operating result

15,386,889 € 15,387 K €

-39.8%

25,540,417 € 25,540 K €

14.1%

22,382,743 € 22,383 K €

12,831,068.10 € 12,831.07 K €

19.9%

6,114 € 6 K €

251566.5%

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0 0 K

0%

0 0 K

0%

0 0 K

-

-

+ Financial income

246,835 247 K

680.6%

31,622 32 K

-90.3%

327,155 327 K

-

-

- Financial charges

4,704,956 4,705 K

-10.6%

5,265,649 5,266 K

18.8%

4,432,438 4,432 K

-

-

Pre-tax result

10,928,768 € 10,929 K €

-46.2%

20,306,390 € 20,306 K €

11.1%

18,277,460 € 18,277 K €

12,824,207.12 € 12,824.21 K €

-14.8%

5,161 € 5 K €

211656.8%

5.39 % CA 5.39 % CA

-43.4%

9.53 % CA 9.53 % CA

7.1%

8.90 % CA 8.90 % CA

-8.16 % CA -8.16 % CA

166.1%

2.18 % CA 2.18 % CA

147.2%

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Sector Average 2017

Sector Median 2017

Extraordinary income

1,911,799 1,912 K

2.4%

1,867,866 1,868 K

-60.3%

4,709,725 4,710 K

43,004.09 43.00 K

4345.6%

0 0 K

0%

- Extraordinary charges

2,505,487 2,505 K

13.1%

2,215,145 2,215 K

-46.1%

4,110,404 4,110 K

-

-

Extraordinary result

-593,688 € -594 K €

-71.0%

-347,279 € -347 K €

-157.9%

599,321 € 599 K €

-8,155.91 € -8.16 K €

-7179.2%

0 € 0 K €

0%

-0.29 % CA -0.29 % CA

-81.3%

-0.16 % CA -0.16 % CA

-155.2%

0.29 % CA 0.29 % CA

21.80 % CA 21.80 % CA

-101.3%

0.00 % CA 0.00 % CA

0%

 

31/08/2017

Variation

31/08/2016

Variation

31/08/2015

Sector Average 2017

Sector Median 2017

Pre-tax result

10,928,768 € 10,929 K €

-46.2%

20,306,390 € 20,306 K €

11.1%

18,277,460 € 18,277 K €

12,824,207.12 € 12,824.21 K €

-14.8%

5,161 € 5 K €

211656.8%

Extraordinary result

-593,688 € -594 K €

-71.0%

-347,279 € -347 K €

-157.9%

599,321 € 599 K €

-8,155.91 € -8.16 K €

-7179.2%

0 € 0 K €

0%

- Employee profit sharing

458,486 458 K

179.7%

163,931 164 K

-22.0%

210,293 210 K

-

-

- Tax on profits

2,504,242 2,504 K

-59.9%

6,238,897 6,239 K

10.8%

5,631,534 5,632 K

-

-

Net result

7,372,352 € 7,372 K €

-45.6%

13,556,283 € 13,556 K €

4.0%

13,034,954 € 13,035 K €

12,802,049.04 € 12,802.05 K €

-42.4%

5,243 € 5 K €

140513.2%

3.63 % CA 3.63 % CA

-42.9%

6.36 % CA 6.36 % CA

0.2%

6.35 % CA 6.35 % CA

10.45 % CA 10.45 % CA

-65.3%

2.11 % CA 2.11 % CA

72.0%

 

 

Key Performance Indicators

 

Find below a comparison of the company based on the industry code (primary) with other companies from the same industry. The following analysis has been based on the industry code 4771Z - Retail sale of clothing in specialised stores.

Key Performance Indicators

Graphical analysis

Net Turnover

Net TurnoverCompany ResultSector Average31/08/201731/08/201631/08/20150M100M200M300M

31/08/2017

31/08/2016

31/08/2015

Company Result

202,887,029 €

213,035,919 €

205,345,125 €

Sector Average

56,978,461 €

1,370,231 €

1,403,396 €

Net Profit

 

31/08/2017

31/08/2016

31/08/2015

Company Result

7,372,352 €

13,556,283 €

13,034,951 €

Sector Average

5,704 €

10,221 €

7,140 €

Net Export Turnover

 

31/08/2017

31/08/2016

31/08/2015

Company Result

25,837,503 €

27,939,719 €

25,934,487 €

Sector Average

80,917 €

92,946 €

92,705 €

Account Total

 

31/08/2017

31/08/2016

31/08/2015

Company Result

191,275,174 €

186,260,634 €

162,340,482 €

Sector Average

1,194,241 €

951,126 €

999,149 €

Shareholders Equity

 

31/08/2017

31/08/2016

31/08/2015

Company Result

72,735,712 €

65,401,848 €

51,892,471 €

Sector Average

453,907 €

367,522 €

357,471 €

Liabilities

 

31/08/2017

31/08/2016

31/08/2015

Company Result

117,516,425 €

118,984,338 €

109,069,960 €

Sector Average

730,403 €

571,192 €

627,022 €

Need background in operating working capital

 

31/08/2017

31/08/2016

31/08/2015

Company Result

5 €

7 €

11 €

Sector Average

27 €

53 €

46 €

Gross operating surplus (EBE)

 

31/08/2017

31/08/2016

31/08/2015

Company Result

18,185,587 €

27,041,212 €

28,508,943 €

Sector Average

12,887,988 €

64,106 €

69,526 €

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

INR 65.02

UK Pound

1

INR 90.12

Euro

1

INR 80.91

Euro

1

INR 80.13

 

Note : Above are approximate rates obtained from sources believed to be correct

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

PRI

 

 

Report Prepared by :

KET

                                                


 

RATING EXPLANATIONS

 

Credit Rating

Explanation

Rating Comments

A++

Minimum Risk

Business dealings permissible with minimum risk of default

A+

Low Risk

Business dealings permissible with low risk of default

A

Acceptable Risk

Business dealings permissible with moderate risk of default

B

Medium Risk

Business dealings permissible on a regular monitoring basis

C

Medium High Risk

Business dealings permissible preferably on secured basis

D

High Risk

Business dealing not recommended or on secured terms only

NB

New Business

No recommendation can be done due to business in infancy stage

NT

No Trace

No recommendation can be done as the business is not traceable

 

NB is stated where there is insufficient information to facilitate rating. However, it is not to be considered as unfavourable.

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors are as follows:

 

·         Financial condition covering various ratios

·         Company background and operations size

·         Promoters / Management background

·         Payment record

·         Litigation against the subject

·         Industry scenario / competitor analysis

·         Supplier / Customer / Banker review (wherever available)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.