MIPL-Logo

3decades

 

MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

498634 

Report Date :

27.03.2018

 

 

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

LE TANNEUR ET CIE

 

 

Registered Office :

Le Tanneur, 128 130, 128 Quai De Jemmapes, 75010 Paris

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2016

 

 

Date of Incorporation :

November 1997

 

 

Com. Reg. No.:

RCS Paris B 414 433 797

 

 

Legal Form :

Public Limited Company With Board Of Directors

 

 

Line of Business :

Wholesale Trade (Business-to-Business) of Other Household Goods (4649Z)

 

 

No. of Employees :

177 [2016]

 

 

RATING & COMMENTS

(Mira Inform has adopted New Rating mechanism w.e.f. 23rd January 2017)

 

MIRA’s Rating :

A

 

Credit Rating

 

Explanation

Rating Comments

A

Acceptable Risk

Business dealings permissible with moderate risk of default

 

Status :

Satisfactory

 

 

Payment Behaviour :

Slow but correct

 

 

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List

 

Country Name

Previous Rating

(30.09.2017)

Current Rating

(31.12.2017)

France

A1

A1

 

Risk Category

 

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low Risk

 

A2

Moderately Low Risk

 

B1

Moderate Risk

 

B2

Moderately High Risk

 

C1

High Risk

 

C2

Very High Risk

 

D

 


 

FRANCE - ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. France is the most visited country in the world with 83 million foreign tourists in 2016, including 530,000 visitors for the 2016 Euro Cup. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that mitigate economic inequality.

 

France's real GDP grew by 1.6% in 2017, up from 1.2% the year before. The unemployment rate (including overseas territories) increased from 7.8% in 2008 to 10.2% in 2015, before falling to 9.5% in 2017. Youth unemployment in metropolitan France decreased from 24.6% in the fourth quarter of 2014 to 24% in the fourth quarter of 2016.

 

France’s public finances have historically been strained by high spending and low growth. Despite measures to restore public finances, the budget deficit rose from 3.3% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009. In 2017, the budget deficit improved to 2.9% of GDP, bringing it in compliance with the EU-mandated 3% deficit target. Meanwhile, France's public debt rose from 89.5% of GDP in 2012 to 96.9% in 2017.

 

Since entering office in May 2017, President Emmanuel MACRON launched a series of economic reforms to improve competitiveness and boost economic growth. President MACRON campaigned on reforming France’s labor code and in late 2017 implemented a range of reforms to increase flexibility in the labor market by making it easier for firms to hire and fire and simplifying negotiations between employers and employees. In addition to labor reforms, President MACRON’s proposed 2018 budget cuts public spending, taxes, and social security contributions to spur private investment and increase purchasing power.

 

Source : CIA

 

 


Company summary

 

SIRET

414 433 797 00506

Name

LE TANNEUR ET CIE

Acronym

-

Trade name

LE TANNEUR

Status

Economically active

Postal Address

LE TANNEUR ET CIE
LE TANNEUR
128 130
128 QUAI DE JEMMAPES
75010 PARIS
FRANCE

Share Capital

12,144,192 Euros

Telephone

01 44 72 40 00

Activity (APE)

Wholesale trade (business-to-business) of other household goods (4649Z)

RCS Registration

RCS Paris B 414 433 797

Formation Date

11/1997

EUR VAT Number

FR23414433797

Deregistration Date

-

Last account Date

31/12/2016

Court Registry Number

19 9 8B10944

Incorporation Date

04/1998

Registration Court

Paris (75)

Fax

01 44 72 40 49

Nationality

France

Legal form

Public Limited Company With Board Of Directors

Currency

Euros

 

 

Key Financials

 

YEAR TO DATE

TURNOVER

GROSS OPERATING SURPLUS

SHAREHOLDER'S EQUITY

NET RESULT

EMPLOYEES

31/12/2016

25,681,407 €

-2.78% Turnover

6,540,991 €

-388,990 €

177 employees

31/12/2014

28,976,852 €

-5.82% Turnover

8,813,118 €

-442,412 €

217 employees

31/12/2013

30,451,383 €

-7.08% Turnover

9,255,530 €

-379,807 €

2 employees

 

Directors

Current Directors

9

 

Ultimate Holding Company

Name

Country

Company Number

TOLOMEI PARTICIPATIONS

452794811

Affiliation links.

1 company in 1 country.

 

Judgment and Preferential

Judgment

No judgement

 

Preferential Right

Collection of preferential rights for this company has been stopped by the Court

 

 

Establishment Details

 

Type of Establishment

Head Office

Production Role

-

APE/NAF Code

1512Z

Activity

Manufacture of travel goods, leather goods and saddlery

Formation Date

06/2011

Reason for Formation

Formation

Closure Date

-

Reason for Closure

-

Reactivation Date

-

Seasonality

-

Activity Nature

Services

Activity Location

Office

Trading Address

128 QUAI DE JEMMAPES 
75010 PARIS 10

Department

Paris (75)

Location Surface

-

District

1

City

PARIS 10

Status

Economically active

Business Pages FT®

MAROQUINERIE ET ARTICLES DE VOYAGE (DETAIL)

Region

Ile-de-France

Area

-

Size of Urban Area

Paris conglomeration

 

Ultimate Parent(s)

1 ultimate parent company/companies for this company

Company Name

Activity (APE)

APE/NAF Code

City

Post Code

TOLOMEI PARTICIPATIONS

Activities of holding companies

6420Z

PARIS 2

75002

 

Other Establishment(s)

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas having at least 50% of workforce in same area

Mono-activity status

Legal unit with multiple establishments having main activities in many divisions, which one activity grouping from 50 to 80% of workforce

Branches

35 branch entities in this company

 

Company Name

Company Type

APE/NAF Code

Activity

City

Post Code

LE TANNEUR ET CIE

Head Office

4649Z

Wholesale trade (B2B) of other household goods

PARIS 10

75010

LE TANNEUR ET CIE

Branch

4649Z

Wholesale trade (B2B) of other household goods

BELLEY

01300

LE TANNEUR ET CIE

Branch

4649Z

Wholesale trade (B2B) of other household goods

NICE

06000

LE TANNEUR ET CIE

Branch

4649Z

Wholesale trade (B2B) of other household goods

MARSEILLE 1

13001

LE TANNEUR ET CIE

Branch

4649Z

Wholesale trade (B2B) of other household goods

MARSEILLE 1

13001

 

Workforces

Workforce at address

50 to 99 employees

Company workforce

200 to 249 employees

 

 

Workforce account

100 to 199 employees

 

 

31/12/2016

 

 

 

Commentary

 

The comments are ordered according to the class of risk. Companies are compared with regard to other companies of the same type. Thus a positive comment for one category can be negative for another or can change depending on its value. This is a purely statistical decision.

 

The company has 11 directors

The decrease in the gearing percentage over the last two accounting periods is 45 %

Department code with low risk rating

Industry code with low risk rating

The creditor days are 53.89

The total assets are 27,884,835 €

The shareholder's equity is 6,540,991 €

The liabilities are 21,122,589 €

The ratio total assets to total liabilities is 1.31

The risk provisions are 221,155 €

The net current assets are 16,058,482 €

The net turnover is 25,681,407 €

High risk workforce size

The sales to current assets ratio is 1.60

The pre-tax profit is -493,611 €

The stock to turnover ratio is 34.72

The return on total assets employed is -2

 

Industry comparison

Activity (APE)

Wholesale trade (business-to-business) of other household goods (4649Z)

 

Collective procedures

No judgment information for the company

 

Preferential rights details and history

Summary of preferential rights

Company monitored since

13/12/2010

Monitored stopped since

13/12/2011

Status of Monitoring

Collection of preferential rights for this company has been stopped by the Court

 

Group Data

Parent

QATAR LUXURY GROUP S.P.C

Direct parent

QATAR LUXURY GROUP - FASHION S.P.C. - 42.6 %

Group – Number of companies

10

Linkages – Number of companies

1

Number of countries

1

Ultimate parent company

TOLOMEI PARTICIPATIONS

Direct parent

TOLOMEI PARTICIPATIONS - 50.22 %

Group – Number of companies

4

Linkages – Number of companies

1

Number of countries

1

 

 

 

NAME

SIREN

PARTS

LAST ACCOUNT PUBLISHED

1

QATAR LUXURY GROUP S.P.C

-

-

-

2

QATAR LUXURY GROUP - FASHION S.P.C.

-

100 %

-

3

LE TANNEUR ET CIE

414433797

42.60 %

31/12/2016

4

SOPADIMA FAR EAST

-

100 %

-

4

MAROQUINERIE DES ORGUES

523967198

100 %

31/12/2016

5

SOMACAP

-

99.90 %

-

3

LE TANNEUR INTERNATIONAL S.P.C.

-

100 %

-

4

LE TANNEUR CHINE CO LTD

-

100 %

-

LE TANNEUR INTERNATIONAL JAPAN K.K.

-

100 %

-

LE TANNEUR INTERNATIONAL BELGIUM SA

861093645

100 %

31/12/2016

 

Shareholders

Type of shareholders

Company: 92.82%Undefined: 7.18%CompanyUndefined

 

Shareholders

QATAR LUXURY GROUP - FASH...: 42.6%TOLOMEI PARTICIPATIONS: 50.22%Undefined: 7.18%QATAR LUXURY GROUP - FASHION S.P.C.TOLOMEI PARTICIPATIONSUndefined

Linkages

COMPANY NAME

SIREN

LAST ACCOUNT PUBLISHED

TURNOVER

LE TANNEUR INTERNATIONAL SPC

-

-

-

 

Director(s)

Name

AL NASR FALEH

Manager position

Administrator

Date of birth

01/11/1987

Place of birth

DOHA(QATAR)

Type

Individual

Name at birth

Name

ALI REZA

Manager position

Administrator

Date of birth

30/10/1982

Place of birth

LONDRES(ROYAUME-UNI)

Type

Individual

Name at birth

 

Name

M. DAILEY ERIC

Manager position

Administrator, Chairman of the Board, Managing director

Date of birth

23/05/1962

Place of birth

NEUILLY-SUR-SEINE

Type

Individual

Name at birth

Name

Mme. MOTTET LAURENCE

Manager position

Administrator

Date of birth

27/11/1964

Place of birth

BOURG-DE-PÉAGE

Type

Individual

Name at birth

MARTIN

 

Name

Mme. STAHLIE SUZANNE

Manager position

Administrator

Date of birth

12/10/1972

Place of birth

LA PAZ(MEXIQUE)

Type

Individual

Name at birth

 

Statutory Auditor

Name

MGF AUDIT

Name of representative

Manager position

Deputy auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

Name

IN EXTENSO IDF AUDIT

Name of representative

Manager position

Statutory auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

Name

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Name of representative

Manager position

Statutory auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

Name

AUDITEX

Name of representative

Manager position

Deputy auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

Previous Directors

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

President

Mme. AL-THANI NOOR

04/02/1982 - DOHA(QATAR)

Chairman of the Board

M. COUILLARD GREGORY

25/08/1972 - TOURS (37000)

Chairman of the Board

M. DOBASHI MOHAMED

10/10/1968 - SANA A(YEMEN)

Chairman of the Board

M. LE BRAS JEAN-FRANÇOIS

14/09/1955 - BREST (29200)

Chief Executive Officer

DESCOTTES HERVÉ

10/08/1946 - MONTREUIL SUR ILLE (35)

Chief Executive Officer

DESCOTTES HERVÉ

10/08/1946 - MONTREUIL SUR ILLE (35)

Chief Executive Officer

DESCOTTES HERVÉ

10/08/1946 - MONTREUIL SUR ILLE (35)

Managing director

M. CLENET JEAN

19/07/1956 - LE LOROUX-BOTTEREAU

Managing director

M. CLENET JEAN

19/07/1956 - LE LOROUX-BOTTEREAU (44430)

Managing director

M. DESCOTTES HERVE

10/08/1946 - MONTREUIL SUR ILLE (35)

Managing director

M. DESCOTTES HERVÉ

10/08/1946 - MONTREUIL SUR ILLE (35)

Managing director

M. DESCOTTES HERVÉ

10/08/1946 - MONTREUIL SUR ILLE (35)

Administrator

BRUN RENÉ

16/06/1931 - BORT LES ORGUES (19)

Administrator

BRUN RENÉ

16/06/1931 - BORT LES ORGUES (19)

Administrator

BRUN RENÉ

16/06/1931 - BORT LES ORGUES (19)

Administrator

M. BRUN RENE

-

Administrator

M. CALMELS DIDIER

-

Administrator

DESCOTTES JOCELYNE

01/01/1949 - BOULOGNE BILLANCOURT (92)

Administrator

DESCOTTES JOCELYNE

01/01/1949 - BOULOGNE BILLANCOURT (92)

Administrator

M. DESCOTTES HERVÉ

10/08/1946 - MONTREUIL-SUR-ILLE

Administrator

M. DESCOTTES HERVÉ

10/08/1946 - MONTREUIL-SUR-ILLE (35440)

Administrator

Mme. DESCOTTES JOCELYNE

01/01/1949 - BOULOGNE BILLANCOURT (92)

Administrator

Mme. DESIGNORI HELENA

12/09/1964 - HARBOROUGH MAGNA(ROYAUME-UNI)

Administrator

FAUQUEUR ALAIN

08/04/1946 - PARIS 12 (75)

Administrator

FAUQUEUR ALAIN

08/04/1946 - PARIS 12 (75)

Administrator

FAUQUEUR ALAIN

08/04/1946 - PARIS 12 (75)

Administrator

M. LE BRAS JEAN-FRANCOIS

14/09/1955 - BREST (29200)

Administrator

Mme. MOULON PATRICIA

27/09/1971 - BELLEY

Administrator

Mme. MOULON PATRICIA

27/09/1971 - BELLEY (01300)

Administrator

M. PECENKA THOMAS

07/06/1980 - VIENNE(AUTRICHE)

 

Status history

No Status History

 

 

Recent publications in Gazettes

 

Publication date

Gazette Name

Description

13/02/2018

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1529 - 414 433 797 RCS Paris. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Capital : 12144192 EUR. Activité : 
Adresse du siège social : 128-130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

23/01/2018

JAL

Modification of the share capital

Les Echos


Date de décision : 30/11/2017
La société : 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, 119 QUAI DE VALMY, 117-119, 75010 PARIS 10 a subi une augmentation de son capital social désormais de 12 144 192 € 

02/11/2017

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1025 - 414 433 797 RCS Paris. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Administration : Président du conseil d'administration partant : Dobashi, Mohamed, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Dailey, Eric, Directeur général partant : Clenet, Jean, Administrateur partant : Descottes, Hervé, Administrateur partant : Moulon, Patricia, nomination de l'Administrateur : Al Nasr, Faleh, nomination de l'Administrateur : Ali, Reza, nomination de l'Administrateur : Dailey, Eric, nomination de l'Administrateur : Martin, nom d'usage : Mottet, Laurence, nomination de l'Administrateur : Stahlie, Suzanne. Capital : 8602136 EUR. Activité : 
Adresse du siège social : 128-130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration.

03/08/2017

Bodacc C

Comptes consolidés et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

6177 - 414433797 RCS. LE TANNEUR & CIEForme : Société anonyme. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes 75010 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2016.

20/07/2017

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

5693 - 414433797 RCS. LE TANNEUR & CIEForme : Société anonyme. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes 75010 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2016.

07/09/2016

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

4943 - 414433797 RCS. LE TANNEUR & CIEForme : Société anonyme. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes 75010 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2015.

07/09/2016

Bodacc C

Comptes consolidés et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

4942 - 414433797 RCS. LE TANNEUR & CIEForme : Société anonyme. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes 75010 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2015.

02/09/2016

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1854 - 414 433 797 RCS Paris. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDUCIAIRE LEYDET, Commissaire aux comptes titulaire partant : AFIGEC AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE - Société à responsabilité limitée, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO IDF AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes suppléant partant : Giraud, Yannis, Commissaire aux comptes suppléant partant : Lemaitre, Benoit, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : MGF AUDIT. Capital : 4282136 EUR. Activité : 
Adresse du siège social : 128-130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

15/11/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

680 - 414 433 797 RCS Paris. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Administration : Administrateur partant : Designori, Helena. Capital : 4282136 EUR. Activité : 
Adresse du siège social : 128-130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

11/11/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1867 - 414 433 797 RCS Paris. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Administration : Président partant : Al-Thani, Noor, nomination du Président du conseil d'administration : Dobashi, Mohamed. Capital : 4282136 EUR. Activité : 
Adresse du siège social : 128-130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

08/10/2015

JAL

Appointment of the social representative

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 27/05/2015
Société faisant l'objet d'une nomination : 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, LE TANNEUR, 128 QUAI DE JEMMAPES, 128-130, 75010 PARIS 10 
Nominé : Monsieur Mohamed DOBASHI, 15604 DOHA
En la fonction de : Président du Conseil d'Administration
Nominé : Monsieur Mohamed DOBASHI, 15604 DOHA
En la fonction de : Administrateur

08/10/2015

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 27/05/2015
La société 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, LE TANNEUR, 128 QUAI DE JEMMAPES, 128-130, 75010 PARIS 10 
Fait l'objet du départ de Madame Helena DESIGNORI

28/07/2015

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

8717 - 414433797 RCS. LE TANNEUR & CIEForme : Société anonyme. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes 75010 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2014.

28/07/2015

Bodacc C

Comptes consolidés et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

8716 - 414433797 RCS. LE TANNEUR & CIEForme : Société anonyme. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes 75010 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2014.

23/04/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1110 - 414 433 797 RCS Paris. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Clari, Evelyne, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lemaitre, Benoit. Capital : 4282136 EUR. Activité : 
Adresse du siège social : 128-130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

23/04/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1119 - 414 433 797 RCS Paris. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Administration : Président du conseil d'administration partant : Le Bras, Jean-François, nomination du Président : Al-Thani, Noor, Administrateur partant : Pecenka, Thomas, nomination de l'Administrateur : Designori, Helena. Capital : 4282136 EUR. Activité : 
Adresse du siège social : 128-130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

08/04/2015

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

74 - HAUTE-SAVOIE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

950 - 414 433 797 RCS Paris. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société Anonyme à Conseil d'Administration. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 280000 EUR. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : La vente au détail d'articles de maroquinerie et de textiles. Adresse : 27 rue Vaugelas, 74000 Annecy. 
Précédent propriétaire : R.L.G. 491 670 972 RCS Chambéry. 
Date de commencement de l’activité : 02/03/2015. Publication légale : Hebdo des Savoie du 19/03/2015. Oppositions : au siège du fonds cédé pour la validité auprès de la SCP MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats, 45 rue Sommeiller 74000 ANNECY et pour la correspondance au Cabinet LEXALP, avocats, SCP BOISSON ET ASSOCIES, 121 allée Albert Sylvestre 73000 CHAMBERY. Descriptif : Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

03/04/2015

JAL

Appointment of the social representative

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 03/12/2014
Société faisant l'objet d'une nomination : 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, LE TANNEUR, 128 QUAI DE JEMMAPES, 128-130, 75010 PARIS 10 
Nominé : Madame Noor AL-THANI, DOHA
En la fonction de : Président du Conseil d'Administration
Nominé : Madame Noor AL-THANI, DOHA
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Madame Helena DESIGNORI, DOHA
En la fonction de : Administrateur

03/04/2015

JAL

End of rent-management

Echos Judiciaires Girondins (Les)


Date de décision : 19/12/2014
Locataire gérant : 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, LE TANNEUR, 128 QUAI DE JEMMAPES, 128-130, 75010 PARIS 10
Date d’effet : 19/12/2014

03/04/2015

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 03/12/2014
La société 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, LE TANNEUR, 128 QUAI DE JEMMAPES, 128-130, 75010 PARIS 10 
Fait l'objet du départ de Monsieur Jean-François LEBRAS, Umm Bab Tow/er appartement A6-23, DOHA, 
De Monsieur Thomas PECENKA, 
De Monsieur Jean-François LE BRAS, Umm Bab Tow/er appartement A6-23, DOHA

19/03/2015

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Hebdo des Savoie (L')


Date de décision : 27/02/2015 
Cédant : 491670972 - R.L.G., JONAK, 10 RUE DE BOIGNE, 73000 CHAMBERY
Cessionnaire : 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, LE TANNEUR, 128 QUAI DE JEMMAPES, 128-130, 75010 PARIS 10
Prix de vente : 280000 €
Date d’effet : 02/03/2015 

23/01/2015

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

33 - GIRONDE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

247 - 414 433 797 RCS Paris. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Capital : 4282136 EUR. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 406000 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : commerce de vente au détail d'articles de maroquinerie et notamment de produits aux marques le tanneur et Soco. Adresse : 9 cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux. 
Précédent propriétaire : SARL LES ANGES. 441 402 955 RCS Bordeaux. 
Date de commencement de l’activité : 19/12/2014. Publication légale : Les Echos Judiciaires Girondins du 16/01/2015. Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance TAJ 19 Boulevard Alfred Daney BP 80105 33041 BORDEAUX CEDEX. Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

20/01/2015

JAL

Start of rent-management

Echos Judiciaires Girondins (Les)


Date de décision : 20/01/2015 
Bailleur : 441402955 - LES ANGES, LE TANNEUR, 9 CRS DE L INTENDANCE, 33000 BORDEAUX
Locataire gérant : 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, LE TANNEUR, 128 QUAI DE JEMMAPES, 128-130, 75010 PARIS 10
Date d’effet : 01/10/2014 
pour une durée de 3 mois 

16/01/2015

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Echos Judiciaires Girondins (Les)


Date de décision : 19/12/2014 
Cédant : 441402955 - LES ANGES, LE TANNEUR, 9 CRS DE L INTENDANCE, 33000 BORDEAUX
Cessionnaire : 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, LE TANNEUR, 128 QUAI DE JEMMAPES, 128-130, 75010 PARIS 10
Prix de vente : 406000 €
Date d’effet : 19/12/2014 

19/10/2014

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1075 - 414 433 797 RCS Paris. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Administration : Président du conseil d'administration partant : Couillard, Gregory, modification du Président du conseil d'administration Le Bras, Jean-Francois. Capital : 4282136 EUR. Activité : 
Adresse du siège social : 128-130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

03/10/2014

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 03/09/2014
La société 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, LE TANNEUR, 128 QUAI DE JEMMAPES, 128-130, 75010 PARIS 10 
Fait l'objet du départ de Monsieur Gregory COUILLARD, West Bay Lagoon Compound 11 Villa 2 PO Box, 15604, DOHA, 
De Monsieur Gregory COUILLARD, West Bay Lagoon Compound 11 Villa 2 PO Box, 15604, DOHA

03/10/2014

JAL

Appointment of the social representative

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 03/09/2014
Société faisant l'objet d'une nomination : 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, LE TANNEUR, 128 QUAI DE JEMMAPES, 128-130, 75010 PARIS 10 
Nominé : Monsieur Jean François LEBRAS
En la fonction de : Président du Conseil d'Administration

12/08/2014

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

2403 - 414 433 797 RCS Paris. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Administration : nomination de l'Administrateur : Moulon, Patricia. Capital : 4282136 EUR. Activité : 
Adresse du siège social : 128-130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

05/08/2014

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

4688 - 414433797 RCS. LE TANNEUR & CIEForme : Société anonyme. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes 75010 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2013.

05/08/2014

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

4689 - 414433797 RCS. LE TANNEUR & CIEForme : Société anonyme. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes 75010 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2013.

24/07/2014

JAL

Appointment of the social representative

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 03/06/2014
Société faisant l'objet d'une nomination : 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, LE TANNEUR, 128 QUAI DE JEMMAPES, 128-130, 75010 PARIS 10 
Nominé : Madame Patricia MOULON, 01300 BELLEY
En la fonction de : Administrateur

25/03/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

44 - LOIRE-ATLANTIQUE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

268 - Réctificatif. 
Parution avis précédent : BODACC A. Numéro de parution : Date de parution : 9 mars 2014. Numéro d’annonce : 386. Cet avis est annulé et remplacé par le suivant. 
414 433 797 RCS Nantes. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Capital : 4282.14 EUR. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Achat au prix stipulé de 565000,00 euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : vente d'articles de maroquinerie. Enseigne : Le Tanneur. Adresse : 14 rue Santeuil, 1 rue du Puits d'Argent, 20 et 22 rue de la Fosse, 44000 Nantes. 
Précédent propriétaire : SOKADE. 512 028 853 RCS Nantes. 
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Publication légale : Ouest France du 22/02/2014. Oppositions : Cabinet Saje 1 bis rue Robert Schuman BP 137 44403 Reze Cedex pour la validité. Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

21/03/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

33 - GIRONDE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

225 - Réctificatif. 
Parution avis précédent : BODACC A. Numéro de parution : Date de parution : 6 mars 2014. Numéro d’annonce : 136. Cet avis est annulé et remplacé par le suivant. 
414 433 797 RCS Bordeaux. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Capital : 4282136 EUR. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 340000 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : vente d'articles de maroquinerie. Adresse : avenue des Quarante Journaux, Centre Commercial Auchan, 33000 Bordeaux. 
Précédent propriétaire : SOKADE. 512 028 853 RCS Niort. 
Date de commencement de l’activité : 01/02/2014. Publication légale : Les Echos Judiciaires Girondins du 25/02/2014. Oppositions : Au Mandataire CABIENT SAJE 19 Avenue Henri Becquerel Parc d'Activités Kennedy 33700 MERIGNAC pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

16/03/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

24 - DORDOGNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX

115 - 414 433 797 RCS Paris. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Capital : 4282136 EUR. Adresse : 128/130 quai de Jemmapes, 75010 Paris 10. 
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 195000 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : un fonds de commerce de ventes d'articles de maroquinerie exploité sous l'enseigne LE TANNEUR, dans le cadre d'un contrat de commission. Adresse : 19 rue Taillefer, 24000 Périgueux. 
Précédent propriétaire : SOKADE. 512 028 853 RCS Niort. 
Date de commencement de l’activité : 01/02/2014. Publication légale : Sud Ouest du 22/02/2014 et du 26/02/2014. Oppositions : SCP L RODRIGUEZ et G PEYS, huissiers de justice, 25 rue Louis Mie 24000 Périgueux BP 7041 24000 Périgueux. Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

11/03/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

49 - MAINE-ET-LOIRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS

610 - 414 433 797 RCS Paris. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Adresse : 128 - 130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 250000 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : un fonds de commerce de vente d'articles de maroquinerie connu sous l'enseigne LE TANNEUR dans le cadre d'un contrat de commission affiliation. Adresse : 187 rue Corneille, et 23 rue Voltaire, 49100 Angers. 
Précédent propriétaire : SOKADE. 512 028 853 RCS Niort. 
Date de commencement de l’activité : 01/02/2014. Publication légale : le courrier de l'ouest du 22/02/2014. Oppositions : Cabinet SAJE 18 rue Bouché Thomas - TSA 31229 - 49012 Angers cédex 1. Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

09/03/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

44 - LOIRE-ATLANTIQUE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

386 - 414 433 797 RCS Nantes. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Capital : 4282.14 EUR. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Achat au prix stipulé de 565000,00 euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : vente d'articles de maroquinerie. Enseigne : Le Tanneur. Adresse : 14 rue Santeuil, 1 rue du Puits d'Argent, 20 et 22 rue de la Fosse, 44000 Nantes. 
Précédent propriétaire : SOKADE. 512 028 853 RCS Nantes. 
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Publication légale : Ouest France du 22/02/2014. Oppositions : Cabinet Saje 1 bis rue Robert Schuman BP 137 44403 Reze Cedex pour la validité. Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

06/03/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

33 - GIRONDE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

136 - 414 433 797 RCS Bordeaux. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Capital : 4282136 EUR. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 340000 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : vente d'articles de maroquinerie. Adresse : avenue des Quarante Journaux, Centre Commercial Auchan, 33000 Bordeaux. 
Précédent propriétaire : SOKADE. 512 028 853 RCS Niort. 
Date de commencement de l’activité : 01/02/2014. Publication légale : Les Echos Judiciaires Girondins du 25/02/2014. Oppositions : Au Mandataire CABIENT SAJE 19 Avenue Henri Becquerel Parc d'Activités Kennedy 33700 MERIGNAC pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

22/02/2014

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Ouest France/Edition Loire Atlantique


Date de décision : 07/02/2014 
Cédant : 512028853 - SOKADE, 9 RUE MARTIN LUTHER KING, ESPACE MENDES FRANCE, 79000 NIORT
Cessionnaire : 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, 128 QUAI DE JEMMAPES, 128-130, 75010 PARIS 10
Prix de vente : 565000 €
Date d’effet : 01/02/2014 

22/02/2014

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Sud Ouest/Edition de Périgueux


Date de décision : 01/02/2014 
Cédant : 512028853 - SOKADE, 9 RUE MARTIN LUTHER KING, ESPACE MENDES FRANCE, 79000 NIORT
Cessionnaire : 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, 128 QUAI DE JEMMAPES, 128-130, 75010 PARIS 10
Prix de vente : 195000 €
Date d’effet : 01/02/2014 

26/08/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

5089 - 414433797 RCS. LE TANNEUR & CIEForme : Société anonyme. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes 75010 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2012.

19/08/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

8540 - 414433797 RCS. LE TANNEUR & CIEForme : Société anonyme. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes 75010 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2012.

11/08/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1955 - 414 433 797 RCS Paris. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Capital : 4282136 EUR. Activité : 
Adresse du siège social : 128-130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

24/07/2013

JAL

Modification of the share capital

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 26/03/2013
La société : 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, 128 QUAI DE JEMMAPES, 128-130, 75010 PARIS 10 a subi une augmentation de son capital socialdésormais de 4 282 136 € 
Date d'effet : 31/03/2010

06/03/2013

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

35 - ILLE-ET-VILAINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

245 - 414 433 797 RCS Rennes. LE TANNEUR CIE. Forme : Société anonyme. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 235000 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : la vente au détail de tous objets en cuir, de maroquinerie, articles de mode, articles de voyages et produits dérivés et accessoires. Adresse : 1 rue de la Monnaie, 35000 Rennes. 
Précédent propriétaire : VARIATIONS. 403 276 900 RCS Rennes. 
Date de commencement de l’activité : 01/01/2013. Publication légale : Le journal de Vitré du 04/01/2013. Oppositions : Cabinet Portier-Collet-Verdier 3 allée Francis Charpentier 35000 Rennes pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

23/01/2013

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

35 - ILLE-ET-VILAINE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

395 - 414 433 797 RCS Rennes. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Capital : 4224759 EUR. Adresse : 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 235000 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : articles de maroquinerie, bagages, accessoires de mode (branche d'activité). Adresse : 1 rue de la Monnaie, 35000 Rennes. 
Précédent propriétaire : VARIATIONS. 403 276 900 RCS Rennes. 
Date de commencement de l’activité : 01/01/2013. Publication légale : Le journal de Vitré du 04/01/2013. Oppositions : Au Mandataire Cabinet PORTIER COLLET, 3 allée Francis Charpentier, 35000 Rennes pour la validité et pour la correspondance Cabinet PORTIER COLLET 3 Allée Francis Charpentier 35000 RENNES. Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

04/01/2013

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Journal de Vitré (Le)


Date de décision : 28/12/2012 
Cédant : 403276900 - VARIATIONS, LE TANNEUR, 1 RUE DE LA MONNAIE, 35000 RENNES
Cessionnaire : 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, LE TANNEUR ET SOCO, 128 QUAI DE JEMMAPES, 128-130, 75010 PARIS 10
Prix de vente : 235000 €
Date d’effet : 01/01/2013 

05/10/2012

JAL

Start of rent-management

Courrier Français/Edition de la Gironde


Date de décision : 13/09/2012 
Bailleur : 441402955 - LES ANGES, LE TANNEUR, 9 CRS DE L INTENDANCE, 33000 BORDEAUX
Locataire gérant : 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, 128 QUAI DE JEMMAPES, 128-130, 75010 PARIS 10
Date d’effet : 01/10/2012 
pour une durée de 2 mois 

20/08/2012

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

8903 - 414433797 RCS. LE TANNEUR & CIEForme : Société anonyme. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes 75010 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011.

20/08/2012

Bodacc C

Comptes annuels, consolidés et rapports

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

8904 - 414433797 RCS. LE TANNEUR & CIEForme : Société anonyme. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes 75010 Paris. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011.

16/03/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

1274 - 414 433 797 RCS Paris. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Administration : nomination du Directeur général : Clenet, Jean, modification de l'Administrateur Descottes, Hervé. Capital : 4224759 EUR. Activité : 
Adresse du siège social : 128-130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

05/03/2012

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 06/02/2012
La société 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, 128 QUAI DE JEMMAPES, 128-130, 75010 PARIS 10 
Fait l'objet du départ de Monsieur Hervé DESCOTTES

05/03/2012

JAL

Appointment of the social representative

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 06/02/2012
Société faisant l'objet d'une nomination : 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, 128 QUAI DE JEMMAPES, 128-130, 75010 PARIS 10 
Nominé : Monsieur Jean CLENET, 01300 BELLEY
En la fonction de : Directeur général

21/09/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

75 - PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

740 - 414 433 797 RCS Paris. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Administration : Président du conseil d'administration : Couillard, Gregory, Directeur général : Descottes Herve, , Administrateur : Le Bras, Jean-Francois, Administrateur : Pecenka, Thomas, Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE LEYDET - Société anonyme de presse, Commissaire aux comptes titulaire : AFIGEC AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE - Société à responsabilité limitée, Commissaire aux comptes suppléant : Clari, Evelyne, Commissaire aux comptes suppléant : Giraud, Yannis. Capital : 4224759 EUR. Adresse : 128-130 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Origine du fonds : Fonds acquis par achat. Etablissement : Etablissement complémentaire. Adresse : 
A dater du : 16/04/1998. Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Publication légale : LA VIE CORREZIENNE du 03/07/1998. Oppositions : Au fonds. Descriptif : Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

11/08/2011

JAL

Head Office Transfer

Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France


Date de décision : 15/06/2011
Transfert du siège social de la société 414433797 -  LE TANNEUR ET CIE 
Adresse du nouveau siège : 128-130 Quai de Jemmapes, 75010 PARIS 10
Ancienne localisation : 1028 AV DE LA GARE, 19110 BORT LES ORGUES
Date d'effet : 15/06/2011

10/08/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

19 - CORREZE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

324 - 414 433 797 RCS Brive. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Administration : Directeur général : DESCOTTES Hervé modification le 27 Juin 2011 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE LEYDET modification le 02 Août 2011 Président du conseil d'administration : COUILLARD Gregory en fonction le 27 Juin 2011 Administrateur : LE BRAS Jean-Francois en fonction le 27 Juin 2011 Administrateur : PECENKA Thomas en fonction le 27 Juin 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CLARI Evelyne en fonction le 02 Août 2011 Commissaire aux comptes titulaire : AFIGEC AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE en fonction le 02 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : GIRAUD Yannis en fonction le 02 Août 2011. Activité : 
Commentaires : Modification de représentant.

05/07/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

19 - CORREZE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

364 - 414 433 797 RCS Brive. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Administration : Directeur général : DESCOTTES Hervé modification le 27 Juin 2011 Commissaire aux comptes titulaire : SPITZ OLLIVIER & ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE LEYDET Commissaire aux comptes suppléant : MMP AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : SOGENI Président du conseil d'administration : COUILLARD Gregory en fonction le 27 Juin 2011 Administrateur : LE BRAS Jean-Francois en fonction le 27 Juin 2011 Administrateur : PECENKA Thomas en fonction le 27 Juin 2011. Activité : 
Commentaires : Modification de représentant.

27/05/2011

JAL

Appointment of the social representative

Vie correzienne (La)


Société faisant l'objet d'une nomination : 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, 1028 AV DE LA GARE, 19110 BORT LES ORGUES 
Nominé : Monsieur Grégory Couillard
En la fonction de : Président du Conseil d'Administration
Nominé : Monsieur Thomas Pecenka, Bilal Studios, Al Areeq Street, PO BOX, 15604 DOHA
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Monsieur Jean LeBras, Umm Bab Tow/er, appartement A6-23, DOHA
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Monsieur Grégory Couillard, West Bay Lagoon, Compound 11, Villa 2, PO Box, 15604 DOHA
En la fonction de : Administrateur
Date d'effet : 18/05/2011

27/05/2011

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Vie correzienne (La)


Date de décision : 18/05/2011
La société 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, 1028 AV DE LA GARE, 19110 BORT LES ORGUES 
Fait l'objet du départ de Date d'effet : 18/05/2011

14/01/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

45 - LOIRET

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

253 - 414 433 797 RCS Brive. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société à responsabilité limitée. Capital : 4224759 EUR. Adresse : 1028 avenue de la Gare, 19110 Bort-les-Orgues. 
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 30000 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : vente d'articles de maroquinerie, gants, articles de voyages, cadeaux, articles de Paris, stylos, chapeaux, casquettes et parapluies. Adresse : place du Châtelet, 45000 Orléans. 
Précédent propriétaire : TALEC. 481 625 820 RCS Orléans. 
Date de commencement de l’activité : 01/01/2011. Publication légale : la République du Centre du 04/01/2011. Oppositions : au fonds cédé pour la validité et pour la correspondance au cabinet Marceau Conseil, 8 rue de la République 45000 Orléans. Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

04/01/2011

JAL

Activity or goodwill cession

République du Centre (La)/Edition Orléans Ville


Date de décision : 22/12/2010 
Cédant : 481625820 - TALEC, LE TANNEUR, PL DU CHATELET, 45000 ORLEANS
Cessionnaire : 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, 1028 AV DE LA GARE, 19110 BORT LES ORGUES
Prix de vente : 30000 €
Date d’effet : 01/01/2011 

10/12/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

19 - CORREZE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

345 - 414 433 797 RCS Brive. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Administration : Président directeur général : DESCOTTES Hervé modification le 01 Décembre 2010 Administrateur : BRUN René Administrateur : RABONI Jocelyne modification le 01 Décembre 2010 Administrateur : FAUQUEUR Alain Commissaire aux comptes titulaire : SPITZ OLLIVIER & ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE LEYDET Commissaire aux comptes suppléant : MMP AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : SOGENI. Capital : 4224759 EUR. Activité : 
Commentaires : Modification du capital. Modification de représentant.

05/11/2010

JAL

Modification of the share capital

Vie correzienne (La)


Date de décision : 27/09/2010
La société : 414433797 - LE TANNEUR ET CIE, 1028 AV DE LA GARE, 19110 BORT LES ORGUES a subi une augmentation de son capital social désormais de 4 224 759 € 
Date d'effet : 27/09/2010

16/09/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

19 - CORREZE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

1889 - 414433797 RCS. LE TANNEUR & CIEForme : Société anonyme. Adresse : 1028 Avenue de la Gare Bort-Les-Orgues 19110 Bort-les-Orgues. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

16/09/2010

Bodacc C

Comptes annuels, consolidés et rapports

19 - CORREZE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

1890 - 414433797 RCS. LE TANNEUR & CIEForme : Société anonyme. Adresse : 1028 Avenue de la Gare Bort-Les-Orgues 19110 Bort-les-Orgues. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

12/04/2010

Bodacc C

Comptes annuels, consolidés et rapports

19 - CORREZE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

1766 - 414433797 RCS. LE TANNEUR & CIEForme : Société anonyme. Adresse : 1028 Avenue de la Gare Bort-Les-Orgues 19110 Bort-les-Orgues. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

03/12/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

19 - CORREZE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

456 - 414 433 797 RCS Brive. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Enseigne : SOCO TANN'S E. TANNEUR LE TANNEUR. 
Commentaires : Modification du nom commercial.

02/10/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

19 - CORREZE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

208 - 414 433 797 RCS Brive. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Capital : 4218375 EUR. 
Commentaires : Modification du capital.

25/07/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

19 - CORREZE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

3137 - 414433797 RCS. LE TANNEUR & CIEForme : Société anonyme. Adresse : 1028 Avenue de la Gare, 19110 Bort-les-Orgues. Commentaires :Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

05/07/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

19 - CORREZE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

183 - 414 433 797 RCS Brive. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Capital : 1406125 EUR. 
Commentaires : Modification du capital.

06/05/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

19 - CORREZE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

219 - 414 433 797 RCS Brive. LE TANNEUR& CIE. Forme : Société anonyme. Capital : 4218375 EUR. 
Commentaires : Modification du capital.

26/07/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

19 - CORREZE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TULLE

2340 - 414433797 RCS. LE TANNEUR & CIEForme : Société anonyme. Adresse : 1028 avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues. Commentaires :Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

26/07/2008

Bodacc C

Comptes consolidés et rapports

19 - CORREZE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TULLE

2341 - 414433797 RCS. LE TANNEUR & CIEForme : Société anonyme. Adresse : 1028 avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues. Commentaires :Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

20/05/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

19 - CORREZE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TULLE

118 - 414 433 797 RCS Tulle. LE TANNEUR & CIE. Forme : Société anonyme. Capital : 4206375 EUR. 
Commentaires : Modification survenue sur le capital.

08/08/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

1680 - 414 433 797. RCS Tulle LE TANNEUR & CIE. Forme: Société anonyme. Adresse du siège social: 1028 avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2006.

08/08/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

1681 - 414 433 797. RCS Tulle LE TANNEUR & CIE. Forme: Société anonyme. Adresse du siège social: 1028 avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues. Comptes consolidés et rapport de l'exercice clos le: 31 décembre 2006.

15/06/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

721 - RCS Tulle B 414 433 797. RC 98-B 43. LE TANNEUR & Cie. Forme : S.A. Nom commercial : Soco Upla Tann's Lorenzo E. Tanneur Le Tanneur. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare,, 19110 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président directeur général : DESCOTTES (Hervé) (Nom d'usage : DESCOTTES). Administrateurs : BRUN (René) (Nom d'usage : BRUN) RABONI (Jocelyne) (Nom d'usage : DESCOTTES) FAUQUEUR (Alain) (Nom d'usage : FAUQUEUR). Commissaires aux comptes titulaires : SPITZ OLLIVIER & ASSOCIES FIDUCIAIRE LEYDET. Commissaires aux comptes suppléants : MMP AUDIT SOGENI. Date d'effet : 23 mars 2007.

09/03/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

519 - RCS Tulle B 414 433 797. RC 98-B 43. LE TANNEUR & COMPAGNIE. Forme : S.A. Capital : 4 184 775 euros. Nom commercial : Soco Upla Tann's Lorenzo E. Tanneur Le Tanneur. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare,, 19110 Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration. Administration : président directeur général : DESCOTTES (Hervé) (Nom d'usage : DESCOTTES). Administrateurs : BRUN (René) (Nom d'usage : BRUN) RABONI (Jocelyne) (Nom d'usage : DESCOTTES). Commissaires aux comptes titulaires : SPITZ OLLIVIER & ASSOCIES FIDUCIAIRE LEYDET. Commissaires aux comptes suppléants : MMP AUDIT SOGENI. Date d'effet : 9 janvier 2007.

22/11/2006

Bodacc A

Vente et cession

1129 - RCS B 485 385 595. RC 06-B 15654. PARFILUXE. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 12 rue Montrosier, 92200 Neuilly-sur-Seine. Etablissement secondaire - Activité : vente au détail de tous objets en cuir, de maroquinerie, d'articles de mode, de voyages, de produits dérivés et d'accessoires. Adresse : 5 rue Saint-Benoît, 75006 Paris. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 475 000 euros. Date de début d'activité : 29 juin 2006. Précédent propriétaire : LE TANNEUR ET Cie. RCS Paris 414 433 797. Publication légale : Journal spécial des sociétés françaises par actions du 13 juillet 2006. Oppositions : au fonds pour la validité et Office notarial Canales & Egasse, 168 rue Grenelle, 75007 Paris, pour la correspondance.

07/09/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

696 - RCS Tulle B 414 433 797. RC 98-B 43. LE TANNEUR & CIE. Forme: S.A. Adresse du siège social: 1028, avenue de la Gare,19110 Bort-les-Orgues. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

08/08/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

841 - RCS Tulle B 414 433 797. RC 98-B 43. LE TANNEUR & CIE. Forme: S.A. Adresse du siège social: 1028, avenue de la Gare,19110 Bort-les-Orgues. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

28/02/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

0435 - RCS Tulle B 414 433 797. RC 98-B 43. LE TANNEUR & COMPAGNIE. Forme : S.A. Capital : 4 155 000 euros. Nom commercial : Soco Upla Tann's Lorenzo E. Tanneur Le Tanneur. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare,, 19110 Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation). Date d'effet : 14 décembre 2005.

12/08/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

1108 - RCS Tulle B 414 433 797. RC 98-B 43. LE TANNEUR & CIE. Forme: S.A. Adresse du siège social: 1028, avenue de la Gare,19110 Bort-les-Orgues. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

12/08/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

1109 - RCS Tulle B 414 433 797. RC 98-B 43. LE TANNEUR & CIE. Forme: S.A. Adresse du siège social: 1028, avenue de la Gare,19110 Bort-les-Orgues. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

22/09/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Strasbourg 435264569 RC 01-B 664 E TANNEUR. Forme : S.A.R.L. Capital : 9 000 euros Nom commercial: e-tanneur Etanneur. Adresse du siège social : 16 rue Stoeber, 67000 Strasbourg. Commentaires : dissolution de la société suite à la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, la STE LE TANNEUR & C i e S.A.,. RCS 414 433 797, 1028 avenue de la Gare, 19110 Bort- les-Orgues, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil. Date d'effet : 31 juillet 2004.

02/09/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Tulle B 414433797 RC 98-B 43 LE TANNEUR & COMPAGNIE. Forme : S.A Nom commercial: Soco Upla Tann's Lorenzo E. Tanneur Le Tanneur. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare, 19110 Bort-les-Orgues. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : président directeur général : DESCOTTES (Hervé) ( Nom d'usage : DESCOTTES). Administrateurs : CALMELS (Didier) ( Nom d'usage : CALMELS) BRUN (René) ( Nom d'usage : BRUN) BORGEOT (Vincent) ( Nom d'usage : BORGEOT). Commissaires aux comptes titulaires : SPITS OLLIVIER & ASSOCIES FIDUCIAIRE LEYDET. Commissaires aux comptes suppléants : MMP AUDIT SOGENI. Date d'effet : 2 juin 2004.

12/05/2004

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Versailles B 453323529 RC 04-B 1557 ELEGANCE COLLECTION. Forme : S.A.R.L. Capital : 8 000 euros Nom commercial: Elégance Collection. Activité : vente d' articles de maroquinerie, de bagagerie, d'accessoires de mode et import-export de ces articles. Adresse du siège social : 10 T rue de la Salle, 78100 Saint- Germain-en-Laye. Administration : gérant : JIN (Yichen). Fonds acquis par achat au prix stipulé de 150 000 euros Date de début d'activité: 3 mai 2004. Précédent propriétaire : LE TANNEUR ET C i e. RCS 414433797 Publication légale: La Semaine de l'Ile-de-France du 4 mai 2004. Oppositions : au fonds pour la validité et M e Chevrier de Zitter ( Fabienne), 1 quai de Corse, 75004 Paris, pour la correspondance.

10/03/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS B 414433797 RC 98-B 10944 LE TANNEUR ET C i e. Forme : S.A. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare, 19110 Bort-les-Orgues Etablissement principal: Activité : prestations de services dans le domaine de la fabrication du cuir, comptabilité et gestion. Adresse : 117-119 quai de Valmy, 75010 Paris. Commentaires : transfert de l'établissement principal du 102 avenue Victor-Hugo, 75016 Paris. Date d'effet : 1 e r juin 2001 (régularisation).

06/09/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Tulle B 414433797 RC 98-B 43 LE TANNEUR & COMPAGNIE. Forme : S.A. Capital : 4 110 000 euros Nom commercial: Soco Upla Tann's Lorenzo E. Tanneur Le Tanneur. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare, 19110 Bort-les- Orgues. Commentaires : modification survenue sur le nom commercial. Date d'effet : 25 juillet 2002.

19/08/2001

Bodacc A

Vente et cession

RCS non encore inscrit. HOTEL ALEXANDER. Forme : S.A. Capital : 480 000 F. Adresse du siège social : 100-102 avenue Victor-Hugo, 75016 Paris Etablissement principal: Activité : droit au bail de locaux. Adresse : 102 avenue Victor-Hugo, 75016 Paris Droit au bail, dépendant de l'établissement principal, acquis par cession au prix stipulé de 3 800 000 F. Date d'effet : 14 juin 2001. Précédent propriétaire : LE TANNEUR ET COMPAGNIE. RCS B 414433797 Publication légale: Le Publicateur légal du 6 juillet 2001. Oppositions : Séquestre Juridique de l' Ordre des Avocats, 11 place Dauphine, 75053 Paris Louvre R.P.-S.P.

05/04/2001

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Créteil B 414433797 RC AP-B 491 LE TANNEUR ET COMPAGNIE. Forme : S.A. Capital : 4 110 000 euros. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare, 19110 Bort-les- Orgues Etablissement principal: Activité : droit au bail de divers locaux. Adresse : centre commercial Créteil Soleil, niveau 40-30, n° 2315, file E-D 29, 94000 Créteil Droit au bail, dépendant de l'établissement principal, acquis par achat au prix stipulé de 3 000 000 de F. Date d'effet : 28 février 2001. Précédent propriétaire : LES BOUTIQUES FRANCHISEES. RCS B 352205165 Publication légale: La Gazette du Palais du 15 mars 2001. Oppositions : S.C.P. Meunier Gendron, centre 348, 40 rue du Séminaire, 94586 Rungis.

08/03/2001

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Pontoise B 434653184 RC 01-B 430 MAROQUINERIE GENERALE STOCKS-M.G.S. Forme : S.A.R.L. Capital : 7 700 euros. Activité : vente d'articles de maroquinerie, d'accessoires, d'articles de bureau et de bagages. Adresse du siège social : Paris Nord II, Usines Center, 95500 Gonesse. Administration : gérant : SON (Xiaoxia) ( Nom d'usage : ZHANG). Fonds acquis par achat au prix stipulé de 1 400 000 F Date de début d' activité: 10 février 2001. Précédent propriétaire : LE TANNEUR & COMPAGNIE. RCS B 414433797 Publication légale: L'Echo- Le Régional du 21 février 2001. Oppositions : au fonds pour la validité et pour la correspondance chez M e Chevrier de Zitter (Fabienne), 1 quai de la Corse, 75004 Paris.

28/02/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Tulle B 414433797 RC 98-B 43 LE TANNEUR & COMPAGNIE. Forme : S.A. Capital : 4 110 000 euros Nom commercial: Soco Upla Tann's Lorenzo E. Tanneur. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare, 19110 Bort-les-Orgues. Commentaires : modification survenue sur le nom commercial. Date d'effet : 20 septembre 2000.

23/01/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Tulle B 414433797 RC 98-B 43 LE TANNEUR & COMPAGNIE. Forme : S.A. Capital : 4 110 000 euros Nom commercial: Soco Upla Tann's Lorenzo Tanneur. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare, 19110 Bort-les-Orgues. Commentaires : déclaration d'utilisation des noms commerciaux en tant que marques. Date d'effet : 20 septembre 2000.

24/08/2000

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Bobigny B 432496230 RC 00-B 3151 PACIFIC CUIR 2. Forme : S.A.R.L. Capital : 7 700 euros. Activité : vente d'articles de maroquinerie, de bagagerie et d' accessoires de mode import-export de ces articles. Adresse du siège social : quai des Marques, 8 quai du Chatelier, 93450 L'Ile-Saint-Denis. Administration : gérant : LIN (Chunsheng). Fonds acquis par achat au prix stipulé de 1 200 000 F Date de début d'activité: 16 aout 2000. Précédent propriétaire : LE TANNEUR ET COMPAGNIE. RCS B 414433797 Publication légale: Les Petites affiches du 4 aout 2000. Oppositions : M e Chevrier de Zitter, 1 quai de Corse, 75004 Paris, pour la correspondance et au fonds pour la validité.

14/06/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Tulle B 414433797 RC 98-B 43 LE TANNEUR & COMPAGNIE. Forme : S.A. Capital : 4 110 000 euros. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare, 19110 Bort-les- Orgues. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation et conversion en euros). Date d'effet : 14 avril 2000.

29/12/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Tulle B 414433797 RC 98-B 43 LE TANNEUR & COMPAGNIE. Forme : S.A. Capital : 22 500 000 F. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare, 19110 Bort-les- Orgues. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration. Administration : P.- D.G. : DESCOTTES (Hervé) ( Nom d'usage : DESCOTTES). Administrateurs : CALMELS ( Didier) ( Nom d'usage : CALMELS) BRUN (René) ( Nom d'usage : BRUN) BORGEOT (Vincent) ( Nom d'usage : BORGEOT). Commissaires aux comptes titulaires : AMPHOUX (Didier) ( Nom d' usage : AMPHOUX) SPTIZ (Jean-Claude) ( Nom d'usage : SPTIZ). Commissaires aux comptes suppléants : GIULIANI (Jean- Marcel) ( Nom d'usage : GIULIANI) OLLIVIER (Paul) ( Nom d'usage : OLLIVIER). Date d'effet : 29 octobre 1999.

14/11/1999

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 405038258 RC 99-B 2440 L'IDEAL 1. Forme : S.A.R.L. Adresse du siège social : centre commercial La Grande Porte, local n° 18, niveau 1, 93100 Montreuil- sous-Bois Etablissement principal: Activité : vente au détail de produits et d'articles de maroquinerie. Adresse : centre commercial Usines Center Vélizy, local n° 127, route André-Citroen, 78140 Vélizy-Villacoublay Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 850 000 F Date de début d' activité: 15 octobre 1999. Précédent propriétaire : LE TANNEUR ET COMPAGNIE. RCS B 414433797 Publication légale: La Semaine de l'Ile-de-France du 26 octobre 1999. Oppositions : Cabinet Fidal, immeuble Le Pascal, 1-9 rue Charles-de- Gaulle, 94007 Créteil Cedex, pour la correspondance et au fonds pour la validité.

23/05/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Ancienne situation du siège social. RCS Tulle B 414 433 797 RC 98-B 43 LE TANNEUR ET COMPAGNIE. Forme : S.A. Capital : 15 000 000 de F. Adresse : 1028 avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues Nouvelle situation du siège social. Adresse : 1070 avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues Etablissement principal: Adresse : 1028 avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues ETABLISSEMENT PRINCIPAL nouvelle situation. Adresse : 1070 avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues Etablissement Complémentaire. Adresse : 1070 avenue de la Gare 19110 Bort-les- Orgues Etablissement complémentaire - nouvelle situation -. Adresse : fermé. Date d'effet : 6 novembre 1997.

30/11/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Tulle B 414 433 797 A dater du: 5 novembre 1998 LE TANNEUR ET CIE. Forme : S.A. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare, 19110 Bort-les- Orgues Fonds secondaire acquis par achat dans le cadre d'un plan de cession, au prix global stipulé de 5 000 000 de F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Bourg-en-Bresse 98-B 643. Activité : vente au détail de tous objets en cuir, maroquinerie , articles de maroquinerie, articles de mode, articles de voyage et produits dérivés et accessoires. Adresse : 5 avenue de Lyon, 01000 Bourg-en- Bresse Date de début d'activité: 6 novembre 1997 Précédente propriétaire- exploitante ANDRELUX S.A. RCS B 320 825 300 RC 94-B 639 Publication légale: La Voix de l'Ain du 3 juillet 1998. Oppositions : S.C.P. Mizon Thoux, 60 boulevard de Sébastopol, 75003 Paris.

22/11/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 414 433 797 RC 98-B 02124 LE TANNEUR ET COMPAGNIE. Forme : S.A. à conseil d'administration. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues Etablissement principal: Activité : vente au détail de tous objets en cuir, de maroquinerie, d' articles de voyages, de produits et d' accessoires. Adresse : centre commercial La Valentine, route La Sablière 13373 Marseille Etablissement principal acquis par achat, dans le cadre d'une procédure collective, au prix stipulé de 5 000 000 de F. Date d'effet : 6 novembre 1998. Précédent propriétaire : ANDRELUX. RCS B 320 825 300 Publication légale: Les Nouvelles publications du 26 juin 1998.

07/11/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Tulle B 414 433 797 A dater du: 12 octobre 1998 RC 98-B 43 LE TANNEUR ET COMPAGNIE. Forme : S.A. Capital : 15 000 000 de F. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues Etablissement Complémentaire. Activité : vente au détail de tous objets en cuir et de maroquinerie. Adresse : 1070 avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues Etablissement complémentaire acquis par cession au prix stipulé de 5 000 000 de F. Date d'effet : 6 novembre 1997. Précédent propriétaire : exploitant ANDRELUX INDUSTRIES S.A. RCS Tulle B 348 862 467 Publication légale: La Vie corrézienne du 3 juillet 1998. Oppositions : S.C.P. Mizon Thoux, 60 boulevard de Sébastopol, 75003 Paris.

14/10/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Tulle B 414 433 797 A dater du: 17 septembre 1998 LE TANNEUR ET CIE. Forme : S.A. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare, 19110 Bort-les- Orgues Fonds secondaire acquis par achat, au prix stipulé de 5 000 000 de F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Belley 98- B 78. Activité : vente au détail de tous objets en cuir de maroquinerie , articles de mode, de voyages et produits dérivés, accessoires. Adresse : chemin des Ecassaz, 01300 Belley. Date d'effet : 6 novembre 1997 Précédente propriétaire exploitante (en liquidation judiciaire) ANDRELUX INDUSTRIE S.A. RC Belley 92-B 87 Publication légale: La Voix de l'Ain du 9 juillet 1998.

24/09/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Tulle B 414 433 797 A dater du: 4 septembre 1998 LE TANNEUR ET CIE. Forme : S.A. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare, 19110 Bort-les- Orgues Fonds secondaire acquis par achat au prix stipulé de 5 000 000 de F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Troyes 98-B 298. Activité : fabrication, vente, diffusion sous toutes ses formes de tous objets en cuir, maroquinerie , articles de mode, articles de voyage et produits dérivés et accessoires, exploitation directe ou indirecte de tous magasins de vente au détail. Adresse : 141 boulevard de Dijon, centre commercial Marques-Avenue, 10800 Saint- Julien-les-Villas Date de début d' activité: 6 novembre 1997 Précédente propriétaire ANDRELUX S.A. RCS B 320 825 300 RC 94-B 415 Publication légale: Libération Champagne du 27 juin 1998. Oppositions : S.C.P. Mizon Thoux, 60 boulevard de Sébastopol, 75003 Paris.

06/09/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 414 433 797 RC 98-B 1636 LE TANNEUR ET COMPAGNIE. Forme : S.A. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues Etablissement principal: Activité : fabrication, vente, diffusion sous toutes ses formes de tous objets en cuir, de maroquinerie, de mode et de voyage, de produits dérivés et d'accessoires exploitation, directe ou indirecte, de tous magasins de vente au détail. Adresse : centre commercial Usine-Center, lots n°s 13 et 37, Paris-Nord II 95500 Gonesse Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 12 000 000 de F Date de début d'activité: 6 novembre 1997. Précédent propriétaire : ANDRELUX S. A. RCS B 320 825 300 Publication légale: L'Echo-Le Régional du 2 juillet 1998. Oppositions : S.C.P. Mizon Thoux, 60 boulevard de Sébastopol, 75003 Paris.

23/08/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 414 433 797 RC 98-B 10944 LE TANNEUR ET COMPAGNIE. Forme : S.A. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues Etablissement principal: Activité : vente au détail de tous objets en cuir, de maroquinerie, d' articles de mode, de voyage, de produits dérivés et d'accessoires. Adresse : 56 rue Bonaparte 75006 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente au détail de tous objets en cuir, de maroquinerie, d'articles de mode, de voyage, de produits dérivés et d' accessoires. Adresse : 17 rue des Halles 75001 Paris Etablissement secondaire acquis par achat dans le cadre d'une procédure collective au prix stipulé de 5 000 000 de F Date de début d'activité: 6 novembre 1997. Précédent propriétaire : ANDRELUX S.A. RCS B 320 825 300 Publication légale: Les Annonces de la Seine du 25 juin 1998.

23/08/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 414 433 797 RC 98-B 3832 LE TANNEUR ET COMPAGNIE. Forme : S.A. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues Etablissement principal: Activité : vente au détail de tous objets en cuir, de maroquinerie, d' articles de mode et de voyage, de produits dérivés et d'accessoires. Adresse : centre commercial Les Quatre Temps, 15 parvis de La Défense 92800 Puteaux Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 5 000 000 de F Date de début d'activité: 6 novembre 1997. Précédent propriétaire : ANDRELUX S.A. RCS B 320 825 300 Publication légale: Les Annonces de la Seine du 25 juin 1998. Oppositions : S.C. P. Mizon Thoux, 60 boulevard Sébastopol, 75003 Paris.

23/08/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 414 433 797 RC 98-B 10944 LE TANNEUR ET COMPAGNIE. Forme : S.A. Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues Etablissement principal: Activité : vente au détail de tous objets en cuir, de maroquinerie, d' articles de mode, de voyage, de produits dérivés et d'accessoires. Adresse : 56 rue Bonaparte 75006 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente au détail de tous objets en cuir, de maroquinerie, d'articles de mode, de voyage, de produits dérivés et d' accessoires. Adresse : 102 avenue Victor- Hugo 75116 Paris Etablissement secondaire acquis par achat dans le cadre d'une procédure collective au prix stipulé de 5 000 000 de F Date de début d'activité: 6 novembre 1997. Précédent propriétaire : ANDRELUX S.A. RCS B 320 825 300 Publication légale: Les Annonces de la Seine du 25 juin 1998.

20/08/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Tulle B 414 433 797 A dater du: 6 juillet 1998 RC 98-B 43 LE TANNEUR & CIE. Forme : S.A. Capital : 15 000 000 de F (fixe). Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare, 19110 Bort-les- Orgues Fonds principal acquis par cession au prix stipulé de 5 000 000 de F Etablissement principal: Activité : fabrication et vente de tous objets en cuir de maroquinerie. Adresse : 1028 avenue de la Gare, 19110 Bort-les- Orgues. Date d'effet : 6 novembre 1997 Précédentes propriétaires ANDRELUX INDUSTRIES S.A. RCS Paris B 348 862 467 ANDRELUX S.A. RCS Paris B 320 825 300 Publication légale: La Vie corrézienne du 3 juillet 1998. Oppositions : S.C.P. Mizon Thoux, 60 boulevard de Sébastopol, 75003 Paris.

14/08/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS *. RCS Paris B 414 433 797 RC RC 98- B 10944 LE TANNEUR ET COMPAGNIE. Forme : S.A. Adresse du siège social : 1028, avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues Etablissement principal: Activité : vente au détail de tous objets en cuir de maroquinerie, articles de mode, articles de voyage et produits dérivés et accessoires. Adresse : 56, rue Bonaparte 75006 Paris Etablissement principal acquis par achat dans le cadre d'une procédure collective au prix stipulé de 5 000 000 de F Date de début d'activité: 6 novembre 1997 ( régularisation). Précédent propriétaire : : ANDRELUX S.A. RCS RCS B 320 825 300 Publication légale: Les Annonces de la Seine du 25 juin 1998.

14/08/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS *. RCS Créteil B 414 433 797 RC RC 98-B 2013 LE TANNEUR ET COMPAGNIE. Forme : S.A. Adresse du siège social : 1028, avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues Etablissement principal: Activité : vente au détail de tous objets en cuir de maroquinerie, articles de mode, articles de voyage, produits dérivés et accessoires. Adresse : centre commercial régional Belle-Epine 94320 Thiais Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 5 000 000 de F Date de début d'activité: 6 novembre 1997. Précédent propriétaire : en liquidation judiciaire : ANDRELUX. RCS RCS B 320 825 300 Publication légale: Les Annonces de la Seine du 25 juin 1998.

14/08/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS *. RCS Versailles B 414 433 797 RC RC 98-B 1836 LE TANNEUR ET COMPAGNIE. Forme : S.A. Capital : 15 000 000 de F. Adresse du siège social : 1028, avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues Etablissement principal: Activité : la vente au détail de tous objets en cuir de maroquinerie, articles de mode, articles de voyage, produits dérivés et accessoires. Adresse : centre commercial Parly-II, avenue Charles-de-Gaulle 78150 Le Chesnay Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 5 000 000 de F ETABLISSEMENT SECONDAIRE immatriculé au. RCS : Versailles. Adresse : Les Galeries de Saint-Germain, 10, traverse de la Salle 78100 Saint-Germain-en-Laye. Activité : vente au détail de tous objets en cuir de maroquinerie, mode, articles de voyage, produits dérivés et accessoires Date de début d'activité: 6 novembre 1997. Précédent propriétaire : : ANDRELUX. RCS RCS B 320 825 300 Publication légale: Les Annonces de la Seine du 25 juin 1998. Oppositions : ordre des avocats, 11, place Dauphine, 75001 Paris.

14/08/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS *. RCS Versailles B 414 433 797 RC RC 98-B 1836 LE TANNEUR ET COMPAGNIE. Forme : S.A. Capital : 15 000 000 de F. Adresse du siège social : 1028, avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues Etablissement principal: Activité : vente au détail de tous objets en cuir, maroquinerie, articles de mode, articles de voyage, produits dérivés et accessoires. Adresse : centre commercial Parly-II, avenue Charles-de-Gaulle 78150 Le Chesnay Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 5 000 000 de F ETABLISSEMENT SECONDAIRE immatriculé au. RCS : Versailles. Adresse : 127, Usines Center, rue André-Citroen 78140 Vélizy- Villacoublay. Activité : vente au détail de tous objets en cuir de maroquinerie, articles de mode, articles de voyage, produits dérivés et accessoires Date de début d'activité: 6 novembre 1997. Précédent propriétaire : : RCS RCS B 320 825 300 Publication légale: Les Annonces de la Seine du 25 juin 1998. Oppositions : ordre des avocats, 11, place Dauphine, 75001 Paris.

10/06/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Tulle B 414 433 797 A dater du: 16 avril 1998 RC 98-B 43 LE TANNEUR & CIE. Forme : S.A. Capital : 15 000 000 de F ( fixe). Adresse du siège social : 1028 avenue de la Gare, 19110 Bort-les- Orgues. Administration : président- directeur général : DESCOTTES (Hervé) administrateur : Mme RABONI (Jocelyne), nom d'usage : DESCOTTES, CALMELS ( Didier), BRUN (René), INCH (Marc) commissaire aux comptes titulaire : AMPHOUX (Didier), SPTIZ (Jean-Claude) commissaire aux comptes suppléant : GIULIANI (Jean-Marcel), OLLIVIER (Paul) Cette société se constitue Cette société se constitue, mais n'exploite provisoirement aucun établissement.

 

 

Company events history

 

Date

Description

13/02/2018

Bodacc B: Various editing or changing

02/02/2018

Capital increase

02/02/2018

Amendment

02/02/2018

Updated articles of association

30/11/2017

Legal Gazette: Modification of the share capital

03/11/2017

New ultimate parent

03/11/2017

New parent detected

02/11/2017

Bodacc B: Various editing or changing

20/10/2017

Updated articles of association

20/10/2017

Minutes of general meeting of shareholders

20/10/2017

Capital increase

20/10/2017

Appointment/resignation of company officers

20/10/2017

Amendment

20/10/2017

Changes to the Board of Directors

03/08/2017

Bodacc C : Deposit accounts notice

20/07/2017

Bodacc C : Deposit accounts notice

27/06/2017

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

31/12/2016

New accounts available

31/12/2016

New consolidated accounts available

10/12/2016

Update Rating

10/12/2016

Update Limit

07/09/2016

Bodacc C : Deposit accounts notice

02/09/2016

Bodacc B: Various editing or changing

24/08/2016

Invalid balance sheet

23/08/2016

New auditor

23/08/2016

Minutes of general meeting of shareholders

23/08/2016

Changes to the Board of Directors

06/08/2016

New shareholders detected

31/12/2015

New consolidated accounts available

15/11/2015

Bodacc B: Various editing or changing

11/11/2015

Bodacc B: Various editing or changing

02/11/2015

Update Rating

29/10/2015

Changes to the Board of Directors

29/10/2015

Amendment

27/10/2015

Amendment

27/10/2015

Appointment/resignation of company officers

27/10/2015

Changes to the Board of Directors

08/10/2015

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

28/07/2015

Bodacc C : Deposit accounts notice

03/07/2015

Update Limit

03/07/2015

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

27/05/2015

Legal Gazette: Appointment of the social representative

23/04/2015

Bodacc B: Various editing or changing

08/04/2015

Minutes of general meeting of shareholders

08/04/2015

Changes to the Board of Directors

08/04/2015

Amendment

08/04/2015

New auditor

08/04/2015

New chairman (CEO, CoB)

08/04/2015

Bodacc A : Sale and transfer

03/04/2015

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

27/02/2015

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer

23/01/2015

Bodacc A : Sale and transfer

20/01/2015

Legal Gazette: Start of rent-management

31/12/2014

New accounts available

31/12/2014

New consolidated accounts available

19/12/2014

Legal Gazette: End of rent-management

19/12/2014

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer

03/12/2014

Legal Gazette: Appointment of the social representative

19/10/2014

Bodacc B: Various editing or changing

03/10/2014

Update of participations in other companies

03/10/2014

Disengagement in other companies

03/10/2014

New shareholders detected

03/10/2014

New chairman (CEO, CoB)

03/10/2014

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

03/10/2014

Changes to the Board of Directors

03/10/2014

Amendment

03/09/2014

Legal Gazette: Appointment of the social representative

12/08/2014

Bodacc B: Various editing or changing

05/08/2014

Bodacc C : Deposit accounts notice

28/07/2014

Minutes of general meeting of shareholders

28/07/2014

Changes to the Board of Directors

08/07/2014

Update Limit

08/07/2014

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

03/06/2014

Legal Gazette: Appointment of the social representative

25/03/2014

Bodacc A : Sale and transfer

21/03/2014

Bodacc A : Sale and transfer

16/03/2014

Bodacc A : Sale and transfer

11/03/2014

Bodacc A : Sale and transfer

09/03/2014

Bodacc A : Sale and transfer

06/03/2014

Bodacc A : Sale and transfer

07/02/2014

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer

01/02/2014

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer

31/12/2013

New accounts available

31/12/2013

New consolidated accounts available

30/10/2013

Update Rating

30/10/2013

Update Limit

30/10/2013

Invalid balance sheet

26/08/2013

Bodacc C : Deposit accounts notice

19/08/2013

Bodacc C : Deposit accounts notice

11/08/2013

Bodacc B: Various editing or changing

28/07/2013

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

26/07/2013

Minutes of general meeting of shareholders

26/07/2013

Capital increase

26/07/2013

Audit or Management Report

26/07/2013

Amendment

26/07/2013

Updated articles of association

19/06/2013

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

26/03/2013

Legal Gazette: Modification of the share capital

26/03/2013

Other modification of Establishment

06/03/2013

Bodacc A : Sale and transfer

23/01/2013

Bodacc A : Sale and transfer

01/01/2013

Formation of Establishment

31/12/2012

New accounts available

28/12/2012

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer

08/12/2012

Update of Company Workforce

08/12/2012

Other modification of Establishment

08/12/2012

Formation of Establishment

13/09/2012

Legal Gazette: Start of rent-management

20/08/2012

Bodacc C : Deposit accounts notice

16/03/2012

Bodacc B: Various editing or changing

05/03/2012

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

01/03/2012

Minutes of Board meeting

01/03/2012

Changes to the Board of Directors

01/03/2012

Appointment/resignation of company officers

01/03/2012

Amendment

06/02/2012

Legal Gazette: Appointment of the social representative

31/12/2011

New consolidated accounts available

31/12/2011

Modification of Company Activity

31/12/2011

New accounts available

31/12/2011

Update of Company Activity

13/12/2011

Collection of preferential rights for this company has been stopped by the Court

21/09/2011

Bodacc A : Sale and transfer

07/09/2011

Declaration of conformity

07/09/2011

Minutes of Board meeting

07/09/2011

Minutes of general meeting of shareholders

07/09/2011

Partial contribution

07/09/2011

Amendment

02/09/2011

Update of participations in other companies

23/08/2011

Registration after transfer

23/08/2011

Registered office transferred outside jurisdiction of the Commercial Court

23/08/2011

Minutes of general meeting of shareholders

23/08/2011

Amendment

23/08/2011

Updated articles of association

23/08/2011

Changes to the Board of Directors

11/08/2011

Legal Gazette: Head Office Transfer

10/08/2011

Bodacc B: Various editing or changing

02/08/2011

Minutes of general meeting of shareholders

02/08/2011

New auditor

28/07/2011

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

05/07/2011

Bodacc B: Various editing or changing

01/07/2011

Update of participations in other companies

01/07/2011

New shareholders detected

01/07/2011

New subsidiarie(s) detected

27/06/2011

Amendment

27/06/2011

Minutes of Board meeting

27/06/2011

New chairman (CEO, CoB)

16/06/2011

Closure of Establishment

15/06/2011

Update of Company Head Office Identifier

15/06/2011

Transfer of Establishment

03/06/2011

Disengagement of the group

03/06/2011

New ultimate parent

03/06/2011

New parent detected

01/06/2011

Transfer of Establishment

27/05/2011

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

18/05/2011

Legal Gazette: Appointment of the social representative

01/04/2011

New shareholders detected

14/01/2011

Bodacc A : Sale and transfer

31/12/2010

New accounts available

22/12/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

13/12/2010

Collection of preferential rights activated for this company

10/12/2010

Bodacc B: Various editing or changing

01/12/2010

Power of attorney

01/12/2010

Minutes of general meeting of shareholders

01/12/2010

Minutes of Board meeting

01/12/2010

Capital increase

01/12/2010

Amendment

03/11/2010

Audit or Management Report

01/10/2010

Spin-off

01/10/2010

Private document

27/09/2010

Legal Gazette: Modification of the share capital

16/09/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

13/08/2010

New shareholders detected

12/04/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

31/12/2009

New accounts available

03/12/2009

Bodacc B: Various editing or changing

02/10/2009

Bodacc B: Various editing or changing

23/09/2009

Minutes of Board meeting

23/09/2009

Capital increase

23/09/2009

Amendment

25/07/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

05/07/2009

Bodacc B: Various editing or changing

26/06/2009

Capital reduction

26/06/2009

Private document

26/06/2009

Updated articles of association

26/06/2009

Minutes of general meeting of shareholders

26/06/2009

Minutes of general meeting of shareholders

26/06/2009

Minutes of Board meeting

26/06/2009

Capital reduction

06/05/2009

Bodacc B: Various editing or changing

05/05/2009

Capital reduction

05/05/2009

Capital reduction

05/05/2009

Minutes of general meeting of shareholders

05/05/2009

Minutes of general meeting of shareholders

05/05/2009

Private document

23/04/2009

Amendment

23/04/2009

Amendment

23/04/2009

Capital increase

23/04/2009

Capital increase

23/04/2009

Updated articles of association

23/04/2009

Minutes of general meeting of shareholders

23/04/2009

Minutes of general meeting of shareholders

23/04/2009

Private document

23/04/2009

Updated articles of association

23/04/2009

Minutes of Board meeting

31/12/2008

New accounts available

15/09/2008

Private document

15/09/2008

New manager

15/09/2008

Minutes of general meeting of shareholders

15/09/2008

Minutes of Board meeting

15/09/2008

Appointment/resignation of company officers

26/07/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

26/06/2008

Private document

26/06/2008

Updated articles of association

26/06/2008

Updated articles of association

26/06/2008

Minutes of general meeting of shareholders

26/06/2008

Minutes of general meeting of shareholders

20/05/2008

Bodacc B: Various editing or changing

20/05/2008

New Bodacc B ads detected

29/04/2008

Updated articles of association

29/04/2008

Capital increase

29/04/2008

Minutes of general meeting of shareholders

29/04/2008

Private document

29/04/2008

Updated articles of association

29/04/2008

Capital increase

29/04/2008

Minutes of Board meeting

31/12/2007

New accounts available

15/05/2007

Private document

15/05/2007

Minutes of Board meeting

15/05/2007

Minutes of Board meeting

15/05/2007

Changes to the Board of Directors

15/05/2007

Changes to the Board of Directors

15/05/2007

Appointment/resignation of company officers

15/05/2007

Amendment

12/02/2007

Minutes of general meeting of shareholders

12/02/2007

Minutes of general meeting of shareholders

12/02/2007

Private document

12/02/2007

Updated articles of association

12/02/2007

Updated articles of association

12/02/2007

Minutes of Board meeting

12/02/2007

Minutes of Board meeting

12/02/2007

Changes to the Board of Directors

12/02/2007

Changes to the Board of Directors

12/02/2007

Capital increase

12/02/2007

Capital increase

12/02/2007

Appointment/resignation of company officers

12/02/2007

Amendment

12/02/2007

Amendment

31/12/2006

New accounts available

12/07/2006

Updated articles of association

12/07/2006

Private document

12/07/2006

Minutes of general meeting of shareholders

12/07/2006

Capital reduction

13/01/2006

Private document

13/01/2006

Minutes of general meeting of shareholders

13/01/2006

Minutes of Board meeting

13/01/2006

Capital increase

13/01/2006

Amendment

13/01/2006

Updated articles of association

31/12/2005

New accounts available

31/12/2004

New accounts available

09/08/2004

Appointment/resignation of company officers

09/08/2004

New auditor

09/08/2004

Private document

09/08/2004

Amendment

09/08/2004

Minutes of general meeting of shareholders

31/12/2003

New accounts available

04/09/2002

Amendment

04/09/2002

Appointment/resignation of company officers

04/09/2002

Changes to the Board of Directors

04/09/2002

Updated articles of association

04/09/2002

Minutes of general meeting of shareholders

04/09/2002

New chairman (CEO, CoB)

04/09/2002

Private document

04/09/2002

Minutes of Board meeting

02/07/2001

Amendment

02/07/2001

Minutes of general meeting of shareholders

02/07/2001

Updated articles of association

02/07/2001

Private document

02/07/2001

New closing date

23/05/2000

Amendment

23/05/2000

Audit or Management Report

23/05/2000

Capital increase

23/05/2000

Capital reduction

23/05/2000

Updated articles of association

23/05/2000

Minutes of Board meeting

23/05/2000

Minutes of general meeting of shareholders

23/05/2000

Private document

23/05/2000

Conversion of equity to euro

08/12/1999

Appointment/resignation of company officers

08/12/1999

Minutes of Board meeting

08/12/1999

Minutes of general meeting of shareholders

08/12/1999

Private document

08/12/1999

Amendment

08/12/1999

Updated articles of association

08/12/1999

Audit or Management Report

08/12/1999

Merger

08/12/1999

Fund deposit certificate

08/12/1999

Declaration of conformity

08/12/1999

Changes to the Board of Directors

08/12/1999

Capital increase

21/10/1999

Amendment

21/10/1999

Audit or Management Report

21/10/1999

Merger

21/10/1999

Private document

20/09/1999

Amendment

20/09/1999

Planned merger

20/09/1999

Private document

11/06/1999

Private document

11/06/1999

Minutes of general meeting of shareholders

11/06/1999

Amendment

11/06/1999

Updated articles of association

20/04/1999

Private document

20/04/1999

Audit or Management Report

20/04/1999

Amendment

14/10/1998

Minutes of general meeting of shareholders

14/10/1998

Appointment/resignation of company officers

14/10/1998

New closing date

14/10/1998

Private document

14/10/1998

Updated articles of association

14/10/1998

Amendment

16/04/1998

Minutes of Board meeting

16/04/1998

Company formation

16/04/1998

Articles of association

16/04/1998

Appointment/resignation of company officers

16/04/1998

Amendment

16/04/1998

Private document

 

 

Establishment events history

 

Date

Description

03/08/2016

Update of phone numbers

30/07/2015

Update of phone numbers

10/06/2015

Update of phone numbers

02/03/2015

Modification of Head office

01/01/2013

Modification of Head office

08/12/2012

Modification of Head office

08/12/2012

Update of Establishment Workforce

24/10/2012

Update of phone numbers

31/12/2011

Modification of Head office

16/06/2011

Modification of Establishment

15/06/2011

Modification of Head office (after transfer)

01/06/2011

Formation of Establishment (after transfer)

 

Synthesized Accounts

Annual Accounts

31/12/2016

31/12/2014

31/12/2013

Account period (month)

12

12

12

Account Type

Normal

Normal

Normal

Date of capture

26/06/2017

02/07/2015

07/07/2014

Activity Code

4649Z

4649Z

4649Z

Employees

177

217

2

 

Active account

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2016

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

11,816,818

-4.5%

12,372,254

8.8%

11,376,007

23,763

49628.9%

 Intangible assets

3,859,126

-13.1%

4,440,825

42.3%

3,120,253

0

0%

 Tangible assets

2,031,484

2.9%

1,974,371

-13.5%

2,282,119

5,287

38327.8%

 Financial assets

5,926,208

-0.5%

5,957,058

-0.3%

5,973,634

1,009

587234.8%

Net current assets

16,058,482

-4.2%

16,761,344

-12.6%

19,180,512

221,253

7158.0%

 Stocks

8,915,930

-5.9%

9,476,946

-9.5%

10,474,961

39,113

22695.3%

 Advanced payments

0

0%

0

0%

0

0

0%

 Receivables

4,936,091

28.0%

3,856,596

-20.0%

4,823,556

65,147

7476.9%

 Securities and cash

2,206,461

-35.6%

3,427,802

-11.7%

3,881,993

34,597

6277.6%

 Prepaid expenses

-

-

-

-

-

0

-

Accounts of regularization

9,535

-65.6%

27,689

-24.9%

36,878

0

0%

Total Assets

27,884,835

-4.4%

29,161,287

-4.7%

30,593,397

279,974

9859.8%

 

Passive Account

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2016

Shareholders' equity

6,540,991

-25.8%

8,813,118

-4.8%

9,255,530

96,038

6710.8%

Share capital

4,282,136

0%

4,282,136

0%

4,282,136

12,989

32868.7%

Other capital resources

0

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

221,155

-47.2%

419,092

-10.8%

470,082

0

0%

Liabilities

21,122,589

6.0%

19,927,113

-4.5%

20,864,793

148,351

14138.3%

 Financial liabilities

501,355

-63.0%

1,353,953

-44.2%

2,425,424

15,889

3055.5%

 Advanced payments received

0

0%

0

0%

0

0

0%

 Trade account payables

3,791,877

19.3%

3,178,990

-31.6%

4,644,504

40,039

9370.6%

 Tax and social liabilities

2,171,206

-10.3%

2,421,778

-18.8%

2,983,538

32,029

6678.9%

 Other debts and fixed assets liabilities

14,081,361

14.8%

12,261,728

22.2%

10,033,820

4,907

286894.0%

Account regularization

576,890

-19.0%

712,629

-8.7%

780,498

0

0%

Total liabilities

27,884,835

-4.4%

29,161,288

-4.7%

30,593,396

279,874

9863.4%

 

Results

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2016

Sales of Goods

27,358,025

-4.9%

28,772,014

-8.4%

31,397,705

375,002

7195.4%

Net turnover

25,681,407

-11.4%

28,976,852

-4.8%

30,451,383

365,790

6920.8%

 of which net export turnover

0

0%

0

0%

0

0

0%

Operating charges

28,509,944

-9.1%

31,370,646

-8.3%

34,222,779

368,128

7644.6%

Operating profit/loss

-1,151,919

55.7%

-2,598,632

8.0%

-2,825,074

7,297

-15886.2%

Financial income

1,118,149

64.7%

678,861

-71.3%

2,363,106

10

11181390.0%

Financial charges

331,966

-23.8%

435,926

-15.5%

516,041

508

65247.6%

Financial profit/loss

786,183

223.6%

242,935

-86.8%

1,847,065

-63

1257992.8%

Pretax net operating income

-365,736

84.5%

-2,355,697

-140.9%

-978,009

7,162

-5207.0%

Extraordinary income

710,925

-73.9%

2,726,706

81.2%

1,505,032

0

0%

Extraordinary charges

838,798

2.0%

821,989

-10.9%

922,672

136

618939.1%

Extraordinary profit/loss

-127,873

-106.7%

1,904,717

227.1%

582,360

0

0%

Net result

-388,990

12.1%

-442,412

-16.5%

-379,807

6,667

-5934.6%

 

Accounts - Active

Normal Account

31/12/2016

31/12/2014

31/12/2013

Months

12

12

12

 

Grand Total - Active Accounts (I to VI)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Grand Total (I to VI)

Net

27,884,835

-4.4%

29,161,287

-4.7%

30,593,397

Gross

CO

36,706,187

-9.4%

40,529,869

-0.8%

40,852,764

Amortisation

1A

8,821,352

-22.4%

11,368,582

10.8%

10,259,367

 

Non declared distributed capital (I)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

Gross

AA

0

0%

0

0%

0

 

Active fixed asset (II)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total Active fixed asset (II)

Net

11,816,818

-4.5%

12,372,254

8.8%

11,376,007

Gross

BJ

19,372,691

2.3%

18,938,082

8.5%

17,449,290

Amortisation

BK

7,555,873

15.1%

6,565,828

8.1%

6,073,283

 

Intangible fixed assets

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R&D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CQ

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

2,416

-88.7%

21,369

-35.4%

33,102

Gross

AF

478,847

0%

478,847

1.9%

470,109

Amortisation

AG

476,431

4.1%

457,478

4.7%

437,007

Goodwill

Net

3,856,710

-11.8%

4,370,719

45.5%

3,003,997

Gross

AH

4,140,741

-5.3%

4,370,719

45.5%

3,003,997

Amortisation

AI

284,031

0%

0

0%

0

Other intangible fixed assets

Net

0

0%

48,737

-41.4%

83,154

Gross

AJ

138,818

0%

138,818

0%

138,818

Amortisation

AK

138,818

54.1%

90,081

61.8%

55,664

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible asset

Net

3,859,126

-13.1%

4,440,825

42.3%

3,120,253

 

Tangible fixed assets

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Lands

Net

313,646

1.5%

308,899

-5.9%

328,317

Gross

AN

585,454

8.3%

540,779

0%

540,779

Amortisation

AO

271,808

17.2%

231,880

9.1%

212,462

Buildings

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AP

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AQ

0

0%

0

0%

0

Plant

Net

9,917

8.4%

9,147

-40.3%

15,316

Gross

AR

157,975

6.1%

148,922

0%

148,922

Amortisation

AS

148,058

5.9%

139,775

4.6%

133,606

Other tangible fixed assets

Net

1,371,240

-13.2%

1,579,003

-17.1%

1,904,824

Gross

AT

7,353,004

5.3%

6,986,074

0.7%

6,936,832

Amortisation

AU

5,981,764

10.6%

5,407,071

7.5%

5,032,008

Fixed assets in construction

Net

336,681

335.4%

77,322

129.7%

33,662

Gross

AV

336,681

335.4%

77,322

129.7%

33,662

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AX

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

Sub Total Tangible asset

Net

2,031,484

2.9%

1,974,371

-13.5%

2,282,119

 

Financial assets

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

5,302,000

0%

5,302,000

0%

5,302,000

Gross

CU

5,302,000

0%

5,302,000

0%

5,302,000

Amortisation

CV

0

0%

0

0%

0

Inter-company receivables

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BB

189,763

7.8%

176,075

25.5%

140,316

Amortisation

BC

189,763

7.8%

176,075

25.5%

140,316

Other investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BD

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BE

0

0%

0

0%

0

Loans

Net

1,618

0%

0

0%

995

Gross

BF

66,818

5.3%

63,468

0.4%

63,216

Amortisation

BG

65,200

2.7%

63,468

2.0%

62,221

Other financial assets

Net

622,590

-5.0%

655,058

-2.3%

670,639

Gross

BH

622,590

-5.0%

655,058

-2.3%

670,639

Amortisation

BI

0

0%

0

0%

0

Sub Total Financial assets

Net

5,926,208

-0.5%

5,957,058

-0.3%

5,973,634

 

Current Assets (III)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total Current Assets

Net

16,058,482

-4.2%

16,761,344

-12.6%

19,180,512

Gross

CJ

17,323,961

-19.7%

21,564,098

-7.7%

23,366,596

Amortisation

CK

1,265,479

-73.7%

4,802,754

14.7%

4,186,084

 

Stocks

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Raw materials

Net

0

0%

101,938

1309.2%

7,234

Gross

BL

71,946

-59.7%

178,307

105.2%

86,908

Amortisation

BM

71,946

-5.8%

76,369

-4.1%

79,674

Work in progress (goods)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BN

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

0

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

8,915,930

-4.9%

9,375,008

-10.4%

10,467,727

Gross

BR

9,798,179

-5.5%

10,363,578

-9.1%

11,403,951

Amortisation

BS

882,249

-10.8%

988,570

5.6%

936,224

Goods for resale

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BT

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BU

0

0%

0

0%

0

Sub Total Stocks

Net

8,915,930

-5.9%

9,476,946

-9.5%

10,474,961

 

Advance payments to suppliers

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Advance payments to suppliers

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BV

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0

 

Debtors

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Trade accounts receivable

Net

3,342,577

41.2%

2,366,595

-11.7%

2,679,583

Gross

BX

3,635,413

-1.5%

3,692,585

4.6%

3,531,183

Amortisation

BY

292,836

-77.9%

1,325,990

55.7%

851,600

Other debtors

Net

822,246

11.5%

737,719

-49.4%

1,459,383

Gross

BZ

826,882

-73.7%

3,142,821

-16.8%

3,777,970

Amortisation

CA

4,636

-99.8%

2,405,102

3.7%

2,318,587

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

Sub Total debtors

Net

4,164,823

34.2%

3,104,314

-25.0%

4,138,966

 

Divers

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Investment securities

Net

13,260

-34.8%

20,349

-24.8%

27,072

Gross

CD

27,072

0%

27,072

0%

27,072

Amortisation

CE

13,812

105.4%

6,723

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

2,193,201

-35.6%

3,407,453

-11.6%

3,854,921

Gross

CF

2,193,201

-35.6%

3,407,453

-11.6%

3,854,921

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

Sub Total Divers

Net

2,206,461

-35.6%

3,427,802

-11.7%

3,881,993

 

Prepaid expenses

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Prepaid expenses

Net

771,268

2.5%

752,282

9.9%

684,590

Gross

CH

771,268

2.5%

752,282

9.9%

684,590

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts (IV to VI)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Expenses of loan issue to be spread

CW3

8,163

-70.1%

27,306

-26.0%

36,878

Gross

8,163

-70.1%

27,306

-26.0%

36,878

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Currency differential gain

CN3

1,372

258.2%

383

0%

0

Gross

1,372

258.2%

383

0%

0

 

References

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

Accounts - Passive

Grand Total - Passive Accounts (I to V)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Grand Total (I to V)

EE

27,884,835

-4.4%

29,161,288

-4.7%

30,593,396

 

Shareholder Equity (I)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total shareholders' equity (Total I)

DL

6,540,991

-25.8%

8,813,118

-4.8%

9,255,530

Equity and shareholders' equity

DA

4,282,136

0%

4,282,136

0%

4,282,136

Issue and merger premiums

DB

6,329,647

0%

6,329,647

0%

6,329,647

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

Legal reserve

DD

329,066

0%

329,066

0%

329,066

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

Other reserves

DG

55,103

0%

55,103

0%

55,103

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

0%

0

0%

0

Profits or losses brought forward

DH

-4,065,971

-133.6%

-1,740,422

-27.9%

-1,360,616

Profit or loss for the period

DI

-388,990

12.1%

-442,412

-16.5%

-379,807

Investment grants

DJ

0

0%

0

0%

0

Special tax-allowable reserves

DK

0

0%

0

0%

0

 

Other capital resources (II)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

 

Provisions for risks and charges (III)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

221,155

-47.2%

419,092

-10.8%

470,082

Risk provisions

DP

221,155

-47.2%

419,092

-10.8%

470,082

Reserves for charges

DQ

0

0%

0

0%

0

 

Liabilities (IV)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total Liabilities (Total IV)

EC

21,122,589

6.0%

19,927,113

-4.5%

20,864,793

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

Bank loans and liabilities

DU

232,257

-78.8%

1,095,536

-46.7%

2,055,607

Sundry loans and financial liabilities

DV

269,098

4.1%

258,417

-30.1%

369,817

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

Advance payments received for current orders

DW

0

0%

0

0%

0

Trade accounts payables

DX

3,791,877

19.3%

3,178,990

-31.6%

4,644,504

Tax and social security liabilities

DY

2,171,206

-10.3%

2,421,778

-18.8%

2,983,538

Fixed asset liabilities

DZ

41,357

100.8%

20,593

18.0%

17,458

Other debts

EA

14,039,904

14.7%

12,239,170

22.2%

10,013,371

 

Translation loss (V)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Translation loss (Total V)

ED

100

-94.9%

1,965

-34.3%

2,991

 

Equalization accounts

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Deferred income

EB

576,890

-19.0%

712,629

-8.7%

780,498

 

References

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

0

0%

0

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

0

 

Result account

1 - Operating result (I-II)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Operating result (Total I-II)

GG

-1,151,919

55.7%

-2,598,632

8.0%

-2,825,074

 

2 - Financial result (V-VI)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Financial result (Total V-VI)

GV

786,183

223.6%

242,935

-86.8%

1,847,065

 

3 - Pre-tax net operating income result (I to VI)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

-365,736

84.5%

-2,355,697

-140.9%

-978,009

 

4 - Extraordinary result (VII-VIII)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

-127,873

-106.7%

1,904,717

227.1%

582,360

 

Profit or loss

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Profit or loss

HN

-388,990

12.1%

-442,412

-16.5%

-379,807

 

Total Income (I+III+V+VII)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total Income (Total I+III+V+VII)

HL

29,187,099

-9.3%

32,177,581

-8.8%

35,265,843

 

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

29,576,087

-9.3%

32,619,993

-8.5%

35,645,652

 

Operating income (I)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total operating income (Total I)

FR

27,358,025

-4.9%

28,772,014

-8.4%

31,397,705

 

Operating income (details)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Sale of goods for resale

FC

0

0%

0

0%

0

France

FA

0

0%

0

0%

0

Export

FB

0

0%

0

0%

0

Sale of goods produced

FF

24,554,993

-8.7%

26,900,407

-4.9%

28,287,107

France

FD

24,554,993

-8.7%

26,900,407

-4.9%

28,287,107

Export

FE

0

0%

0

0%

0

Sale of services

FI

1,126,414

-45.8%

2,076,445

-4.1%

2,164,276

France

FG

1,126,414

-45.8%

2,076,445

-4.1%

2,164,276

Export

FH

0

0%

0

0%

0

Net turnover

FL

25,681,407

-11.4%

28,976,852

-4.8%

30,451,383

France

FJ

25,681,407

-11.4%

28,976,852

-4.8%

30,451,384

Export

FK

0

0%

0

0%

0

Stocked production

FM

372,199

149.5%

-752,378

-281.9%

413,592

Self-constructed assets

FN

0

0%

0

0%

0

Operating grants

FO

0

0%

0

0%

0

Release of reserves and provisions

FP

1,214,592

468.9%

213,512

76.2%

121,210

Other income

FQ

89,827

-73.1%

334,028

-18.8%

411,520

 

Operating charges (II)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total operating charges (Total II)

GF

28,509,944

-9.1%

31,370,646

-8.3%

34,222,779

 

Exploitation charges

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Purchase of goods for resale

FS

0

0%

0

0%

0

Change in stocks of goods for resale

FT

0

0%

0

0%

0

Purchase of raw materials

FU

11,222,228

2.7%

10,925,778

-5.7%

11,581,213

Change in stocks of raw materials

FV

-667,508

-439.5%

196,596

-73.9%

752,180

Other external purchases and charges

FW

8,010,173

-12.0%

9,102,024

-16.4%

10,884,778

Tax, duty and similar payments

FX

444,401

-16.8%

534,221

5.8%

505,139

Payroll

FY

5,743,760

-13.4%

6,632,076

-0.8%

6,687,032

Social security costs

FZ

2,014,450

-20.0%

2,519,434

-3.5%

2,609,996

 

Depreciation

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Depreciation of fixed assets

GA

588,870

-19.3%

729,927

-3.5%

756,197

Amortisation of fixed assets

GB

115,822

0%

0

0%

0

Depreciation/amortisation of current assets

GC

79,035

-86.6%

589,100

271.1%

158,755

Provisions for risks and charges

GD

0

0%

54,127

-72.6%

197,885

 

Other charges

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Other charges

GE

958,713

997.4%

87,363

-2.5%

89,604

 

Operating charges (III-IV)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

 

Financial income (V)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total financial income (Total V)

GP

1,118,149

64.7%

678,861

-71.3%

2,363,106

Share financial income

GJ

0

0%

0

0%

0

Other investment income & capitalised receivables

GK

989,345

93.7%

510,797

-76.1%

2,138,822

Other interest and similar income

GL

3,242

-90.0%

32,408

-40.8%

54,699

Released provisions and transferred charges

GM

51,941

0%

0

0%

28,461

Exchange gains

GN

73,621

-45.7%

135,656

-3.9%

141,124

Net income from disposal of investment securities

GO

0

0%

0

0%

0

 

Financial charge (VI)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total financial charge (Total VI)

GU

331,966

-23.8%

435,926

-15.5%

516,041

Financial reserves and provisions

GQ

13,729

-89.5%

130,629

149.5%

52,351

Interest and similar charges

GR

271,519

-1.0%

274,286

-36.2%

430,246

Exchange losses

GS

46,718

50.6%

31,011

-7.3%

33,444

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary income (VII)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total extraordinary income (Total VII)

HD

710,925

-73.9%

2,726,706

81.2%

1,505,032

Extraordinary operating income

HA

13,106

-93.4%

198,392

0%

0

Extraordinary income from capital transactions

HB

643,011

-74.6%

2,528,314

80.3%

1,401,969

Released provisions and transferred charges

HC

54,808

0%

0

0%

103,063

 

Extraordinary charges (VIII)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

838,798

2.0%

821,989

-10.9%

922,672

Extraordinary operating charges

HE

385

-61.7%

1,006

-99.2%

130,501

Extraordinary charges from capital transactions

HF

539,616

-31.5%

787,505

10.9%

710,171

Extraordinary reserves and provisions

HG

298,797

792.5%

33,478

-59.2%

82,000

 

Employee profit sharing (IX)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

0

0%

0

0%

0

 

Tax on profits (X)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Tax on profits (Total X)

HK

-104,621

-1121.1%

-8,568

45.9%

-15,840

 

References

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

Of which transferred charges

A1

0

0%

0

0%

0

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

0

0%

0

 

Other incomes tax return forms

Fixed Assets

Grand Total Fixed Assets (I to IV)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

OK2

0

0%

1,035,703

0%

0

Gross value at the end of period

OL

0

0%

18,938,082

0%

0

 

Research and development Charge (Total I)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

CO1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

CO2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

DO

0

0%

0

0%

0

 

Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Gross value at begin of period

KD

0

0%

3,612,924

0%

0

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

0

0%

1,797,382

0%

0

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

LV2

0

0%

421,923

0%

0

Gross value at the end of period

LW

0

0%

4,988,383

0%

0

 

Tangible fixed assets (Total III)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Gross value at begin of period

LN

0

0%

7,703,855

0%

0

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

0

0%

663,023

0%

0

Decreasess by budget item transfer

NG1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NG2

0

0%

613,780

0%

0

Gross value at the end of period

NH

0

0%

7,753,098

0%

0

 

Financial assets (Total IV)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Gross value at begin of period

LQ

0

0%

5,957,058

0%

0

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

0

0%

239,543

0%

0

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NJ2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

NK

0

0%

6,196,601

0%

0

 

Reserve for depreciation

Situation and movement of reserve for depreciation - Grand total (I-II-III)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Reserve for depreciation value at begin of period

ON

0

0%

0

0%

0

Increases

OP

0

0%

0

0%

0

Decreasess

OQ

0

0%

0

0%

0

Reserve for depreciation value at the end of period

OR

0

0%

0

0%

0

 

Research and development charge (Total I)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0

 

Other intangible assets (Total II)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

0

0%

0

0%

0

Increases

PF

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PG

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

PH

0

0%

0

0%

0

 

Total fixed assets amotisation (Total III)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

6,182,050

0%

0

0%

0

Increases

QV

573,880

0%

0

0%

0

Decreases

QW

354,295

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

QX

6,401,635

0%

0

0%

0

 

Movements during period affecting charge allocated over several period

Deferred charges and debt issuance costs

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0

 

Premium refund of obligations

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Net value at begin of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

 

Provisions included in balance sheet

Grand Total (I-II-III)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Value at begining of period

7C

0

0%

0

0%

0

Increases

UB

0

0%

0

0%

0

Decreases

UC

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

UD

0

0%

0

0%

0

 

Includes Total allocations

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Operating

UE

0

0%

0

0%

0

Financial

UG

0

0%

0

0%

0

Exceptional

UJ

0

0%

0

0%

0

 

Includes Total Withdrawal

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Operating

UF

0

0%

0

0%

0

Financial

UH

0

0%

0

0%

0

Exceptional

UK

0

0%

0

0%

0

 

Total regulated provisions (Total I)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Value at begining of period

3Z

0

0%

0

0%

0

Increases

TS

0

0%

0

0%

0

Decreases

TT

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

TU

0

0%

0

0%

0

 

Total risk and charge provisions (Total II)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Value at begining of period

5Z

0

0%

0

0%

0

Increases

TV

0

0%

0

0%

0

Decreases

TW

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

TX

0

0%

0

0%

0

 

Total Provision for depreciation (Total III)

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Value at begining of period

7B

0

0%

0

0%

0

Increases

TY

0

0%

0

0%

0

Decreases

TZ

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

UA

0

0%

0

0%

0

 

State deadlines claims and debts at the end of period

State claims

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Gross value

VT

0

0%

8,482,289

0%

0

1 year at most

VU

0

0%

8,333,588

0%

0

More than one year

VV

0

0%

148,701

0%

0

 

State of loans

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Claims related to holdings (gross)

UL

0

0%

176,075

0%

0

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0

0%

176,075

0%

0

Loans (gross)

UP

0

0%

63,468

0%

0

Loans (1 year at most)

UR

0

0%

63,468

0%

0

Other financial assets (gross)

UT

0

0%

655,058

0%

0

Other financial assets (1 year at most)

UV

0

0%

655,058

0%

0

 

Receivables statement of assets

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Customers doubtful or disputed

VA

0

0%

0

0%

0

Other claims customer

UX

0

0%

3,692,585

0%

0

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts

UY

0

0%

20,407

0%

0

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

5,634

0%

0

Income taxes

VM

0

0%

133,859

0%

0

Value added tax

VB

0

0%

182,636

0%

0

Other taxes and payments assimilated

VN

0

0%

32,608

0%

0

State and other public - Miscellaneous

VP

0

0%

2,405,102

0%

0

Group and Associates

VC

0

0%

0

0%

0

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

0

0%

362,575

0%

0

 

Prepaid

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Prepaid

VS

0

0%

752,282

0%

0

 

State Debt

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total debt (gross)

VY

0

0%

19,927,113

0%

0

1 year at most

VZ2

0

0%

19,927,113

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

VZ4

0

0%

0

0%

0

 

Details

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

0

0%

1,095,536

0%

0

1 year at most

VG2

0

0%

1,095,536

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VH2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

0%

0

0%

0

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8A2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8A3

0

0%

0

0%

0

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

0

0%

3,178,990

0%

0

1 year at most

8B2

0

0%

3,178,990

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8B3

0

0%

3,178,990

0%

0

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8C2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

0

0%

2,421,778

0%

0

1 year at most

8D2

0

0%

2,421,778

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (Gross)

VW1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VW2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VQ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

0

0%

20,593

0%

0

1 year at most

8J2

0

0%

20,593

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

258,417

0%

0

1 year at most

VI2

0

0%

258,417

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

V14

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

0

0%

12,239,170

0%

0

1 year at most

8K2

0

0%

12,239,170

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

0

0%

712,629

0%

0

1 year at most

8L2

0

0%

712,629

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

0

0%

0

 

References

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Loans made during the period

VJ

0

0%

0

0%

0

Debt repaid during the period

VK

0

0%

0

0%

0

 

Table allocation results and other information

Dividends distributed

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0

 

Commitments

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0

 

Other charges Externes

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0

 

Taxes and Fees

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0

 

VAT

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0

 

Average number of employees

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Average number of employees

YP

177

-18.4%

217

10750.0%

2

 

Groups and Shareholders

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Groups and Shareholders

ZR

0

-

-

-

-

 

Ratios

Synthetic financial performance indicators

31/12/2016

31/12/2014

31/12/2013

Score

Situation

Score

Situation

Score

Situation

HideAFDCC 2

-

-

0.96

Fragility +

-

-

Description

The AFDCC 2 score uses sectors of activity and company sizes for companies with a turnover of 150 000 to 75 million euros. This calculation allows a classification of the companies in three levels:

-

Healthy: the higher the score value is, the more the company is healthy.

-

Undetermined: it’s impossible to determine the situation.

-

Fragility/Failure: the lower the score value is, the more the company is in danger.

The status are completed which “+/-“ signs.

HideConan & Holder

-0.06

90%

-0.15

90%

-0.13

90%

Description

The Conan and Holder (1979) is a recommended method for industrial companies with a turnover of 150 000 to 75 million euros. It is based only on a balance sheet. This calculation allows a classification of the most perilous situation (Score lower than 0.002) to the healthiest situation (score greater than 0.16):

-

Healthy situation: companies which maintain or develop their activity level.

-

Situation to monitor: companies which has to follow remedial measures or find a new strategy.

-

Perilous situation: companies which could have important cash difficulties and have a failure risk.

HideAltman

-

-

-

-

-

-

Description

The Altman score is a method based only on a complete balance sheet, this calculation allows a classification of the companies in three levels:

-

Good shape: companies which have a low risk (with a score value higher than 2.99).

-

Warning signs: companies which should be approached with caution and with a high risk in the next two years for bankruptcy (with a score value between 2.99 and 1.81).

-

Bankruptcy: companies which are in immediate risk (with a score value lower than 1.81).

 

Structure and Liquidity

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2016

Fixed Asset Financing

0.76

-16.5%

0.91

-12.5%

1.04

2.69

-71.7%

Global Debt

296 days

19.4%

248 days

0.4%

247 days

120 days

146.7%

Working Capital Fund overall net

-64 days

-190.9%

-22 days

-344.4%

9 days

86 days

-174.4%

Financial independence

1,304.66 %

100.4%

650.92 %

70.6%

381.60 %

200.41 %

551.0%

Solvability

23.46 %

-22.4%

30.22 %

-0.1%

30.25 %

39.58 %

-40.7%

Capacity debt futures

-

-

804.46 %

-

-

1,522.10 %

-

Coverage of current assets by net working capital overall

-27.46 %

-220.4%

-8.57 %

-351.3%

3.41 %

49.93 %

-155.0%

General Liquidity

-

-

0.42

-

-

0.57

-

Restricted Liquidity

-

-

0.59

-

-

1.03

-

 

Management or rotation

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2016

Need background in operating working capital

88 days

12.8%

78 days

20.0%

65 days

36 days

144.4%

Treasury

31 days

-27.9%

43 days

-6.5%

46 days

16 days

93.8%

Inventory turnover of goods

-

-

-

-

-

99 days

-

Average length of credit granted to customers

51 days

10.9%

46 days

9.5%

42 days

41 days

24.4%

Average length of credit obtained suppliers

74 days

29.8%

57 days

-20.8%

72 days

52 days

42.3%

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

2 days

-66.7%

6 days

100.0%

3 days

0 days

0%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

-

-

374 days

-

-

1,264 days

-

Rotation tangible assets

-

-

373.75 %

-

-

1,190.77 %

-

 

Profitability of the business

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2016

Margin trading

0.00 %

0%

0.00 %

0%

0.00 %

32.26 %

0%

Profitability of the business

-2.78 %

52.2%

-5.82 %

17.8%

-7.08 %

3.15 %

-188.3%

Net profit

-1.51 %

1.3%

-1.53 %

-22.4%

-1.25 %

1.96 %

-177.0%

Growth rate of turnover (excluding VAT)

0.00 %

0%

-4.84 %

0%

0.00 %

0.00 %

0%

Rates integration

29.16 %

5.6%

27.61 %

10.0%

25.11 %

20.24 %

44.1%

Rate leasing furniture

0.00 %

0%

0.00 %

0%

0.00 %

0.00 %

0%

Work Factor

103.60 %

-9.4%

114.39 %

-5.9%

121.58 %

67.64 %

53.2%

Weight interests

1.29 %

-14.0%

1.50 %

-11.2%

1.69 %

0.14 %

821.4%

 

Return on capital

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2016

Cash flow from the overall profitability

2.04 %

145.8%

-4.45 %

-654.2%

-0.59 %

2.82 %

-27.7%

Rates of economic profitability

-10.00 %

41.2%

-17.00 %

5.6%

-18.00 %

10.00 %

-200.0%

Financial profitability

6,540,991.00 %

-25.8%

8,813,118.00 %

-4.8%

9,255,530.00 %

64,055.00 %

10111.5%

Return on investment

-0.81 %

-1250.0%

-0.06 %

-105.1%

1.17 %

7.62 %

-110.6%

 

Management intermediate balances

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2016

Turnover

25,681,407

-11.4%

28,976,852

-4.8%

30,451,383

365,790

6920.8%

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2016

Sales of goods

0

0%

0

0%

0

-

- Purchase of goods

0

0%

0

0%

0

-

+/- Stock of goods variation

0

0%

0

0%

0

-

Trading margin

0 €

0%

0 €

0%

0 €

95,374 €

0%

0.00 % CA

0%

0.00 % CA

0%

0.00 % CA

33.09 % CA

0%

 

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2016

Sale of goods produced

25,681,407

-11.4%

28,976,852

-4.8%

30,451,383

-

+/- Stocked production

372,199

149.5%

-752,378

-281.9%

413,592

-

+ Self-constructed assets

0

0%

0

0%

0

-

Period production

26,053,606 €

-7.7%

28,224,474 €

-8.6%

30,864,975 €

9,706 €

268327.8%

101.45 % CA

4.2%

97.40 % CA

-3.9%

101.36 % CA

2.81 % CA

3510.3%

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2016

Trading margin

0

0%

0

0%

0

95,374

0%

+ Period Production

26,053,606

-7.7%

28,224,474

-8.6%

30,864,975

9,706

268327.8%

- Purchase of raw materials

11,222,228

2.7%

10,925,778

-5.7%

11,581,213

-

+/- Change in stocks of raw materiels

-667,508

-439.5%

196,596

-73.9%

752,180

-

- Other external purchases and charges

8,010,173

-12.0%

9,102,024

-16.4%

10,884,778

-

Added value

7,488,713 €

-6.4%

8,000,076 €

4.6%

7,646,804 €

81,250 €

9116.9%

29.16 % CA

5.6%

27.61 % CA

10.0%

25.11 % CA

20.22 % CA

44.2%

 

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2016

Added value

7,488,713 €

-6.4%

8,000,076 €

4.6%

7,646,804 €

81,250 €

9116.9%

+ Operating grants

0

0%

0

0%

0

-

- Tax, duty and similar payments

444,401

-16.8%

534,221

5.8%

505,139

-

- Personal charges

7,758,210

-15.2%

9,151,510

-1.6%

9,297,028

-

Gross operating surplus

-713,898 €

57.6%

-1,685,655 €

21.8%

-2,155,363 €

10,542 €

-6871.9%

-2.78 % CA

52.2%

-5.82 % CA

17.8%

-7.08 % CA

3.15 % CA

-188.3%

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2016

Gross operating surplus

-713,898 €

57.6%

-1,685,655 €

21.8%

-2,155,363 €

10,542 €

-6871.9%

+ Release of reserves and provisions

1,214,592

468.9%

213,512

76.2%

121,210

-

+ Other operating income

89,827

-73.1%

334,028

-18.8%

411,520

-

- Depreciation/ Amortisation

783,727

-42.9%

1,373,154

23.4%

1,112,837

-

- Other charges

958,713

997.4%

87,363

-2.5%

89,604

-

Operating result

-1,151,919 €

55.7%

-2,598,632 €

8.0%

-2,825,074 €

7,292 €

-15897.0%

-4.49 % CA

49.9%

-8.97 % CA

3.3%

-9.28 % CA

2.32 % CA

-293.5%

 

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2016

Operating result

-1,151,919 €

55.7%

-2,598,632 €

8.0%

-2,825,074 €

7,292 €

-15897.0%

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

-

+ Financial income

1,118,149

64.7%

678,861

-71.3%

2,363,106

-

- Financial charges

331,966

-23.8%

435,926

-15.5%

516,041

-

Pre-tax result

-365,736 €

84.5%

-2,355,697 €

-140.9%

-978,009 €

7,155 €

-5211.6%

-1.42 % CA

82.5%

-8.13 % CA

-153.3%

-3.21 % CA

2.17 % CA

-165.4%

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2016

Extraordinary income

710,925

-73.9%

2,726,706

81.2%

1,505,032

0

0%

- Extraordinary charges

838,798

2.0%

821,989

-10.9%

922,672

-

Extraordinary result

-127,873 €

-106.7%

1,904,717 €

227.1%

582,360 €

0 €

0%

-0.50 % CA

-107.6%

6.57 % CA

244.0%

1.91 % CA

0.00 % CA

0%

 

31/12/2016

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2016

Pre-tax result

-365,736 €

84.5%

-2,355,697 €

-140.9%

-978,009 €

7,155 €

-5211.6%

Extraordinary result

-127,873 €

-106.7%

1,904,717 €

227.1%

582,360 €

0 €

0%

- Employee profit sharing

0

0%

0

0%

0

-

- Tax on profits

-104,621

-1121.1%

-8,568

45.9%

-15,840

-

Net result

-388,988 €

12.1%

-442,412 €

-16.5%

-379,809 €

6,653 €

-5947.2%

-1.51 % CA

1.3%

-1.53 % CA

-22.4%

-1.25 % CA

1.96 % CA

-177.0%

 

Synthesized Accounts

31/12/2014

31/12/2011

Account period (month)

12

12

Account Type

Consolidated

Consolidated

Activity Code

4649Z

4649Z

 

Active account

31/12/2014

Variation

31/12/2011

Capital not called

0

0%

0

Total fixed assets

11,442,000

0%

0

 Intangible assets

4,454,000

0%

0

 Tangible assets

4,039,000

0%

0

 Financial assets

2,731,000

0%

0

Net current assets

31,737,000

0%

0

 Stocks

15,200,000

0%

0

 Advanced payments

0

0%

0

 Receivables

12,827,000

0%

0

 Securities and cash

3,710,000

0%

0

Accounts of regularization

0

0%

0

Total Assets

43,179,000

0%

0

 

Passive account

31/12/2014

Variation

31/12/2011

Shareholders' equity

7,121,000

0%

0

Share capital

4,282,000

0%

0

Other capital resources

0

0%

0

Risk Provisions

3,315,000

0%

0

Liabilities

32,743,000

0%

0

 Financial liabilities

20,804,000

0%

0

 Advanced payments received

0

0%

0

 Trade account payables

11,939,000

0%

0

 Tax and social liabilities

0

0%

0

 Other debts and fixed assets liabilities

0

0%

0

Account regularization

0

0%

0

Total liabilities

43,179,000

0%

0

 

Results

31/12/2014

Variation

31/12/2011

Sales of Goods

59,098,000

0%

0

Net turnover

55,920,000

0%

0

 of which net export turnover

0

0%

0

Operating charges

59,883,000

0%

0

Operating profit/loss

-785,000

0%

0

Financial income

225,000

0%

0

Financial charges

67,000

0%

0

Financial profit/loss

158,000

0%

0

Pretax net operating income

-627,000

0%

0

Extraordinary income

0

0%

0

Extraordinary charges

0

0%

0

Extraordinary profit/loss

0

0%

0

 

Consolidation

31/12/2014

Variation

31/12/2011

Net result before amortisation of goodwill

-2,334,000

0%

0

Goodwill amortisation allocation

0

0%

0

Net result of equity affiliates companies

0

0%

0

Net result of integrated companies

0

0%

0

Group result (consolidated net result)

-2,334,000

0%

0

Share of minority interest (Result except group)

0

0%

0

Net result - group share (part of parent company)

-2,334,000

0%

0

 

Accounts - Active

Normal Account

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Account period (month)

12

12

12

 

Grand Total - Active Accounts (I to VI)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Grand Total (I to VI)

Net

0

0%

0

0%

43,179,000

Gross

CO

0

0%

0

0%

43,179,000

Amortisation

1A

0

0%

0

0%

0

 

Capital subscribed not called (I)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Capital suscribed not called (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

 

Active fixed asset (II)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total Active fixed asset (II)

Net

0

0%

0

0%

11,442,000

Gross

BJ

0

0%

0

0%

11,442,000

Amortisation

BK

0

0%

0

0%

0

 

Intangible fixed assets

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R&D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CQ

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AF

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AG

0

0%

0

0%

0

Goodwill

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AH

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AI

0

0%

0

0%

0

Other intangible fixed assets

Net

0

0%

0

0%

4,454,000

Gross

AJ

0

0%

0

0%

4,454,000

Amortisation

AK

0

0%

0

0%

0

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible asset

Net

0

0%

0

0%

4,454,000

 

Tangible fixed assets

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Acquisition difference

Net

0

0%

0

0%

218,000

Gross

A11

0

0%

0

0%

218,000

Amortisation

A12

0

0%

0

0%

0

Goodwill

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

A21

0

0%

0

0%

0

Amortisation

A22

0

0%

0

0%

0

Difference from the first consolidation

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

A31

0

0%

0

0%

0

Amortisation

A32

0

0%

0

0%

0

Lands

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AN

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AO

0

0%

0

0%

0

Buildings

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AP

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AQ

0

0%

0

0%

0

Plant

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AR

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AS

0

0%

0

0%

0

Other tangible fixed assets

Net

0

0%

0

0%

4,039,000

Gross

AT

0

0%

0

0%

4,039,000

Amortisation

AU

0

0%

0

0%

0

Fixed assets in construction

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AV

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AX

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

Sub Total Tangible asset

Net

0

0%

0

0%

4,257,000

 

Financial assets

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CU

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CV

0

0%

0

0%

0

Inter-company receivables

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BC

0

0%

0

0%

0

Other investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BD

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BE

0

0%

0

0%

0

Loans

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BF

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BG

0

0%

0

0%

0

Other financial assets

Net

0

0%

0

0%

2,731,000

Gross

BH

0

0%

0

0%

2,731,000

Amortisation

BI

0

0%

0

0%

0

Other financial assets

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

A41

0

0%

0

0%

0

Amortisation

A42

0

0%

0

0%

0

Sub Total Financial assets

Net

0

0%

0

0%

2,731,000

 

Current Assets (III)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total Assets

Net

0

0%

0

0%

31,737,000

Gross

CJ

0

0%

0

0%

31,737,000

Amortisation

CK

0

0%

0

0%

0

 

Stocks

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Raw materials

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BL

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BM

0

0%

0

0%

0

Work in progress (goods)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BN

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

0

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BR

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BS

0

0%

0

0%

0

Goods for resale

Net

0

0%

0

0%

15,200,000

Gross

BT

0

0%

0

0%

15,200,000

Amortisation

BU

0

0%

0

0%

0

Sub Total Stocks

Net

0

0%

0

0%

15,200,000

 

Advance payments to suppliers

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Advance payments to suppliers

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BV

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0

 

Debtors

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Trade accounts receivable

Net

0

0%

0

0%

12,827,000

Gross

BX

0

0%

0

0%

12,827,000

Amortisation

BY

0

0%

0

0%

0

Other debtors

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BZ

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CA

0

0%

0

0%

0

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

Sub Total debtors

Net

0

0%

0

0%

12,827,000

 

Divers

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CD

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CE

0

0%

0

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

0

0%

0

0%

3,710,000

Gross

CF

0

0%

0

0%

3,710,000

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

Sub Total Divers

Net

0

0%

0

0%

0

 

Prepaid expenses

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Prepaid expenses

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CH

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts (IV to VI)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Expenses of loan issue to be spread

CW3

0

0%

0

0%

0

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

Currency differential gain

CN3

0

0%

0

0%

0

 

References

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

Accounts - Passive

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Grand Total (I to IV)

EE

0

0%

0

0%

43,179,000

 

Shareholder Equity (I)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total shareholders' equity (Total I)

DL

0

0%

0

0%

7,121,000

Equity and shareholders' equity

DA

0

0%

0

0%

4,282,000

Issue and merger premiums

DB

0

0%

0

0%

6,379,000

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

Legal reserve

DD

0

0%

0

0%

0

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

Other reserves

DG

0

0%

0

0%

-1,206,000

Profits or losses brought forward

DH

0

0%

0

0%

0

Conversion differences

P1

0

0%

0

0%

0

Net result - group part

P2

0

0%

0

0%

-2,334,000

Investment grants

DJ

0

0%

0

0%

0

Special tax-allowable reserves

DK

0

0%

0

0%

0

 

Other capital resources (II)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

Others

P3

0

0%

0

0%

0

 

Provisions for risks and charges (III)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

0

0%

0

0%

3,315,000

Conversion differences

P4

0

0%

0

0%

0

In reserves

P5

0

0%

0

0%

0

In results

P6

0

0%

0

0%

0

Total III

P7

0

0%

0

0%

0

Delayed tax

P8

0

0%

0

0%

0

Acquisition differences

P9

0

0%

0

0%

0

Risk provisions

DP

0

0%

0

0%

692,000

Reserves for charges

DQ

0

0%

0

0%

2,623,000

 

Liabilities (IV)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total Liabilities (Total IV)

EC

0

0%

0

0%

32,743,000

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

Bank loans and liabilities

DU

0

0%

0

0%

20,804,000

Sundry loans and financial liabilities

DV

0

0%

0

0%

0

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

Advance payments received for current orders

DW

0

0%

0

0%

0

Trade accounts payables

DX

0

0%

0

0%

11,939,000

Tax and social security liabilities

DY

0

0%

0

0%

0

Fixed asset liabilities

DZ

0

0%

0

0%

0

Other debts

EA

0

0%

0

0%

0

 

Translation loss (V)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Translation loss (Total V)

ED

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Deferred income

EB

0

0%

0

0%

0

 

References

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

0

0%

0

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

0

 

Result account

1- Operating result (I-II)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Operating result (Total I-II)

GG

0

0%

0

0%

-785,000

 

2 - Financial result (V - VI)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Financial result (Total V-VI)

GV

0

0%

0

0%

158,000

 

3 - Pre-tax net operating income result (I - VI)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

0

0%

0

0%

-627,000

 

4 - Extraordinary result (VII-VIII)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

0

0%

0

0%

0

 

Consolidation

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Delayed tax

R1

0

0%

0

0%

-923,000

Net result before amortisation of acquisition differences

R2

0

0%

0

0%

-2,334,000

Endowment to amortisation of acquisition differences

R3

0

0%

0

0%

0

Net result of companies set in equivalence

R4

0

0%

0

0%

0

Net result of integrated companies

R5

0

0%

0

0%

0

Group result (consolidated net result)

R6

0

0%

0

0%

-2,334,000

Cross-reference : equipment leasing

R7

0

0%

0

0%

0

Cross-reference : property leasing

R8

0

0%

0

0%

-2,334,000

 

Operating income (I)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total operating income (Total I)

FR

0

0%

0

0%

59,098,000

 

Operating income (details)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Sale of goods for resale

FC

0

0%

0

0%

55,920,000

France

FA

0

0%

0

0%

55,920,000

Export

FB

0

0%

0

0%

0

Sale of goods produced

FF

0

0%

0

0%

0

France

FD

0

0%

0

0%

0

Export

FE

0

0%

0

0%

0

Sale of services

FI

0

0%

0

0%

0

France

FG

0

0%

0

0%

0

Export

FH

0

0%

0

0%

0

Net turnover

FL

0

0%

0

0%

55,920,000

France

FJ

0

0%

0

0%

55,920,000

Export

FK

0

0%

0

0%

0

Stocked production

FM

0

0%

0

0%

0

Self-constructed assets

FN

0

0%

0

0%

0

Operating grants

FO

0

0%

0

0%

0

Release of reserves and provisions

FP

0

0%

0

0%

0

Other income

FQ

0

0%

0

0%

3,178,000

 

Operating charges (II)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total operating charges (Total II)

GF

0

0%

0

0%

59,883,000

 

Exploitation charges

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Purchase of goods for resale

FS

0

0%

0

0%

24,341,000

Change in stocks of goods for resale

FT

0

0%

0

0%

965,000

Purchase of raw materials

FU

0

0%

0

0%

0

Change in stocks of raw materials

FV

0

0%

0

0%

0

Other external purchases and charges

FW

0

0%

0

0%

11,213,000

Tax, duty and similar payments

FX

0

0%

0

0%

1,109,000

Payroll

FY

0

0%

0

0%

0

Social security costs

FZ

0

0%

0

0%

19,874,000

 

Depreciation

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Depreciation of fixed assets

GA

0

0%

0

0%

1,552,000

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

0

0%

0

Depreciation/amortisation of current assets

GC

0

0%

0

0%

0

Provisions for risks and charges

GD

0

0%

0

0%

0

 

Other charges

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Other charges

GE

0

0%

0

0%

829,000

 

Operating charges (III-IV)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

 

Financial income (V)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total financial income (Total V)

GP

0

0%

0

0%

225,000

Share financial income

GJ

0

0%

0

0%

0

Other investment income & capitalised receivables

GK

0

0%

0

0%

0

Other interest and similar income

GL

0

0%

0

0%

225,000

Released provisions and transferred charges

GM

0

0%

0

0%

0

Exchange gains

GN

0

0%

0

0%

0

Net income from disposal of investment securities

GO

0

0%

0

0%

0

 

Financial charge (VI)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total financial charge (Total VI)

GU

0

0%

0

0%

67,000

Financial reserves and provisions

GQ

0

0%

0

0%

0

Interest and similar charges

GR

0

0%

0

0%

67,000

Exchange losses

GS

0

0%

0

0%

0

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary income (VII)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total extraordinary income (Total VII)

HD

0

0%

0

0%

0

Extraordinary operating income

HA

0

0%

0

0%

0

Extraordinary income from capital transactions

HB

0

0%

0

0%

0

Released provisions and transferred charges

HC

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary charges (VIII)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

0

0%

0

0%

0

Extraordinary operating charges

HE

0

0%

0

0%

0

Extraordinary charges from capital transactions

HF

0

0%

0

0%

0

Extraordinary reserves and provisions

HG

0

0%

0

0%

0

 

Employee profit sharing (IX)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

0

0%

0

0%

0

 

Tax on profits (X)

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Tax on profits (Total X)

HK

0

0%

0

0%

19,000

 

References

31/12/2016

Variation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

 

Key Performance Indicators

 

Find below a comparison of the company based on the industry code (primary) with other companies from the same industry. The following analysis has been based on the industry code 4649Z - Wholesale (intercompany trade) of other household goods.

 

Graphical analysis

 

Net Turnover Company Result Sector Average 31/12/201631/12/201431/12/20130M10M20M30M40M

31/12/2016

31/12/2014

31/12/2013

Company Result

25,681,407 €

28,976,852 €

30,451,383 €

Sector Average

6,032,877 €

4,710,524 €

4,577,155 €

 

Net Profit Company Result Sector Average 31/12/201631/12/201431/12/2013-500k0k500k1,000k

31/12/2016

31/12/2014

31/12/2013

Company Result

-388,990 €

-442,412 €

-379,807 €

Sector Average

605,507 €

429,326 €

430,642 €

 

Net Export TurnoverCompany ResultSector Average31/12/201631/12/201431/12/20130k500k1,000k1,500k

31/12/2016

31/12/2014

31/12/2013

Company Result

0 €

0 €

0 €

Sector Average

1,335,791 €

1,080,789 €

1,181,161 €

 

Account Total Company Result Sector Average31/12/201631/12/201431/12/20130M10M20M30M40M

31/12/2016

31/12/2014

31/12/2013

Company Result

27,884,835 €

29,161,288 €

30,593,396 €

Sector Average

15,365,212 €

3,616,639 €

3,602,555 €

 

Shareholders Equity Company Result Sector Average31/12/201631/12/201431/12/20130M5M10M

31/12/2016

31/12/2014

31/12/2013

Company Result

6,540,991 €

8,813,118 €

9,255,530 €

Sector Average

2,511,540 €

1,761,408 €

1,767,333 €

 

Liabilities Company Result Sector Average31/12/201631/12/201431/12/20130M10M20M30M

31/12/2016

31/12/2014

31/12/2013

Company Result

21,122,589 €

19,927,113 €

20,864,793 €

Sector Average

12,014,073 €

1,670,839 €

1,663,382 €

 

Need background in operating working capital Company Result Sector Average31/12/201631/12/201431/12/20130250500750

31/12/2016

31/12/2014

31/12/2013

Company Result

88 €

78 €

65 €

Sector Average

45 €

529 €

297 €

 

Gross operating surplus (EBE)Company Result Sector Average31/12/201631/12/201431/12/2013-3M-2M-1M0M1M

31/12/2016

31/12/2014

31/12/2013

Company Result

-713,898 €

-1,685,655 €

-2,155,363 €

Sector Average

490,335 €

373,826 €

283,163 €

 

 

 

 

 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

INR 64.90

UK Pound

1

INR 91.87

Euro

1

INR 80.25

Euro

1

INR 80.78

 

Note : Above are approximate rates obtained from sources believed to be correct

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

VAR

 

 

Report Prepared by :

TPT

 


 

RATING EXPLANATIONS

 

Credit Rating

 

Explanation

Rating Comments

A++

Minimum Risk

Business dealings permissible with minimum risk of default

A+

Low Risk

Business dealings permissible with low risk of default

A

Acceptable Risk

Business dealings permissible with moderate risk of default

B

Medium Risk

Business dealings permissible on a regular monitoring basis

C

Medium High Risk

Business dealings permissible preferably on secured basis

D

High Risk

Business dealing not recommended or on secured terms only

NB

New Business

No recommendation can be done due to business in infancy stage

NT

No Trace

No recommendation can be done as the business is not traceable

 

NB is stated where there is insufficient information to facilitate rating. However, it is not to be considered as unfavourable.

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors are as follows:

 

·         Financial condition covering various ratios

·         Company background and operations size

·         Promoters / Management background

·         Payment record

·         Litigation against the subject

·         Industry scenario / competitor analysis

·         Supplier / Customer / Banker review (wherever available)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.