MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

500512

Report Date :

27.03.2018

 

 

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

SAS FRIAL

 

 

Registered Office :

SAS Frial 6 Route De Caen 14400 St Martin Des Entrees

 

 

Country :

France

 

 

Date of Incorporation :

August 1980

 

 

Legal Form :

Simplified joint stock company

 

 

Line of Business :

Manufacture of prepared meals

 

 

No. of Employees :

50 to 99

 

 

RATING & COMMENTS

(Mira Inform has adopted New Rating mechanism w.e.f. 23rd January 2017)

 

MIRA’s Rating :

B

 

Credit Rating

Explanation

Rating Comments

B

Medium Risk

Business dealings permissible on a regular monitoring basis

 

Status :

Moderate

 

 

Payment Behaviour :

Unknown

 

 

Litigation :

Clear  

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List

 

Country Name

Previous Rating

(30.09.2017)

Current Rating

(31.12.2017)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low Risk

 

A2

Moderately Low Risk

 

B1

Moderate Risk

 

B2

Moderately High Risk

 

C1

High Risk

 

C2

Very High Risk

 

D

 


 

FRANCE - ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. France is the most visited country in the world with 83 million foreign tourists in 2016, including 530,000 visitors for the 2016 Euro Cup. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that mitigate economic inequality.

France's real GDP grew by 1.6% in 2017, up from 1.2% the year before. The unemployment rate (including overseas territories) increased from 7.8% in 2008 to 10.2% in 2015, before falling to 9.5% in 2017. Youth unemployment in metropolitan France decreased from 24.6% in the fourth quarter of 2014 to 24% in the fourth quarter of 2016.

France’s public finances have historically been strained by high spending and low growth. Despite measures to restore public finances, the budget deficit rose from 3.3% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009. In 2017, the budget deficit improved to 2.9% of GDP, bringing it in compliance with the EU-mandated 3% deficit target. Meanwhile, France's public debt rose from 89.5% of GDP in 2012 to 96.9% in 2017.

Since entering office in May 2017, President Emmanuel MACRON launched a series of economic reforms to improve competitiveness and boost economic growth. President MACRON campaigned on reforming France’s labor code and in late 2017 implemented a range of reforms to increase flexibility in the labor market by making it easier for firms to hire and fire and simplifying negotiations between employers and employees. In addition to labor reforms, President MACRON’s proposed 2018 budget cuts public spending, taxes, and social security contributions to spur private investment and increase purchasing power.

 

Source : CIA

 


Company summery

 

SIRET

319 805 974 00015

Name

SAS FRIAL

Acronym

-

Trade name

-

Status

Economically active

Postal Address

SAS FRIAL
6 ROUTE DE CAEN
14400 ST MARTIN DES ENTREES
FRANCE

Share Capital

4,352,000 Euros

Telephone

02 31 51 48 48

Activity (APE)

Manufacture of prepared meals (1085Z)

RCS Registration

RCS Caen B 319 805 974

Formation Date

08/1980

EUR VAT Number

FR52319805974

Deregistration Date

-

Last account Date

-

Court Registry Number

19 8 0B40021

Incorporiation Date

09/1980

Registration Court

Caen (14)

Fax

02 31 21 47 65

Nationality

France

Legal form

Simplified joint stock company

Currency

Euros

 

 

Directors

 

Current Directors

6

 

 

Ultimate Holding Company

 

Name

Country

Company Number

FROZEN HOLDING

B136588

Affiliation links.

 

 

Judgment and Preferential

 

Judgment

No judgement

Preferential Right

No social security and tax office preferential right to date

 

Establishment Details

 

Type of Establishment

Head Office

Production Role

-

APE/NAF Code

1085Z

Activity

Manufacture of prepared meals

Formation Date

08/1980

Reason for Formation

Formation

Closure Date

-

Reason for Closure

-

Reactivation Date

-

Seasonality

-

Activity Nature

-

Activity Location

Other

Trading Address

6 ROUTE DE CAEN
14400 SAINT MARTIN DES ENTREES

Department

Calvados (14)

Location Surface

-

District

1

City

SAINT MARTIN DES ENTREES

Status

Economically active

Business Pages FT®

SURGELES: PRODUITS ALIMENTAIRES (FABRICATION, GROS)

Region

-

Area

02

Size of Urban Area

-

 

Other Establishment(s)

Regionality

Legal unit with all establishments in same area

Mono-activity status

Legal unit having all establishments with the same main activity

Branches

2 branch entities in this company

 

Company Name

Company Type

APE/NAF Code

Activity

City

Post Code

SAS FRIAL

Head Office

1085Z

Manufacture of prepared meals

SAINT MARTIN DES ENTREES

14400

SAS FRIAL

Branch

1085Z

Manufacture of prepared meals

BAYEUX

14400

 

 

Workforces

Workforce at address

50 to 99 employees

Company workforce

50 to 99 employees

 

 

Workforce account

-

 

 

 

 

 

Commentary

The comments are ordered according to the class of risk. Companies are compared with regard to other companies of the same type. Thus a positive comment for one category can be negative for another or can change depending on its value. This is a purely statistical decision.

 

High risk workforce size

The company is 37 years old

 

Industry comparison

Activity (APE)

Manufacture of prepared meals (1085Z)

 

Collective procedures

No judgment information for the company

 

 

Preferential rights details and history

 

Summary of preferential rights

Company monitored since

30/07/2008

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

 

Group Data

Ultimate parent company

FROZEN HOLDING

Direct parent

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET PRODUCTION EN AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION - 95 %

Group – Number of companies

7

Linkages – Number of companies

-

Number of countries

-

 

 

 

Name

SIREN

Parts

Last account published

1

FROZEN HOLDING S.A.

B136588

-

31/03/2017

2

GLACIES HOLDING

485376479

100 %

31/01/2007

3

DEVEL PROD AGRO ALIMENT RESTAUR

477890388

100 %

31/12/2006

4

SAS FRIAL

319805974

95 %

-

5

ERIMER

408515286

85 %

31/03/2014

6

SARL SAINT GUEFROID

353485428

99 %

31/03/2015

COFA

342661535

100 %

31/03/2012

 

Linkages

No Linkages information available for the company.

 

 

Shareholder(s)

Name

GLACIES HOLDING

Name of representative

Manager position

President

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

Director(s)

Name

M. PIRANDA JEAN-MARIE

Manager position

President of the supervisory council

Date of birth

06/04/1954

Place of birth

LAVIRON (25)

Type

Individual

Name at birth

 

Statutory Auditor

Name

CABINET KRIBS

Name of representative

Manager position

Statutory auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

Name

KPMG S.A

Name of representative

Manager position

Statutory auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

Name

M. LETERRIER FREDERIC

 

Manager position

Deputy auditor

Date of birth

-

 

Place of birth

 

Type

Individual

Name at birth

 

 

Name

SALUSTRO REYDEL

Name of representative

Manager position

Deputy auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

Previous Directors

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

President

M. ESNEE PIERRE

23/05/1966 - BAYEUX

President

M. PIRANDA JEAN-MARIE

06/04/1954 - LAVIRON

President

M. PIRANDA JEAN-MARIE

06/04/1954 - LAVIRON (25)

President

M. RUSTICHELLI PHILIPPE

07/01/1960 - MARSEILLE 06 (13)

Managing director

M. DUPONT THIERRY

16/12/1956 - BAYEUX

Managing director

M. PIRANDA JEAN-MARIE

06/04/1954 - LAVIRON

Managing director

M. PUECH JEAN-LUC

-

President of the management board

M. RUSTICHELLI PHILIPPE

07/01/1960 - MARSEILLE 06 (13)

Statutory auditor

KPMG

-

Statutory auditor

SA CABINET KRIBS

-

 

Status history

No Status History

 

Recent publications in Gazettes

Publication date

Gazette Name

Description

17/07/2016

Bodacc B

Modification et mutation diverse

14 - CALVADOS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

274 - 319 805 974 RCS Caen. FRIAL. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président : GLACIES HOLDING (SAS) Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : PIRANDA Jean-Marie Membre du conseil de surveillance : HERMAN Patrick Membre du conseil de surveillance : KORDES Olaf Membre du conseil de surveillance : BENANT Franc, Lionel Membre du conseil de surveillance : VER HULST Nicolas Commissaire aux comptes titulaire : CABINET KRIBS (SACA) Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : LETERRIER Frédéric Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SACA). Activité : .
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

17/07/2016

Bodacc B

Modification et mutation diverse

14 - CALVADOS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

276 - 319 805 974 RCS Caen. FRIAL. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président : GLACIES HOLDING (SAS) Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : PIRANDA Jean-Marie Membre du conseil de surveillance : HERMAN Patrick Membre du conseil de surveillance : KORDES Olaf Membre du conseil de surveillance : VER HULST Nicolas Commissaire aux comptes titulaire : CABINET KRIBS (SACA) Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : LETERRIER Frédéric Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SACA). Activité : .
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

14/07/2016

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

L Agriculteur normand / Edition du Calvados


Date de décision : 31/03/2016
La société 319805974 - SAS FRIAL, RTE DE CAEN, 14400 BAYEUX
Fait l'objet du départ de Monsieur Lionel BENANT

14/07/2016

JAL

Appointment of the social representative

L Agriculteur normand / Edition du Calvados


Date de décision : 31/03/2016
Société faisant l'objet d'une nomination : 319805974 - SAS FRIAL, RTE DE CAEN, 14400 BAYEUX
Nominé : Monsieur Nicolas VER HULST, 75009 PARIS
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance

24/11/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

14 - CALVADOS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

450 - 319 805 974 RCS Caen. FRIAL. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président : GLACIES HOLDING (SAS) Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : PIRANDA Jean-Marie Membre du conseil de surveillance : HERMAN Patrick Membre du conseil de surveillance : KORDES Olaf Membre du conseil de surveillance : VAISSIE Paul Membre du conseil de surveillance : BENANT Franc, Lionel Commissaire aux comptes titulaire : SA CABINET KRIBS (SA) Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LETERRIER Frédéric Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SA). Activité : .
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

11/11/2015

JAL

Appointment of the social representative

Eveil de Lisieux (L )


Date de décision : 25/09/2015
Société faisant l'objet d'une nomination : 319805974 - SAS FRIAL, 6 RTE DE CAEN, 14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
Nominé : 485376479 - GLACIES HOLDING, 6 RUE MONTAIGNE, 14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
En la fonction de : Président

11/11/2015

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Eveil de Lisieux (L )


Date de décision : 25/09/2015
La société 319805974 - SAS FRIAL, 6 RTE DE CAEN, 14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
Fait l'objet du départ de Monsieur Philippe RUSTICHELLI

11/08/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

14 - CALVADOS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

304 - 319 805 974 RCS Caen. FRIAL. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président, Président du directoire : RUSTICHELLI Philippe Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : PIRANDA Jean-Marie Membre du conseil de surveillance : HERMAN Patrick Membre du conseil de surveillance : KORDES Olaf Membre du conseil de surveillance : VAISSIE Paul Membre du conseil de surveillance : BENANT Franc, Lionel Commissaire aux comptes titulaire : SA CABINET KRIBS (SA) Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LETERRIER Frédéric Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SA). Activité : .
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

29/05/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

14 - CALVADOS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

104 - 319 805 974 RCS Caen. FRIAL. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président, Président du directoire : RUSTICHELLI Philippe Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : PIRANDA Jean-Marie Membre du conseil de surveillance : HERMAN Patrick Membre du conseil de surveillance : KORDES Olaf Membre du conseil de surveillance : VAISSIE Paul Membre du conseil de surveillance : BENANT Franc, Lionel Commissaire aux comptes titulaire : SA CABINET KRIBS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LETERRIER Frédéric. Activité : .
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

21/05/2015

JAL

Appointment of the social representative

Agriculteur normand (L )/Edition du Calvados


Date de décision : 27/03/2015
Société faisant l'objet d'une nomination : 319805974 - SAS FRIAL, 6 RTE DE CAEN, 14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
Nominé : Monsieur Lionel Benant, 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance

21/05/2015

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Agriculteur normand (L )/Edition du Calvados


Date de décision : 27/03/2015
La société 319805974 - SAS FRIAL, 6 RTE DE CAEN, 14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
Fait l'objet du départ de Monsieur Nicolas ver Hulst

11/12/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

14 - CALVADOS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

383 - 319 805 974 RCS Caen. FRIAL. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président, Président du directoire : RUSTICHELLI Philippe Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : PIRANDA Jean-Marie Membre du conseil de surveillance : VER HULST Nicolas Membre du conseil de surveillance : HERMAN Patrick Membre du conseil de surveillance : KORDES Olaf Membre du conseil de surveillance : VAISSIE Paul Commissaire aux comptes titulaire : SA CABINET KRIBS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LETERRIER Frédéric. Activité : .
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

30/10/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

14 - CALVADOS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

302 - 319 805 974 RCS Caen. FRIAL. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président, Président du directoire : RUSTICHELLI Philippe Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : PIRANDA Jean-Marie Membre du conseil de surveillance : VER HULST Nicolas Membre du conseil de surveillance : HERMAN Patrick Membre du conseil de surveillance : KORDES Olaf Membre du conseil de surveillance : VAISSIE Paul Commissaire aux comptes titulaire : SA CABINET KRIBS (SA) Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : KRIBS Roger Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves. Activité : .
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

12/10/2013

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Manche libre (La)


Date de décision : 30/09/2013
La société 319805974 - SAS FRIAL, 6 RTE DE CAEN, 14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
Fait l'objet du départ de Monsieur Jean-Marie PIRANDA

12/10/2013

JAL

Appointment of the social representative

Manche libre (La)


Date de décision : 30/09/2013
Société faisant l'objet d'une nomination : 319805974 - SAS FRIAL, 6 RTE DE CAEN, 14400 SAINT MARTIN DES ENTREES
Nominé : Monsieur Jean-Marie PIRANDA, 14400 BAYEUX
En la fonction de : Président du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Philippe RUSTICHELLI, 14390 CABOURG
En la fonction de : Président du Directoire
Nominé : Monsieur Paul VAISSIÉ, 75015 PARIS 15
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Olaf KORDES, 92400 COURBEVOIE
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Patrick Herman, 1000 BRUXELLES
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Nicolas VER HULST, 75009 PARIS 09
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance
Nominé : Monsieur Jean-Marie PIRANDA, 14400 BAYEUX
En la fonction de : Membre du Conseil de Surveillance

13/11/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

14 - CALVADOS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

310 - 319 805 974 RCS Caen. FRIAL. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président : PIRANDA Jean-Marie Commissaire aux comptes titulaire : SA CABINET KRIBS (SA) Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : KRIBS Roger Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves.
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

28/05/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

14 - CALVADOS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYEUX

427 - 319 805 974 RCS Bayeux. FRIAL. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président : PIRANDA Jean-MarieCommissaire aux comptes titulaire : SA CABINET KRIBS (SA). Commissaire aux comptes suppléant : KRIBS Roger.
Commentaires : Modification survenue sur l'administration.

23/10/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

648 - RCS Bayeux B 319 805 974. RC 80-B 21. FRIAL. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : route de Caen,, 14400 Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président : ESNEE (Pierre) (Nom d'usage : ESNEE). Directeurs généraux : DUPONT (Thierry) (Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean-Marie) (Nom d'usage : PIRANDA). Commissaire aux comptes titulaire : S.A. CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant : SCHMITT (Pierre) (Nom d'usage : SCHMITT). Date d'effet : 23 juillet 2007.

20/03/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

150 - RCS Bayeux B 319 805 974. RC 80-B 21. FRIAL. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : route de Caen,, 14400 Commentaires : modification survenue sur la forme juridique et l'administration. Ancienne forme juridique : S.A. Administration : nouveau président : ESNEE (Pierre) (Nom d'usage : ESNEE), ancien président directeur général. Nomination en qualité de directeurs généraux : DUPONT (Thierry) (Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean-Marie) (Nom d'usage : PIRANDA) PUECH (Jean-Luc) (Nom d'usage : PUECH). Commissaire aux comptes titulaire maintenu : S.A. CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant : SCHMITT (Pierre) (Nom d'usage : SCHMITT). Anciens administrateurs : ESNEE (Pierre) ESNEE (Jacques) SOCIETE SCDHH DUPONT (Thierry) PIRANDA (Jean-Marie) PUECH (Jean-Luc). Ancien commissaire aux comptes suppléant : GANDON (Gérard). Date d'effet : 16 décembre 2004.

25/11/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : route de Caen, 14400 Saint-Martin-des- Entrées. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président directeur général : ESNEE (Pierre) ( Nom d'usage : ESNEE). Directeurs généraux délégués et administrateurs : ESNEE (Jacques) ( Nom d'usage : ESNEE) DUPONT (Thierry) ( Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean, Marie) ( Nom d'usage : PIRANDA). Administrateurs : PUECH (Jean-Luc) ( Nom d'usage : PUECH). Nouvel administrateur : S.C. DE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET HOSPITALIER-S.C.D.H., représentée par ESNEE (Pierre) ( Nom d' usage : ESNEE). Commissaire aux comptes : S.A. CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant : GANDON (Gérard) ( Nom d'usage : GANDON). Date d'effet : 22 juillet 2004.

25/07/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 4 352 000 euros. Adresse du siège social : route de Caen, 14400 Saint-Martin-des-Entrées. Commentaires : modification survenue sur le capital (diminution). Date d'effet : 3 mai 2004.

08/08/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées, 14400 Bayeux. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : président directeur général : ESNEE (Pierre) ( Nom d'usage : ESNEE). Directeurs généraux délégués et administrateurs : ESNEE (Jacques) ( Nom d'usage : ESNEE) DUPONT (Thierry) ( Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean, Marie) ( Nom d'usage : PIRANDA). Administrateurs : ESNEE (Nathalie) ( Nom d'usage : ESCLAPEZ) PUECH (Jean- Luc) ( Nom d'usage : PUECH). Commissaire aux comptes : S.A. CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant : GANDON (Gérard) ( Nom d' usage : GANDON). Date d'effet : 23 mai 2003.

16/03/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Adresse du siège social : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées, 14400 Bayeux. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : Président directeur général : ESNEE (Jacques) ( Nom d'usage ESNEE) directeurs généraux délégués : DUPONT (Thierry) ( Nom d'usage : DUPONT) PIRANDA (Jean, Marie) ( Nom d' usage : PIRANDA). Administrateurs : ESNEE (Nathalie) ( Nom d'usage : ESCLAPEZ) ESNEE (Pierre) ( Nom d' usage : ESNEE) PUECH (Jean-Luc) ( Nom d'usage : PUECH). Commissaire aux comptes : S.A. CABINET KRIBS. Commissaire aux comptes suppléant : GANDON (Gérard) ( Nom d'usage : GANDON). Date d'effet : 21 juin 2002.

14/11/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 4 599 040 euros. Adresse du siège social : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées, 14400 Bayeux. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation et conversion en euros). Date d'effet : 22 juin 2001.

06/08/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Bayeux B 319805974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 13 423 448 F. Activité : achat, vente de tous produits alimentaires surgelés, congelés et de conserves, pour une consommation humaine ou animale gestion de participations. Adresse du siège social : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées, 14400 Bayeux. Commentaires : modification survenue sur l'activité. Date d'effet : 9 juin 2000.

31/10/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Bayeux B 319 805 974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 13 423 448 F. Adresse du siège social : route de Caen Saint-Martin-des-Entrées 14400 Bayeux. Administration : ancien commissaire aux comptes titulaire : KRIBS (Roger). Nouveau commissaire aux comptes titulaire : S.A. CABINET KRIBS. Date d'effet : 19 juin 1998.

26/11/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Ancienne situation du siège social. RCS Bayeux B 319 805 974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 5 389 500 F. Adresse : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées 14400 Bayeux Nouvelle situation du siège social. Capital : 13 423 448 F. Date d'effet : 28 juin 1996.

10/10/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Bayeux B 319 805 974 RC 80-B 21 FRIAL. Forme : S.A. Capital : 5 389 500. Adresse du siège social : route de Caen, Saint-Martin-des-Entrées 14400 Bayeux. Administration : renouvellement des mandats des administrateurs : ESNEE ( Jacques) DUPONT (Thierry) ESCLAPEZ ( Nathalie). Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration : ESNEE (Jacques). Renouvellement des mandats des directeurs généraux : DUPONT (Thierry) et PIRANDA (Jean-Marie) à compter du:19 juin 1995 Nouvel administrateur : PIRANDA (Jean-Marie). Date d'effet : 17 juillet 1995.

 

 

Company events history

Date

Description

17/07/2016

Bodacc B: Various editing or changing

14/07/2016

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

08/07/2016

Amendment

08/07/2016

Appointment/resignation of company officers

31/03/2016

Legal Gazette: Appointment of the social representative

24/11/2015

Bodacc B: Various editing or changing

11/11/2015

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

09/11/2015

Amendment

25/09/2015

Legal Gazette: Appointment of the social representative

11/08/2015

Bodacc B: Various editing or changing

30/07/2015

Minutes of general meeting of shareholders

30/07/2015

New auditor

29/05/2015

Bodacc B: Various editing or changing

21/05/2015

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

13/05/2015

Appointment/resignation of company officers

13/05/2015

Amendment

27/03/2015

Legal Gazette: Appointment of the social representative

11/12/2013

Bodacc B: Various editing or changing

25/11/2013

New auditor

25/11/2013

Minutes of general meeting of shareholders

30/10/2013

Bodacc B: Various editing or changing

16/10/2013

Amendment

16/10/2013

Updated articles of association

12/10/2013

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

30/09/2013

Legal Gazette: Appointment of the social representative

25/02/2013

Updated articles of association

25/02/2013

Minutes of general meeting of shareholders

15/10/2010

New shareholders detected

15/10/2010

New subsidiarie(s) detected

15/10/2010

New ultimate parent

15/10/2010

New parent detected

13/11/2009

Bodacc B: Various editing or changing

27/10/2009

Minutes of general meeting of shareholders

30/07/2008

Collection of preferential rights activated for this company

28/05/2008

New Bodacc B ads detected

28/05/2008

Bodacc B: Various editing or changing

15/05/2008

New auditor

15/05/2008

Updated articles of association

15/05/2008

Updated articles of association

15/05/2008

Minutes of general meeting of shareholders

15/05/2008

Minutes of general meeting of shareholders

15/05/2008

Appointment/resignation of company officers

15/05/2008

Private document

18/10/2007

Minutes of general meeting of shareholders

18/10/2007

Minutes of general meeting of shareholders

18/10/2007

Amendment

18/10/2007

Private document

19/09/2007

Minutes of general meeting of shareholders

19/09/2007

Minutes of general meeting of shareholders

19/09/2007

Appointment/resignation of company officers

19/09/2007

Private document

24/10/2005

Private document

24/10/2005

Minutes of general meeting of shareholders

24/10/2005

Minutes of general meeting of shareholders

24/10/2005

Amendment

24/10/2005

Amendment

24/10/2005

Private document

14/01/2005

New legal form – new category

14/01/2005

New legal form – no new category

14/01/2005

New legal form – no new category

14/01/2005

Private document

14/01/2005

Private document

14/01/2005

Updated articles of association

14/01/2005

Updated articles of association

14/01/2005

New auditor

14/01/2005

New auditor

14/01/2005

Minutes of general meeting of shareholders

14/01/2005

Minutes of general meeting of shareholders

14/01/2005

Appointment/resignation of company officers

14/01/2005

Amendment

14/01/2005

Appointment/resignation of company officers

14/10/2004

Amendment

14/10/2004

Appointment/resignation of company officers

14/10/2004

Appointment/resignation of company officers

14/10/2004

Changes to the Board of Directors

14/10/2004

Private document

14/10/2004

Minutes of Board meeting

14/10/2004

Minutes of Board meeting

14/10/2004

Private document

14/10/2004

Changes to the Board of Directors

24/06/2004

Amendment

24/06/2004

Capital reduction

24/06/2004

Capital reduction

24/06/2004

Minutes of Board meeting

24/06/2004

Minutes of Board meeting

24/06/2004

Minutes of general meeting of shareholders

24/06/2004

Private document

24/06/2004

Private document

24/06/2004

Updated articles of association

24/06/2004

Updated articles of association

16/03/2004

Capital reduction

16/03/2004

Capital reduction

16/03/2004

Minutes of general meeting of shareholders

16/03/2004

Minutes of general meeting of shareholders

16/03/2004

Private document

16/03/2004

Amendment

16/03/2004

Private document

01/07/2003

Amendment

01/07/2003

Appointment/resignation of company officers

01/07/2003

Changes to the Board of Directors

01/07/2003

Minutes of Board meeting

01/07/2003

New chairman (CEO, CoB)

01/07/2003

Private document

05/02/2003

Changes to the Board of Directors

05/02/2003

Updated articles of association

05/02/2003

Private document

05/02/2003

Minutes of general meeting of shareholders

05/02/2003

Minutes of Board meeting

05/02/2003

Appointment/resignation of company officers

05/02/2003

Amendment

20/12/2002

Application and court order

20/12/2002

Amendment

02/10/2001

Minutes of general meeting of shareholders

02/10/2001

Minutes of Board meeting

02/10/2001

Conversion of equity to euro

02/10/2001

Private document

02/10/2001

Updated articles of association

02/10/2001

Capital increase

02/10/2001

Amendment

13/07/2000

Private document

13/07/2000

Amendment

13/07/2000

Updated articles of association

13/07/2000

Minutes of general meeting of shareholders

13/07/2000

Change to corporate purpose

10/09/1999

Amendment

10/09/1999

Private document

10/09/1999

Appointment/resignation of company officers

10/09/1999

Minutes of general meeting of shareholders

02/09/1998

Private document

02/09/1998

Minutes of general meeting of shareholders

02/09/1998

Appointment/resignation of company officers

02/09/1998

Amendment

29/08/1996

Amendment

29/08/1996

Minutes of general meeting of shareholders

29/08/1996

Updated articles of association

29/08/1996

Capital increase

24/08/1995

Minutes of Board meeting

24/08/1995

Appointment/resignation of company officers

24/08/1995

Amendment

24/08/1995

Minutes of general meeting of shareholders

27/01/1995

Sale of shares

27/01/1995

Office copy

27/01/1995

Amendment

28/12/1993

Amendment

28/12/1993

Minutes of general meeting of shareholders

05/03/1993

Minutes of Board meeting

05/03/1993

Minutes of general meeting of shareholders

05/03/1993

Amendment

05/03/1993

Capital increase

05/03/1993

Declaration of conformity

05/03/1993

Updated articles of association

23/01/1993

Minutes of Board meeting

23/01/1993

Updated articles of association

23/01/1993

Declaration of conformity

23/01/1993

Capital increase

23/01/1993

Amendment

23/01/1993

Minutes of general meeting of shareholders

09/09/1992

Minutes of Board meeting

09/09/1992

New chairman (CEO, CoB)

09/09/1992

Minutes of general meeting of shareholders

09/09/1992

Changes to the Board of Directors

09/09/1992

Amendment

09/09/1992

Appointment/resignation of company officers

27/11/1991

Sale of shares

27/11/1991

Office copy

 

 

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

INR 64.91

UK Pound

1

INR 91.87

Euro

1

INR 80.26

Euro

1

INR 80.56

 

Note : Above are approximate rates obtained from sources believed to be correct

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

DIV

 

 

Report Prepared by :

TRU

                                                


 

RATING EXPLANATIONS

 

Credit Rating

Explanation

Rating Comments

A++

Minimum Risk

Business dealings permissible with minimum risk of default

A+

Low Risk

Business dealings permissible with low risk of default

A

Acceptable Risk

Business dealings permissible with moderate risk of default

B

Medium Risk

Business dealings permissible on a regular monitoring basis

C

Medium High Risk

Business dealings permissible preferably on secured basis

D

High Risk

Business dealing not recommended or on secured terms only

NB

New Business

No recommendation can be done due to business in infancy stage

NT

No Trace

No recommendation can be done as the business is not traceable

 

NB is stated where there is insufficient information to facilitate rating. However, it is not to be considered as unfavourable.

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors are as follows:

 

·         Financial condition covering various ratios

·         Company background and operations size

·         Promoters / Management background

·         Payment record

·         Litigation against the subject

·         Industry scenario / competitor analysis

·         Supplier / Customer / Banker review (wherever available)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.