MIPL-Logo

3decades

 

MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

500691

Report Date :

31.03.2018

 

 

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

CELIO FRANCE

 

 

Registered Office :

Celio, 21 Rue Blanqui, 93406 St Ouen Cedex

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.01.2017

 

 

Date of Incorporation :

June 1978

 

 

Com. Reg. No.:

RCS Bobigny B 313 334 856

 

 

Legal Form :

Simplified Joint Stock Company

 

 

Line of Business :

Retail Sale of Clothing in Specialized Establishments (4771Z)

 

 

No. of Employees :

2 000 to 4 999

 

 

RATING & COMMENTS

(Mira Inform has adopted New Rating mechanism w.e.f. 23rd January 2017)

 

MIRA’s Rating :

A+

 

Credit Rating

 

Explanation

Rating Comments

A+

Low Risk

Business dealings permissible with low risk of default

 

Status :

Good

 

 

Payment Behaviour :

Regular

 

 

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List

 

Country Name

Previous Rating

(30.09.2017)

Current Rating

(31.12.2017)

France

A1

A1

 

Risk Category

 

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low Risk

 

A2

Moderately Low Risk

 

B1

Moderate Risk

 

B2

Moderately High Risk

 

C1

High Risk

 

C2

Very High Risk

 

D

 


 

FRANCE - ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. France is the most visited country in the world with 83 million foreign tourists in 2016, including 530,000 visitors for the 2016 Euro Cup. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that mitigate economic inequality.

 

France's real GDP grew by 1.6% in 2017, up from 1.2% the year before. The unemployment rate (including overseas territories) increased from 7.8% in 2008 to 10.2% in 2015, before falling to 9.5% in 2017. Youth unemployment in metropolitan France decreased from 24.6% in the fourth quarter of 2014 to 24% in the fourth quarter of 2016.

 

France’s public finances have historically been strained by high spending and low growth. Despite measures to restore public finances, the budget deficit rose from 3.3% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009. In 2017, the budget deficit improved to 2.9% of GDP, bringing it in compliance with the EU-mandated 3% deficit target. Meanwhile, France's public debt rose from 89.5% of GDP in 2012 to 96.9% in 2017.

 

Since entering office in May 2017, President Emmanuel MACRON launched a series of economic reforms to improve competitiveness and boost economic growth. President MACRON campaigned on reforming France’s labor code and in late 2017 implemented a range of reforms to increase flexibility in the labor market by making it easier for firms to hire and fire and simplifying negotiations between employers and employees. In addition to labor reforms, President MACRON’s proposed 2018 budget cuts public spending, taxes, and social security contributions to spur private investment and increase purchasing power.

 

Source : CIA

 

 


Company summary

 

SIRET

313 334 856 01684

Name

CELIO FRANCE

Acronym

-

Trade name

CELIO

Status

Economically active

Postal Address

CELIO FRANCE
CELIO
21 RUE BLANQUI
93406 ST OUEN CEDEX
FRANCE

Share Capital

8,153,904 Euros

Telephone

01 40 12 98 94

Activity (APE)

Retail sale of clothing in specialized establishments (4771Z)

RCS Registration

RCS Bobigny B 313 334 856

Formation Date

06/1978

EUR VAT Number

FR84313334856

Deregistration Date

-

Last account Date

31/01/2017

Court Registry Number

19 8 7B08805

Incorporiation Date

08/1978

Registration Court

Bobigny (93)

Fax

01 48 63 26 85

Nationality

France

Safe Number

FR00745499

Legal form

Simplified Joint Stock Company

Currency

Euros

 

 

Key Financials

 

YEAR TO DATE

TURNOVER

GROSS OPERATING SURPLUS

SHAREHOLDER'S EQUITY

NET RESULT

EMPLOYEES

31/01/2017

594,565,570 €

3.38% Turnover

41,235,878 €

9,639,246 €

2668 employees

31/01/2016

597,981,064 €

4.11% Turnover

69,282,957 €

11,407,408 €

2827 employees

31/01/2015

575,789,202 €

5.39% Turnover

105,303,974 €

11,382,063 €

73 employees

 

Directors

Current Directors

4

 

 

Ultimate Holding Company

Name

Safe Number

Country

Company Number

CELIO FRANCE

FR00745499

313334856

Affiliation links.

 

Judgment and Preferential

Judgment

No judgement

 

Preferential Right

No social security and tax office preferential right to date

 

 

Establishment Details

 

Type of Establishment

Head Office

Production Role

-

APE/NAF Code

4771Z

Activity

Retail sale of clothing in specialized stores

Formation Date

06/1995

Reason for Formation

Formation

Closure Date

-

Reason for Closure

-

Reactivation Date

-

Seasonality

-

Activity Nature

Other

Activity Location

Other

Trading Address

21 RUE BLANQUI 
93400 SAINT OUEN

Department

Seine-Saint-Denis (93)

Location Surface

-

District

3

City

SAINT OUEN

Status

Economically active

Business Pages FT®

VETEMENTS SPORT: SPORTSWEAR (DETAIL)

Region

Ile-de-France

Area

18

Size of Urban Area

Paris conglomeration

 

Ultimate Parent(s)

1 ultimate parent company/companies for this company

Company Name

Activity (APE)

APE/NAF Code

City

Post Code

CELIO FRANCE

Retail sale of clothing in specialized stores

4771Z

SAINT OUEN

93400

 

Other Establishment(s)

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas but no one grouping more than 50% of workforce

Mono-activity status

Legal unit with multiple establishments having main activities in many divisions, which one activity grouping from 80 to 99% of workforce

Branches

419 branch entities in this company

 

 

Company Name

Company Type

APE/NAF Code

Activity

City

Post Code

CELIO FRANCE

Head Office

4771Z

Retail sale of clothing in specialized stores

SAINT OUEN

93400

CELIO FRANCE

Branch

4771Z

Retail sale of clothing in specialized stores

NICE

06000

CELIO FRANCE

Branch

4771Z

Retail sale of clothing in specialized stores

NICE

06300

CELIO FRANCE

Branch

4771Z

Retail sale of clothing in specialized stores

MARSEILLE 1

13001

CELIO FRANCE

Branch

4771Z

Retail sale of clothing in specialized stores

MARSEILLE 1

13001

 

Workforces

Workforce at address

250 to 499 employees

Company workforce

2 000 to 4 999 employees

 

 

Workforce account

2 000 to 4 999 employees

 

 

31/01/2017

 

 

 

Commentary

 

The comments are ordered according to the class of risk. Companies are compared with regard to other companies of the same type. Thus a positive comment for one category can be negative for another or can change depending on its value. This is a purely statistical decision.

The company has 5 directors

Industry code with low risk rating

The total assets are 413,394,439 €

The shareholder's equity is 41,235,878 €

The risk provisions are 3,616,776 €

The liabilities are 368,541,785 €

The net current assets are 223,048,950 €

Department code with low risk rating

Low risk workforce size

The net turnover is 594,565,570 €

The pre-tax profit is 11,710,330 €

The sales to current assets ratio is 2.67

The stock to turnover ratio is 10.63

The return on total assets employed is 2.83

The creditor days are 59.96

The ratio total assets to total liabilities is 1.11

The increase in the gearing percentage over the last two accounting periods is 157 %

 

Industry comparison

Activity (APE)

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (4771Z)

 

Collective procedures

No judgment information for the company

 

Preferential rights details and history

Summary of preferential rights

Company monitored since

04/02/2008

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

 

Group Data

Ultimate parent company

CELIO FRANCE

Direct parent

-

Group – Number of companies

3

Linkages – Number of companies

-

Number of countries

-

 

 

 

NAME

SIREN

PARTS

LAST ACCOUNT PUBLISHED

1

CELIO FRANCE

313334856

-

31/01/2017

2

VELMEUBLES

395374879

100 %

31/01/2017

LCB

-

100 %

-

 

Shareholders

No Shareholders available for this company

 

Linkages

No Linkages information available for the company.

 

Shareholder(s)

Name

CELIO INTERNATIONAL

Name of representative

Manager position

President, Chairman of the Board

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

Name

FINANCIERE NAMSORG

Name of representative

Mme FREDEAU ANTOINETTE

Manager position

Administrator

Date of birth

03/07/1954

Place of birth

BOULOGNE-BILLANCOURT

Type

Moral person

Name at birth

 

Statutory Auditor

Name

DELOITTE & ASSOCIES

Name of representative

Manager position

Statutory auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

Name

BEAS

Name of representative

Manager position

Deputy auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

Previous Directors

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

President

CELIO INTERNATIONAL 0880 793 256 (R.C.S. BRUXELLES)

-

President

M. PIMONT CHRISTIAN

-

Administrator

FINANCIERE NAMSORG

03/07/1954 - BOULOGNE BILLANCOURT

Administrator

FINANCIERE NAMSORG

03/07/1954 - BOULOGNE-BILLANCOURT

Administrator

MME. GROSMAN ANTOINETTE

-

Administrator

M. LOVISOLO ERIC

-

Administrator

M. PIMONT CHRISTIAN

-

President of the management board

M. PIMONT CHRISTIAN

-

 

Status history

No Status History

 

 

Recent publications in Gazettes

 

Publication date

Gazette Name

Description

24/08/2017

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

12931 - 313334856 RCS. CELIO FRANCEForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 21 rue Blanqui 93406 Saint-Ouen. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/01/2017.

21/12/2016

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

9095 - 313334856 RCS. CELIO FRANCEForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 21 rue Blanqui 93406 Saint-Ouen. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/01/2016.

11/07/2015

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

16957 - 313334856 RCS. CELIO FRANCEForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 21 rue Blanqui 93406 Saint-Ouen. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/01/2015.

01/09/2014

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

8130 - 313334856 RCS. CELIO FRANCEForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 21 rue Blanqui 93406 Saint-Ouen. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/01/2014.

12/03/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

17 - CHARENTE-MARITIME

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE

182 - 313 334 856 RCS Bobigny. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 21 rue Blanqui, 93406 Saint-Ouen Cedex. 
Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 40000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Prêt à porter hommes et accessoires s'y rapportant. Adresse : route de Rochefort, Centre Commercial Carrefour, 17690 Angoulins. 
Précédent propriétaire : DEFIVET. 385 219 910 RCS Toulouse. 
Date de commencement de l’activité : 29/01/2014. Publication légale : SUD OUEST du 12/02/2014. Oppositions : AU FONDS VENDU route de Rochefort Centre Commercial Carrefour 17690 Angoulins. Descriptif : Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

07/03/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

10 - AUBE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES

164 - 313 334 856 RCS Bobigny. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 21 rue Blanqui, 93400 Saint-Ouen. 
Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 170000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Prêt à porter hommes et accessoires s'y rapportant. Adresse : Centre Commercial Leclerc Zone Commerciale de la Belle Idée, 10100 Romilly-sur-Seine. 
Précédent propriétaire : CARUDIS. 310 392 394 RCS Saint-Gaudens. 
Date de commencement de l’activité : 13/02/2014. Publication légale : L EST ECLAIR du 12/02/2014. Oppositions : SELARL BRENAC et ASSOCIES prise en la personne de Me Alix BRENAC 23, rue Delcassé 09000 Foix et pour la validité des oppositions au fonds vendu : Centre Commercial Leclerc Zone Commerciale de la Belle Idée 10100 Romilly. Descriptif : Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

05/03/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

47 - LOT-ET-GARONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN

457 - 313 334 856 RCS Bobigny. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 21 rue Blanqui, 93406 Saint-Ouen. 
Origine du fonds : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 197000 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Pret à porter masculin et accessoires s'y rapportant. Adresse : avenue de l'Atlantique Zone d'Activités Commerciales Agen Sud Galerie Marchande Intermarche, 47000 Agen. 
Précédent propriétaire : ETABLISSEMENTS MARSODI. 300 286 333 RCS Toulouse. 
Date de commencement de l’activité : 29/01/2014. Publication légale : LA DEPECHE DU MIDI du 12/02/2014. Oppositions : AU FONDS VENDU Galerie Marchande Intermarché 47000 Agen. Descriptif : Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

02/03/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

16 - CHARENTE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

133 - 313 334 856 RCS Bobigny. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 21 rue Blanqui, 93400 Saint-Ouen. 
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 231000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Vente de prê à porter masculin. Adresse : 40 rue de l'Anisserie, Centre Commercial Auchan, 16100 Châteaubernard. 
Précédent propriétaire : ETABLISSEMENTS MARSODI. 300 286 333 RCS Toulouse. 
Date de commencement de l’activité : 29/01/2014. Publication légale : Sud Ouest ET rectificatif SO du 17/02/2014 du 12/02/2014. Oppositions : au siège du fonds vendu sis 40 rue de l'Anisserie C.Cial Auchan-16100 Chateaubernard et pour la correspondance au siège social de la SELARL BRENAC et associés, mandataire judiciaire, 23 rue Delcassé - 09000 Foix. Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

27/02/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

11 - AUDE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

93 - 313 334 856 RCS Bobigny. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 21 rue Blanqui, 93406 Saint-Ouen. 
Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 239000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Prêt à porter masculin et accessoires s'y rapportant. Adresse : Zone Industrielle la Bouriette Galerie Marchande Géant Salvaza, 11000 Carcassonne. 
Précédent propriétaire : CARUDIS. 310 392 394 RCS Toulouse. 
Date de commencement de l’activité : 29/01/2014. Publication légale : MIDI LIBRE EDITION AUDE du 12/02/2014. Oppositions : POUR LA CORRESPONDANCE : SELARL BRENAC ET ASSOCIES MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS CARUDIS 23, rue DELCASSE 09000 Foix POUR LA VALIDITE : A L'ADRESSE DU FONDS VENDU : GALERIE MARCHANDE GEANT SALVAZA 11000 CARCASSONNE. Descriptif : Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

26/02/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

10 - AUBE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES

56 - 313 334 856 RCS Bobigny. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 21 rue Blanqui, 93400 Saint-Ouen. 
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 170000 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : vente de prêt à porter masculin. Adresse : Centre Commercial Leclerc Zone Commerciale de la Belle Idée, 10100 Romilly-sur-Seine. 
Précédent propriétaire : CARUDIS. 310 392 394 RCS Toulouse. 
Date de commencement de l’activité : 29/01/2014. Publication légale : L' est Eclair du 12/02/2014. Oppositions : pour la validité au fonds vendu et pour la correspondance chez la SELARL BRENAC & ASSOCIES, séquestre, prise en la personne de Me Alix BRENAC, Mandataire Judiciaire de la société CARUDIS 23 rue Delcabé 09000 Poix. Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

25/02/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

17 - CHARENTE-MARITIME

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE

264 - 313 334 856 RCS Bobigny. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 21 rue Blanqui, 93406 Saint-Ouen Cedex. 
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 40000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : vente de prêt à porter masculin. Adresse : route de Rochefort, Centre Commercial Carrefour, 17690 Angoulins. 
Précédent propriétaire : DEFIVET. 385 219 910 RCS Toulouse. 
Date de commencement de l’activité : 29/01/2014. Publication légale : sud ouest du 12/02/2014. Oppositions : pour la validité : au fonds vendu centre commercial Carrefour, route de Rochefort à Angoulins 17690 et pour la correspondance SELARL BRENA & Associés 23 rue Delcassé à Foix 09000. Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

23/02/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

31 - HAUTE-GARONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

256 - 313 334 856 RCS Paris. CELIO FRANCE. Forme : Société par Actions Simplifiée. Sigle : CELIO. Adresse : 21 rue Blanqui, 93406 Saint-Ouen. 
Origine du fonds : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 385000 EUR. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : un fonds de commerce de vente de prêt à porter masculin. Adresse : route Nationale 20, Zone Industrielle de Saint Jory, 31150 Fenouillet. 
Précédent propriétaire : CARUDIS. 310 392 394 RCS Toulouse. 
Date de commencement de l’activité : 29/01/2014. Publication légale : La Dépêche du Midi du 12/02/2014. Oppositions : Pour la validité à l'adresse du fonds vendu Galerie Marchande Géant - Centre Commercial Fenouillet, Route Nationale 20 - Zone Industrielle de Saint Jory 31150 Fenouillet et pour la correspondance 23 Rue Delcassé 09000 Foix siège social de la Selarl Brenac et Associés, séquestre, pris en la personne de Maître Alix Brenac mandataire judiciaire de la SAS CARUDIS. Descriptif : Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

12/02/2014

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Dépêche du Midi (La)/Edition de Toulouse


Date de décision : 29/01/2014 
Cédant : 310392394 - CARUDIS, FORMEN, 21 BD DES LANDES, ZAC DES LANDES, 31800 ESTANCARBON
Cessionnaire : 313334856 - CELIO FRANCE, CELIO, 21 RUE BLANQUI, SAINT OUEN, 93400 SAINT OUEN
Prix de vente : 385000 €
Date d’effet : 29/01/2014 

12/02/2014

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Dépêche du Midi (La)/Edition du Lot et Garonne


Date de décision : 29/01/2014 
Cédant : 300286333 - ETABLISSEMENTS MARSODI, 5 RUE LAMARTINE, 31800 SAINT GAUDENS
Cessionnaire : 313334856 - CELIO FRANCE, CELIO, 21 RUE BLANQUI, SAINT OUEN, 93400 SAINT OUEN
Prix de vente : 197000 €
Date d’effet : 29/01/2014 

12/02/2014

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Est Eclair (L')


Date de décision : 29/01/2014 
Cédant : 310392394 - CARUDIS, FORMEN, 21 BD DES LANDES, ZAC DES LANDES, 31800 ESTANCARBON
Cessionnaire : 313334856 - CELIO FRANCE, CELIO, 21 RUE BLANQUI, SAINT OUEN, 93400 SAINT OUEN
Prix de vente : 170000 €
Date d’effet : 29/01/2014 

12/02/2014

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Sud Ouest/Edition La Rochelle/Ré


Date de décision : 29/01/2014 
Cédant : 385219910 - DEFIVET, CELIO, 5 RUE LAMARTINE, 31800 SAINT GAUDENS
Cessionnaire : 313334856 - CELIO FRANCE, CELIO, 21 RUE BLANQUI, SAINT OUEN, 93400 SAINT OUEN
Prix de vente : 40000 €
Date d’effet : 29/01/2014 

16/01/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

61 - ORNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON

420 - 313 334 856 RCS Bobigny. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 8153904 EUR. Adresse : 21 rue Blanqui, 93406 Saint-Ouen Cedex. 
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 360000 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : Vente de prêt-à-porter masculin. Adresse : 10 Grande Rue, 61000 Alençon. 
Précédent propriétaire : ALENCON CONCEPT DEVELOPPEMENT. 504 074 725 RCS Évreux. 
Date de commencement de l’activité : 01/01/2014. Publication légale : Le Journal de l'Orne du 09/01/2014. Oppositions : Pour la validité auprès de Maître Michel LEMONNIER, Avocat, 27 avenue Jean Mantelet 61000 Alençon, et pour la correspondance auprès de Maître Stéphanie COMBES-MATHIEU, Avocat au Barreau de l'Eure, Cabinet COMBES-MATHIEU, 361 rue Clément Ader PA Le Long Buisson 27005 Evreux. Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

09/01/2014

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Journal de l'Orne (Le)


Date de décision : 18/12/2013 
Cédant : 504074725 - ALENCON CONCEPT DEVELOPPEMENT, A.C.D., 6 LE GERIER, 27580 BOURTH
Cessionnaire : 313334856 - CELIO FRANCE, CELIO, 21 RUE BLANQUI, SAINT OUEN, 93400 SAINT OUEN
Prix de vente : 360000 €
Date d’effet : 01/01/2014 

02/09/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

9836 - 313334856 RCS. CELIO FRANCEForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 21 rue Blanqui 93406 Saint-Ouen. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/01/2013.

09/01/2013

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

21 - COTE-D'OR

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

483 - Réctificatif. 
Parution avis précédent : BODACC A. Numéro de parution : Date de parution : 12 juin 2012. Numéro d’annonce : 482. Cet avis est annulé et remplacé par le suivant. 
313 334 856 RCS Bobigny. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : CELIO. Adresse : 21 rue Blanqui, 93406 Saint-Ouen. 
Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 200000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Vente au détail de prêt à porter masculin et tous accessoires s'y rapportant, chaussures, lingerie, maroquinerie. Adresse : 9 avenue du Général de Gaulle, Centre commercial St Jacques, 21200 Beaune. 
Précédent propriétaire : DOMEDIS. 419 486 725 RCS Toulouse. 
Date de commencement de l’activité : 01/05/2012. Publication légale : Terres de Bourgogne du 18/05/2012. Oppositions : CELIO 9, avenue du Général de Gaulle Centre Commercial St Jacques 21200 Beaune. Descriptif : Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

21/11/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

1352 - Réctificatif. 
Parution avis précédent : BODACC A. Numéro de parution : Date de parution : 7 septembre 2012. Numéro d’annonce : 370. Cet avis est annulé et remplacé par le suivant. 
313 334 856 RCS Meaux. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 8153904 EUR. Adresse : 21 rue Blanqui, 93400 Saint-Ouen. 
Origine du fonds : Achat au prix stipulé de 1850000,00 euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : Prêt à porter hommes et femmes et accessoires de mode. Adresse : 14 rue du Danube, Ccial Val d'Europe, 77400 Lagny sur Marne. 
Précédent propriétaire : BENETTON FRANCE COMMERCIAL SAS. 324 536 499 RCS Meaux. 
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Publication légale : Le Pays Briard du 24/08/2012. Oppositions : au fonds vendu 14 rue du Danube Ccial Val d'Europe 77400 Lagny sur Marne pour la validitéet au siège de la Société BENETTON FRANCE COMMERCIAL SAS sis 16 rue Auber 75009 PARIS et Me Marie Thérèse Delignat Lavaud 32 place Ronde Espace 21 92035 Paris la Défense Cedex pour la correspondance . Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

13/11/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

878 - Réctificatif. 
Parution avis précédent : BODACC A. Numéro de parution : Date de parution : 7 septembre 2012. Numéro d’annonce : 370. Cet avis est annulé et remplacé par le suivant. 
313 334 856 RCS Meaux. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 8153904 EUR. Adresse : 21 rue Blanqui, 93400 Saint-Ouen. 
Origine du fonds : Achat au prix stipulé de 1850000,00 euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : Prêt à porter hommes et femmes et accessoires de mode. Adresse : 14 rue du Danube, Ccial Val d'Europe, 77400 Lagny sur Marne. 
Précédent propriétaire : BENETTON FRANCE COMMERCIAL SAS. 324 536 499 RCS Meaux. 
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Publication légale : Le Pays Briard du 24/08/2012. Oppositions : au fonds vendu 14 rue du Danube Ccial Val d'Europe 77400 Lagny sur Marne pour la validité et au siège de la Société BENETTON France Commercial SAS sis 16 rue Auber 75009 PARIS , Me Marie Thérèse Delignat Lavaud domiciliée professionnellement à FIDAL 32 place Ronde Espace 21 92035 Paris la Défense Cedex pour la correspondance . Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

11/11/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

1211 - 313 334 856 RCS Bobigny. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 20 Octobre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 20 Octobre 2009 Président : CELIO INTERNATIONAL modification le 02 Novembre 2012 Administrateur : FINANCIERE NAMSORG représenté par FREDEAU Antoinette en fonction le 02 Novembre 2012 Président du conseil d'administration : CELIO INTERNATIONAL en fonction le 02 Novembre 2012. Activité : 
Commentaires : Modification de représentant.

17/09/2012

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

12927 - 313334856 RCS. CELIO FRANCEForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 21 rue Blanqui 93406 Saint-Ouen. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/01/2012.

07/09/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

370 - 313 334 856 RCS Meaux. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 8153904 EUR. Adresse : 21 rue Blanqui, 93400 Saint-Ouen. 
Origine du fonds : Achat au prix stipulé de 1850000,00 euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : Prêt à porter hommes et femmes et accessoires de mode. Adresse : 14 rue du Danube, Ccial Val d'Europe, 77400 Lagny sur Marne. 
Précédent propriétaire : BENETTON FRANCE COMMERCIAL SAS. 324 536 499 RCS Meaux. 
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Publication légale : Le Pays Briard du 24/08/2012. Oppositions : au fonds vendu 14 rue du Danube Ccial Val d'Europe 77400 Lagny sur Marne pour la validité, Me Marie Thérèse Delignat Lavaud 32 place Ronde Espace 21 92035 Paris la Défense Cedex pour la correspondance . Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

24/08/2012

JAL

Activity or goodwill cession

Pays Briard (Le)


Date de décision : 02/08/2012 
Cédant : 324536499 - BENETTON FRANCE COMMERCIAL SAS, 16 RUE AUBER, 75009 PARIS 9
Cessionnaire : 313334856 - CELIO FRANCE, CELIO, 21 RUE BLANQUI, SAINT OUEN, 93400 SAINT OUEN
Prix de vente : 1850000 €
Date d’effet : 31/08/2012 

15/08/2012

JAL

Appointment of the social representative

Affiches parisiennes (Les)


Date de décision : 29/06/2012
Société faisant l'objet d'une nomination : 313334856 - CELIO FRANCE, CELIO, 21 RUE BLANQUI, SAINT OUEN, 93400 SAINT OUEN 
Nominé : 394182455 - FINANCIERE NAMSORG, 55 AV HOCHE, 75008 PARIS 8 
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Non renseignée CELIO INTERNATIONAL, 1060 BRUXELLES
En la fonction de : Administrateur

10/08/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

69 - RHONE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

995 - 313 334 856 RCS Bobigny. CELIO FRANCE. Forme : Société par Actions Simplifiée. Sigle : CELIO. Adresse : 21 rue Blanqui, 93406 Saint-Ouen cedex. 
Origine du fonds : Etablissement complémentaire acquis par achat au prix stipulé de 260000 EUR. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Vente au détail de tous articles d'habillement et tous accessoires s'y rapportant, notamment chaussures, maroquinerie et tous articles annexes. Adresse : centre commercial Givors les Deux Vallées, Bât b, Plaine du Gier, Lot 2, 69700 Givors. 
Précédent propriétaire : VETURA. 311 549 240 RCS Lyon. 
Date de commencement de l’activité : 15/07/2012. Publication légale : Tout Lyon du 04/08/2012. Oppositions : Chez Maître Delarue, huissier de justice, 13 rue Louis Guillaumont 69440 Mornant. Descriptif : Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

04/08/2012

JAL

Activity or goodwill cession

Tout Lyon (Le) - le Moniteur


Date de décision : 02/07/2012 
Cédant : 311549240 - VETURA, 81 RUE CARTIER BRESSON, 93500 PANTIN
Cessionnaire : 313334856 - CELIO FRANCE, CELIO, 21 RUE BLANQUI, SAINT OUEN, 93400 SAINT OUEN
Prix de vente : 260000 €
Date d’effet : 15/07/2012 

12/06/2012

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

21 - COTE-D'OR

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

482 - 313 334 856 RCS Bobigny. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : CELIO. Adresse : 21 rue Blanquin, 93406 Saint-Ouen Cedex. 
Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 200000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Vente au détail de prêt à porter masculin et tous accessoires s'y rapportant, chaussures, lingerie, maroquinerie. Adresse : 9 avenue du Général de Gaulle, Centre commercial St Jacques, 21200 Beaune. 
Précédent propriétaire : DOMEDIS. 419 486 725 RCS Toulouse. 
Date de commencement de l’activité : 01/05/2012. Publication légale : Terres de Bourgogne du 18/05/2012. Oppositions : Ordre des Avocats 11, place Dauphine 75001 Paris 01. Descriptif : Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

18/05/2012

JAL

Activity or goodwill cession

Terres de Bourgogne


Date de décision : 03/05/2012 
Cédant : 419486725 - DOMEDIS, 5 RUE LAMARTINE, 31800 SAINT GAUDENS
Cessionnaire : 313334856 - CELIO FRANCE, CELIO, 21 RUE BLANQUI, SAINT OUEN, 93400 SAINT OUEN
Prix de vente : 200000 €
Date d’effet : 01/05/2012 

30/12/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

1161 - 313 334 856 RCS Bobigny. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 8153904 EUR. Adresse : 21 rue Blanqui, 93406 Saint-Ouen. 
Origine du fonds : Acquis par fusion au prix stipulé de 792478 Euros. Etablissement : Etablissement principal. Adresse : 
Précédent propriétaire : ALB. 598 502 169 RCS Strasbourg. 
Date de commencement de l’activité : 21/12/2011. Oppositions : Pas d'opposition. Descriptif : AVIS DE PROJET DE FUSION. ALB, sis ¿ 2 rue de la Haute Mont¿e 67000 STRASBOURG, RCS BOBIGNY est soci¿t¿ absorb¿e. CELIO FRANCE, sis ¿ 21 RUE BLANQUI 93406 ST OUEN CEDEX, RCS BOBIGNY est soci¿t¿ absorbante. Actif : 395828 Euros, passif : 279436 Euros, apport net : 116392 Euros. Rapport d'¿change des droits sociaux : La soci¿t¿ absorbante d¿tenant la totalit¿ des actions de la soci¿t¿ absorb¿e, il n'y a pas lieu ¿ la d¿termination d'un rapport d'¿change et la soci¿t¿ absorbante ne proc¿dera pas ¿ une augmentation de capital. Montant pr¿vu de la prime de fusion : 792478 Euros. Date du projet : 13/12/2011 Les cr¿anciers des soci¿t¿s fusionnantes pourront former opposition ¿ cette fusion dans les conditions et d¿lais pr¿vus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce. Date du d¿p¿t : 14/12/2011, lieu du d¿p¿t : greffe tribuanl de commerce de Bobigny. Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

20/12/2011

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

10742 - 313334856 RCS. CELIO FRANCEForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 21 rue Blanqui 93406 Saint-Ouen. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/01/2011.

27/05/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

44 - LOIRE-ATLANTIQUE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

335 - 313 334 856 RCS Nantes. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 21 rue Blanqui, 93400 Saint Ouen. 
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 240.000,00 EUR. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Vente de prêt à porter hommes et accessoires s'y rapportant. Adresse : Centre Commercial Auchan, Local 90, 44230 Saint Sebastien Sur Loire. 
Précédent propriétaire : MARSODI. 300 286 333 RCS Nantes. 
A dater du : 06/04/1989. Date de commencement de l’activité : 15/03/1989. Publication légale : L'HEBDO DE SEVRE ET MAINE du 19/05/2011. Oppositions : SCP BLOT ET ASSOCIES 14 BOULEVARD WINSTON CHURCHILL BP 38522 44185 NANTES CEDEX 4. Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire). Date d’effet : 01/05/2011.

19/05/2011

JAL

Activity or goodwill cession

Hebdo de Sèvre et Maine (L')


Date de décision : 29/04/2011 
Cédant : 300286333 - ETABLISSEMENTS MARSODI, 5 RUE LAMARTINE, 31800 SAINT GAUDENS
Cessionnaire : 313334856 - CELIO FRANCE, CELIO, 21 RUE BLANQUI, SAINT OUEN, 93400 SAINT OUEN
Prix de vente : 240000 €
Date d’effet : 01/05/2011 

09/03/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

56 - MORBIHAN

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

687 - 313 334 856 RCS Bobigny. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 21 rue Blanqui, 93406 Saint-Ouen. 
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 240000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Vente de prêt à porter masculin. Adresse : 40 rue du Port, 56100 Lorient. 
Précédent propriétaire : PASCAL LE FLOCH VETEMENTS. 332 555 366 RCS Lorient. 
Date de commencement de l’activité : 01/02/2011. Publication légale : Ouest France du 23/02/2011. Oppositions : Siège du fonds vendu sis à Lorient 56100 40 rue du Port. Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

23/02/2011

JAL

Activity or goodwill cession

Ouest France/Edition du Morbihan


Date de décision : 01/02/2011 
Cédant : 332555366 - PASCAL LE FLOCH VETEMENTS, 43 RUE NATIONALE, ET 12 RUE CAINAIN, 56300 PONTIVY
Cessionnaire : 313334856 - CELIO FRANCE, CELIO, 21 RUE BLANQUI, SAINT OUEN, 93400 SAINT OUEN
Prix de vente : 240000 €
Date d’effet : 01/02/2011 

03/12/2010

JAL

Activity or goodwill cession

Var Information


Date de décision : 03/11/2010 
Cédant : 513551663 - SOHO-CONCORD, AV ANDRE ROUSSIN, LOT NORS DE MOUREPIANE, 13016 MARSEILLE 16
Cessionnaire : 313334856 - CELIO FRANCE, CELIO, 21 RUE BLANQUI, SAINT OUEN, 93400 SAINT OUEN
Prix de vente : 150000 €
Date d’effet : 01/11/2010 

19/11/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

2451 - 313 334 856 RCS Bobigny. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 20 Octobre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 20 Octobre 2009 Président : CELIO INTERNATIONAL en fonction le 09 Novembre 2010. Activité : 
Commentaires : Modification de représentant.

07/09/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

8273 - 313334856 RCS. CELIO FRANCEForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 21 rue Blanqui 93406 Saint-Ouen. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/01/2010.

29/10/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

2395 - 313 334 856 RCS Bobigny. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 20 Octobre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 20 Octobre 2009 Président : MOSNIER Ludovic, Yvan, Christian en fonction le 23 Décembre 2008. 
Commentaires : Modification de représentant.

23/10/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

9769 - 313334856 RCS. CELIO FRANCEForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 21 rue Blanqui 93406 Saint-Ouen. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/01/2009.

22/10/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

2811 - 313 334 856 RCS Bobigny. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 8153904 EUR. 
Commentaires : Modification du capital.

18/08/2009

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

45 - LOIRET

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

242 - 321 591 067 RCS Aix. SOCIETE PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : S.P.A.G. Capital : 1999950 EUR. Adresse : 1140 rue Ampère, Pôle d'Activités des Milles - Actimart II, 13851 Aix-en-Provence Cedex 3. 
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 200000 Euros. Etablissement : Établissement secondaire. Activité : un fonds de commerce de vente de prêt-à-porter pour hommes et accessoires. Adresse : 2 rue Nicolas Copernic, Centre Commercial place d'Arc, 45000 Orléans. 
Précédent propriétaire : CELIO FRANCE. 313 334 856 RCS Bobigny. 
Date de commencement de l’activité : 01/08/2009. Publication légale : L'ECLAIREUR DU GATINAIS du 13/08/2009. Oppositions : Pour la correspondance : S.E.L. d'avocats HENNION-GARRIOT & Associés, 8 rue Euthymènes 13001 Marseille pour la validité : au siège du fonds vendu. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

06/01/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

2569 - 313 334 856 RCS Bobigny. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Co-commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 29 Mai 2007. Co-commissaire aux comptes titulaire : MOITRIER Gérard modification le 29 Mai 2007. Co-commissaire aux comptes suppléant : COMELLI DE ROSA Véronique modification le 29 Mai 2007. Co-commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 29 Mai 2007. Président : MOSNIER Ludovic, Yvan, Christian en fonction le 23 Décembre 2008. 
Commentaires : Modification de représentant.

20/10/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

9378 - 313334856 RCS. CELIO FRANCEForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 21 rue Blanqui 93406 Saint-Ouen. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/01/2008.

20/06/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

3360 - 313 334 856 RCS Bobigny. CELIO FRANCE. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 8125344 EUR. 
Commentaires : Modification du capital.

29/11/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

9873 - 313 334 856. RCS Bobigny CELIO FRANCE. Forme: Société par actions simplifiée. Adresse du siège social: 21 rue Blanqui 93406 Saint-Ouen. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 janvier 2007.

29/11/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

9874 - 313 334 856. RCS Bobigny CELIO FRANCE. Forme: Société par actions simplifiée. Adresse du siège social: 21 rue Blanqui 93406 Saint-Ouen. Comptes consolidés et rapport de l'exercice clos le: 31 janvier 2007.

19/09/2007

Bodacc A

Vente et cession

978 - RCS Bobigny 313 334 856. CELIO FRANCE. Forme : S.A.S. Capital : 7 978 224 euros. Adresse du siège social : 21 rue Blanqui, 93400 Saint-Ouen. Etablissement principal - Adresse : 4 rue Delambre, 80000 Amiens. Droit au bail, dépendant de l'établissement principal, acquis par cession au prix stipulé de 1 290 755 euros. Date d'effet : 1er juillet 2007. Précédents propriétaires : Mme BRASSART (Marguerite). RCS 344 025 184. Mme LEGRIS (Marie-José). RCS 341 377 687. Publication légale : Picardie-la gazette du 11 au 17 juillet 2007. Oppositions : Me Bourbon (Claude), notaire associé, 18 place Parmentier, 80000 Amiens.

21/06/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

2552 - RCS Bobigny B 313 334 856. RC 87-B 8805. CELIO FRANCE. Forme : S.A.S. Commentaires : modification survenue sur la dénomination, la forme juridique et l'administration. Administration : modification d'un co-commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Modification du président : PIMONT (Christian). Président et membre du conseil de surveillance partant : GROSMAN (Marc). Membre du directoire partant : GROSMAN (Laurent). Modification d'un co-commissaire aux comptes titulaire : MOITRIER (Gérard). Modification d'un co-commissaire aux comptes suppléant : COMELLI DE ROSA (Véronique). Membre du directoire partant : FREDEAU (Antoinette) (Nom d'usage : GROSMAN). Membre du conseil de surveillance partant : WAHNICH (Ayouch). Modification d'un co-commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Membre du directoire partant : LOVISOLO (Eric, Jean, Maurice). Membres du conseil de surveillance partants : PALTI (Raphaël, Jacques) MALAMATINAS (Dionysios, Nicolaos) FINANCIERE NAMSORG, représentée par BENHAMOU (Karine) (Nom d'usage : GROSMAN).

08/12/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1962 - RCS Bobigny B 313 334 856. RC 87-B 8805. MARC LAURENT. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : membre du conseil de surveillance partant : MILCHIOR (Pierre).

05/12/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

2682 - RCS Bobigny B 313 334 856. RC 87-B 8805. MARC LAURENT. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un membre du conseil de surveillance : FINANCIERE NAMSORG, représentée par BENHAMOU (Karine) (Nom d'usage : GROSMAN).

01/09/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

5293 - RCS Bobigny B 313 334 856. RC 87-B 8805. MARC LAURENT. Forme: société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse du siège social: 21, rue Blanqui,93406 Saint-Ouen-Cedex. Comptes consolidés et rapport de l'exercice clos le: 31 janvier 2006.

01/09/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

5294 - RCS Bobigny B 313 334 856. RC 87-B 8805. MARC LAURENT. Forme: société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse du siège social: 21, rue Blanqui,93406 Saint-Ouen-Cedex. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 janvier 2006.

30/03/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

3597 - RCS Bobigny B 313 334 856. RC 87-B 8805. MARC LAURENT. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : membre du conseil de surveillance partant : KINAS (Jérôme).

30/03/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

3598 - RCS Bobigny B 313 334 856. RC 87-B 8805. MARC LAURENT. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un membre du conseil de surveillance : MALAMATINAS (Dionysios, Nicolaos).

25/11/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1563 - RCS Bobigny B 313 334 856. RC 87-B 8805. MARC LAURENT. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : membre du conseil de surveillance partant : APAX PARTNERS S.A., représentée par TCHENIO (Maurice).

16/09/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

4892 - RCS Bobigny B 313 334 856. RC 87-B 8805. MARC LAURENT. Forme: société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse du siège social: 21, rue Blanqui,93406 Saint-Ouen-Cedex. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 janvier 2005.

16/09/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

4893 - RCS Bobigny B 313 334 856. RC 87-B 8805. MARC LAURENT. Forme: société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Adresse du siège social: 21, rue Blanqui,93406 Saint-Ouen-Cedex. Comptes consolidés et rapport de l'exercice clos le: 31 janvier 2005.

30/08/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1076 - RCS Bobigny B 313 334 856. RC 87-B 8805. MARC LAURENT. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : membre du conseil de surveillance partant : FRAIBERGER (Alain).

30/08/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1077 - RCS Bobigny B 313 334 856. RC 87-B 8805. MARC LAURENT. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification d'un commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (S.A.).

24/03/2005

Bodacc A

Vente et cession

891 - RCS Evry B 313 334 856. RC AP-B 40371. MARC LAURENT. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Capital : 7 978 224 euros. Adresse du siège social : 21 Blanqui, 93400 Saint-Ouen. Etablissement principal - Activité : vente de prêt-à-porter pour hommes et d'accessoires s'y rapportant. Adresse : 1 avenue de la Croix-Blanche, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois. Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 500 000 euros. Date d'effet : 1er mars 2005. Précédent propriétaire : VELMEUBLES. RCS 395 374 879. Publication légale : Les Petites affiches de la Seine-et-Oise du 15 mars 2005. Oppositions : au fonds, pour la validité et la correspondance.

06/02/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

2073 - RCS Bobigny B 313 334 856. RC 87-B 8805. MARC LAURENT. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Capital : 7 978 224 euros. Nom commercial : Célio. Commentaires : modification survenue sur le capital (diminution).

28/12/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Bobigny B 313334856 RC 87-B 8805 MARC LAURENT. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance Nom commercial: Célio. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : modification d'un président et membre du directoire : PIMONT (Christian). Modification d'un membre du directoire : GROSMAN (Laurent).

29/09/2004

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 313334856 RC 86-B 303 MARC LAURENT. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance Nom commercial: Célio. Adresse du siège social : 21 rue Blanqui, 93406 Saint-Ouen Cedex ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : négoce de pret-à-porter masculin. Adresse : R.N. 10, lieudit Le Village, 78310 Coignières Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 150 000 euros Date de début d'activité: 18 aout 2004. Précédent propriétaire : VELMEUBLES. RCS 395374879 Publication légale: Les Petites affiches de Seine-et-Oise du 17 aout 2004. Oppositions : au fonds, pour la validité et la correspondance.

16/09/2004

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 313334856 RC 90-B 499 MARC LAURENT. Sigle : CELIO. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance Nom commercial: Celio. Adresse du siège social : 21 rue Auguste-Blanqui, 93406 Saint-Ouen Cedex ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Adresse : centre commercial Avant Cap, local n° 36, Plan-de- Campagne, 13480 Cabriès Etablissement Complémentaire. Enseigne : Celio. Activité : pret-à-porter pour hommes. Adresse : centre commercial La Pioline, 1175 rue Guillaume-du-Vair, 13290 Aix-les-Milles Etablissement complémentaire acquis par achat au prix stipulé de 600 000 euros. Date d'effet : 16 février 2004. Précédent propriétaire : S.A. CALL. RCS 351749742 RC 01-B 1120 Publication légale: Les Nouvelles publications du 5 mars 2004. Oppositions : au fonds.

19/08/2004

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 313334856 RC 04-B 239 MARC LAURENT. Sigle : CELIO. Forme : S.A. à directoire Nom commercial: Célio. Adresse du siège social : 21 rue Blanqui, 93406 Saint-Ouen Cedex ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente de vetements confectionnés pour hommes et d' accessoires s'y rapportant. Adresse : centre commercial Carrefour, 34540 Balaruc-le-Vieux Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 750 000 euros Date de début d'activité: 16 février 2004. Précédent propriétaire : CALL. RCS B 351749742 Publication légale: Hérault juridique et économique du 4 juin 2004. Oppositions : au fonds.

19/05/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Bobigny B 313334856 RC 87-B 8805 MARC LAURENT. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance Nom commercial: Célio. Commentaires : modification survenue sur l' administration. Administration : membres du conseil de surveillance partants : CDR PARTICIPATIONS, représentée par DE LA CHAPELLE (Philippe, Georges) GROSMAN (Maurice). Nomination de membres du conseil de surveillance : MILCHIOR (Pierre) PALTI (Raphael, Jacques).

09/05/2004

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Bobigny B 313334856 MARC LAURENT. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Capital : 8 846 080 euros. Adresse du siège social : 21 rue Blanqui, 94300 Saint-Ouen Etablissement principal: Adresse : centre commercial Carrefour, locaux n° s 19 et 20, R.N. 7, 83480 Puget-sur-Argens Cession de droit au renouvellement de bail au prix stipulé de 330 000 euros. Date d'effet : 15 mars 2004. Précédent propriétaire : PAPPINI HABILLEURS S.A.R.L. RCS Fréjus B 327046835 Publication légale: Var- Information des 17 et 24 mars 2004. Oppositions : Cabinet de M e Varner ( Marion, D.), avocat, 1 place Pierre- Collet, 83700 Saint-Raphael, pour la correspondance et au fonds, pour la validité.

21/04/2004

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 313334856 RC 90-B 69 MARC LAURENT. Sigle : CELIO. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance Nom commercial: Célio. Adresse du siège social : 21 rue Blanqui, 93406 Saint- Ouen ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Enseigne : Célio. Activité : pret-à-porter pour hommes. Adresse : centre commercial de Roques, 31120 Roques Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 606 000 euros. Date d'effet : 16 février 2004. Précédent propriétaire : S.A. CALL. RCS B 351749742 Publication légale: O Toulouse-La gazette du 27 février 2004. Oppositions : Etude de M e Dagot, notaire, 6 place Wilson, 31000 Toulouse.

28/03/2004

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 313334856 RC 98-B 384 MARC LAURENT. Sigle : CELIO. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance Nom commercial: Célio. Adresse du siège social : 21 rue Blanqui, 93406 Saint- Ouen Cedex ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente de pret-à-porter pour hommes et d'accessoires. Adresse : centre commercial de Barentin, Hameau de Mesnil-Roux, 76360 Barentin Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 1 100 000 euros. Date d'effet : 16 février 2004. Précédent propriétaire : CALL S.A Publication légale: Les Affiches de Normandie du 25 février 2004. Oppositions : au fonds.

10/03/2004

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 313334856 RC 91-B 1900 MARC LAURENT. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance Nom commercial: Célio. Adresse du siège social : 21 rue Blanqui, 93406 Saint-Ouen Cedex ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente de pret-à-porter pour hommes et d' accessoires. Adresse : centre commercial Athis, 180 R.N. 7, 91200 Athis-Mons Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 217 000 euros Date de début d'activité: 9 février 2004. Précédent propriétaire : S.A. CALL. RCS 351749742 Publication légale: Les Petites affiches de la Seine-et-Oise du 24 février 2004. Oppositions : au fonds, pour la validité et la correspondance.

17/02/2004

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Bobigny B 313334856 MARC LAURENT. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Capital : 8 846 080 euros. Adresse du siège social : 21 rue Blanqui, 93400 Saint-Ouen. Administration : président du directoire : GROSMAN ( Laurent) Etablissement principal: Activité : pret-à-porter masculin. Adresse : centre commercial Auchan de Chambray II, 37170 Chambray-lès-Tours Etablissement principal acquis par cession au prix stipulé de 381 000 euros. Date d'effet : 1 e r janvier 2004. Précédent propriétaire : CHAMBRAY- CONFECTION S.A.R.L. RCS Tours B 343421442 Publication légale: Le Courrier français, édition Indre-et- Loire, du 23 janvier 2004. Oppositions : M e Brillatz, 19 rue Edouard-Vaillant, 37000 Tours et au fonds pour la validité.

14/01/2004

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Pontoise B 313334856 RC 88-B 1695 MARC LAURENT. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance Nom commercial: Célio. Adresse du siège social : 21 rue Blanqui, 93406 Saint- Ouen Cedex ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente de pret-à-porter pour hommes et d'accessoires s'y rapportant. Adresse : 174 boulevard du Havre, 95220 Herblay Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 490 547 euros Date de début d'activité: 1 e r novembre 2003. Précédent propriétaire : VELMEUBLES. RCS 395374879 Publication légale: L'Echo-Le Régional du 3 décembre 2003. Oppositions : au fonds, pour la validité et la correspondance.

10/12/2003

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 313334856 RC AP-B 871 MARC LAURENT. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance. Capital : 8 846 080 F. Adresse du siège social : 21 rue Blanqui, 93400 Saint-Ouen Etablissement principal: Activité : commerce d' équipement de la personne et de la maison. Adresse : 174 boulevard du Havre, 95220 Herblay Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 490 547 euros. Date d'effet : 1 e r novembre 2003. Précédent propriétaire : VELMEUBLES. RCS 395374879 Publication légale: L' Echo d'Enghien Montmorency du 3 décembre 2003. Oppositions : au fonds, pour la validité et la correspondance.

27/11/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Bobigny B 313334856 RC 87-B 8805 MARC LAURENT. Forme : S.A. à directoire et conseil de surveillance Nom commercial: Célio. Commentaires : modification survenue sur la forme juridique et l'administration. Administration : commissaire aux comptes suppléant partant : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU PARIS. Modification d'un membre du directoire : PIMONT ( Christian). Modification de membres du conseil de surveillance : APAX PARTNERS S.A., représentée par TCHENIO (Maurice) FRAIBERGER (Alain). Modification d'un président et membre du conseil de surveillance : GROSMAN (Marc). Modification d'un membre du conseil de surveillance : CDR PARTICIPATIONS, représentée par DE LA CHAPELLE ( Philippe, Georges). Administrateur partant : MEYOHAS (Nathan). Modification d'un président et membre du directoire : GROSMAN (Laurent). Modification d'un membre du conseil de surveillance : KINAS (Jérome). Modification d'un membre du directoire : FREDEAU (Antoinette) ( Nom d'usage : GROSMAN). Nomination de membres du conseil de surveillance : GROSMAN ( Maurice) WAHNICH (Ayouch). Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Nomination d'un membre du directoire : LOVISOLO (Eric, Jean, Maurice).

02/07/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Bobigny B 313334856 RC 87-B 8805 MARC LAURENT. Forme : S.A Nom commercial: Célio. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un directeur général délégué : FREDEAU ( Antoinette) ( Nom d'usage : GROSMAN).

02/07/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Bobigny B 313334856 RC 87-B 8805 MARC LAURENT. Forme : S.A Nom commercial: Célio. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : modification d'un directeur général délégué et administrateur : GROSMAN (Marc). Modification du président du conseil d' administration, directeur général et administrateur : GROSMAN (Laurent). Commissaire aux comptes suppléant partant : NACCACHE (Claude). Directeur général délégué partant : FREDEAU ( Antoinette) ( Nom d'usage : GROSMAN). Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : COMELLI DE ROSA (Véronique).

13/06/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Bobigny B 313334856 RC 87-B 8805 MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : 8 846 080 euros Nom commercial: Célio. Activité : achat, vente de tous articles vestimentaires pour hommes, femmes ou enfants bonneterie, lingerie, vetements, articles de sport et de loisirs, chaussures, maroquinerie, plus généralement, tous articles d' équipement de la personne. Adresse du siège social : 21 rue Blanqui, 93406 Saint-Ouen Cedex. Commentaires : modification survenue sur le capital ( augmentation). Cette société transfère son siège du 100 rue Saint-Lazare, 75009 Paris. Administration : nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU PARIS. Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDIT. Nomination d'administrateurs : PIMONT (Christian) APAX PARTNERS S.A., représentée par TCHENIO (Maurice) FRAIBERGER (Alain). Nomination d'un directeur général et administrateur : GROSMAN (Marc). Nomination d' administrateurs : C.D.R. PARTICIPATIONS, représentée par DE LA CHAPELLE ( Philippe, Georges) MEYOHAS (Nathan). Nomination du président du conseil d' administration et directeur général : GROSMAN (Laurent). Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : MOITRIER (Gérard). Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : NACCACHE (Claude). Nomination d'un administrateur : KINAS (Jérome) Date de début d'activité: 17 avril 2003.

29/09/2002

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 309706992 RC AP-B 1286 GINGER. Forme : S.A. Capital : 38 112,25 euros. Adresse du siège social : 121 boulevard de Sébastopol, 75002 Paris Etablissement principal: Activité : droit au bail des locaux. Adresse : 31 boulevard Saint-Michel, 75005 Paris Droit au bail, dépendant de l' établissement principal, acquis par cession au prix stipulé de 762 245 euros. Date d'effet : 1 e r aout 2002. Précédent propriétaire : MARC LAURENT. RCS B 313334856 Publication légale: Le Publicateur légal du 16 septembre 2002. Oppositions : Société Marc Laurent, 100 rue Saint-Lazare, 75009 Paris.

09/07/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 313334856 RC 78-B 5824 MARC LAURENT. Forme : S.A Nom commercial: Célio. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateurs partants : HOLDER (Francis) LIKIERMAN (George, Michael).

09/07/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 313334856 RC 78-B 5824 MARC LAURENT. Forme : S.A Nom commercial: Célio. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un administrateur : PIMONT (Christian).

09/07/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 313334856 RC 78-B 5824 MARC LAURENT. Forme : S.A Nom commercial: Celio. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : LAUNAY (Pascal).

20/09/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 313334856 RC 78-B 5824 MARC LAURENT. Forme : S.A Nom commercial: Celio. Activité : achat, vente de tous articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants bonneterie, lingerie, vente de vetements et d' articles de sport et de loisirs, de chaussures, de maroquinerie. Plus généralement, tous articles d' équipement de la personne. Commentaires : modification survenue sur l'activité.

04/09/2001

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 313334856 RC 91-B 2153 MARC LAURENT. Forme : S.A Nom commercial: Célio. Adresse du siège social : 100 rue Saint-Lazare, 75009 Paris Etablissement principal: Enseigne : Célio. Activité : vente de pret-à-porter pour hommes ou femmes et à titre accessoire de chaussures. Adresse : centre commercial Bourse, local n° 3, 17 cour Belsunce, 13001 Marseille ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : achat, vente de tous articles vestimentaires pour hommes, femmes ou enfants, de bonneterie, de lingerie, de chaussures, de maroquinerie et de tous articles de nouveautés. Adresse : 67 rue Saint- Ferréol, 13006 Marseille Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 7 210 000 F Date de début d' activité: 7 décembre 1991. Date d'effet : 1 e r septembre 2000. Précédent propriétaire : BLANC Simone, Arlette, Angeline. RCS A 069703916 Publication légale: Semaine Provence du 27 juillet 2001. Oppositions : S.E.L.A.R.L. Guillosson et Associés, 46 rue Saint- Jacques, 13006 Marseille.

22/08/2001

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Marseille B 313334856 RC AP-B 586 MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : 55 288 000 F. Adresse du siège social : 100 rue Saint-Lazare, 75009 Paris Etablissement principal: Activité : pret-à-porter. Adresse : 67 rue Saint-Ferréol, 13006 Marseille Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 7 210 000 F. Date d'effet : 1 e r juillet 2001. Précédent propriétaire : BLANC Simone, Arlette, Angeline. RCS A 069703916 Publication légale: Les Travaux publics et batiment du Midi du 27 juillet 2001. Oppositions : S.E.L.A.R. L. Guillosson et Associés, avocats, 46 rue Saint-Jacques, 13006 Marseille.

15/08/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 313334856 RC 78-B 5824 MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : 8 846 080 euros Nom commercial: Célio. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation).

17/07/2001

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Bobigny B 389730599 MARC ORIAN. Forme : S.A. Capital : 66 748 100 F. Adresse du siège social : 410 La Courtine, 93194 Noisy-le-Grand ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : pret- à-porter. Adresse : centre commercial Espace d'Erlon, lot n° 9 et 9 B, 51100 Reims Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 3 000 000 de F. Date d'effet : 1 e r mai 2001. Précédent propriétaire : MARC LAURENT S.A. RCS Paris B 313334856 Publication légale: Les Petites affiches Matot- Braine du 20 juin 2001. Oppositions : au fonds.

06/05/2001

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Bobigny B 351749742 RC AP-B 818 CALL. Forme : S.A. Capital : 2 882 000 F. Adresse du siège social : immeuble Paryseine, 4-5 allée de la Seine, 94200 Ivry-sur-Seine Etablissement principal: Activité : vente de pret-à-porter pour hommes. Adresse : centre commercial Bobigny 2, local n° 30, boulevard Maurice-Thorez, 93000 Bobigny Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 500 000 F. Date d'effet : 1 e r avril 2001. Précédent propriétaire : MARC LAURENT. RCS B 313334856 Publication légale: Le Publicateur légal du 20 avril 2001. Oppositions : au siège de la société Marc Laurent, 21 rue Blanqui, 93406 Saint-Ouen.

25/01/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 313334856 RC 78-B 5824 MARC LAURENT. Forme : S.A Nom commercial: Celio. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un administrateur : KINAS (Jérome).

09/01/2000

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 313334856 RC 93-B 491 MARC LAURENT. Sigle : CELIO. Forme : S.A Nom commercial: Célio. Adresse du siège social : 100 rue Saint-Lazare, 75009 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Enseigne : Celio. Activité : vente d'articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, bonneterie. Adresse : 27 rue du 11 Novembre, 63000 Clermont-Ferrand Droit au bail concernant l' établissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 2 813 994 F Date de début d'activité: 29 octobre 1993. Date d'effet : 4 décembre 1999. Précédent propriétaire : LAUREA. RCS B 319558060 Publication légale: Jugement de valeurs du 13 octobre 1993.

04/01/2000

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 313 334 856 RC 92-B 478 MARC LAURENT. Forme : S.A. Nom commercial: Celio. Adresse du siège social : 100 rue Saint-Lazare, 75009 Paris Droit au bail acquis par cession au prix stipulé de 200 000 F Etablissement principal: Activité : droit au bail. Adresse : centre commercial Jacobins, 72000 Le Mans. Date d'effet : 1er décembre 1999 Précédente propriétaire-exploitante F DE FEMME. RCS Le Mans B 388 655 193 RC 92-B 487 Publication légale: L' Agriculture sarthoise du 17 décembre 1999. Oppositions : les juristes associés du Maine, représentée par Bollengier Stragier, 1 place Lionel-Lecouteux, 72000 Le Mans.

26/12/1999

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 313334856 MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : 55 288 000 F. Adresse du siège social : 100 rue Saint- Lazare, 75009 Paris Etablissement principal: Activité : droit au bail de divers locaux commerciaux dépendant d' un immeuble. Adresse : 3 boulevard Saint- Michel et 42 rue Saint-Séverin, 75005 Paris Droit au bail de l'établissement principal acquis par cession au prix stipulé de 10 700 000 F. Date d'effet : 1 e r février 2000. Précédent propriétaire : CHAUSSURES BALLY FRANCE. RCS B 552006702 Publication légale: La Gazette du Palais du 7 décembre 1999. Oppositions : Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats, 11 place Dauphine, 75053 Paris Louvre R.P.-S.P.

02/07/1999

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Versailles B 313334856 RC 86-B 303 MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : 300 000 F Nom commercial: Celio. Adresse du siège social : 100, rue Saint-Lazare 75009 Paris Etablissement principal: Activité : pret-à-porter féminin et masculin. Adresse : Parly II, Extension, centre commercial régional, niveau 1, lot 1.6 78150 Le Chesnay ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : pret-à-porter masculin et accessoires s'y rapportant à l'exception de toute solderie et/ou de discount. Adresse : centre commercial de Parly-2, lots 126 A et B 78150 Le Chesnay Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 8 300 000 F. Date d'effet : 22 avril 1999 Date de début d'activité: 15 octobre 1987. Précédent propriétaire : GUEPARD S.A. RCS B 305707424 Publication légale: La Semaine de l'Ile-de-France du 1 e r avril 1999. Oppositions : étude Evremond Bac 16, rue Saint-Simon, 78000 Versailles.

18/05/1999

Bodacc A

Création d'établissement

Rectificatif: Annonce numéro: 939 Date de parution: 23 avril 1999 Page: 50 Numéro de parution: 78A Au lieu de : Capital : 300 000 F, lire : RCS Versailles B 313 334 856 MARC LAURENT. Capital : 55 288 000 F.

04/05/1999

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 313 334 856 SOCIETE MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : 55 288 000 F. Adresse du siège social : 100 rue Saint- Lazare 75009 Paris Etablissement principal: Activité : commerce de pret-à- porter pour hommes, femmes et enfants. Adresse : centre commercial régional Evry 2 91000 Evry Cession de l' établissement principal au prix stipulé de 3 000 000 de F. Date d'effet : 26 mars 1999. Précédent propriétaire : GUEPARD. RCS B 305 707 424 Publication légale: La Semaine de l'Ile-de-France du 9 avril 1999. Oppositions : Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats, 11 place Dauphine, 75001 Paris, pour la correspondance et S.C.P. Papillon Siband, 11 boulevard de l'Europe, 91- Evry, pour la validité.

29/04/1999

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 313 334 856 SOCIETE MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : 55 288 000 F. Adresse du siège social : 100 rue Saint-Lazare, 75009 Paris Fonds secondaire acquis par achat, au prix stipulé de 700 000 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : pret-à-porter, homme, femme, enfant. Adresse : centre commercial régional, Villeneuve 2, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Date d'effet : 12 mars 1999 Précédente propriétaire SOCIETE GUEPARD S.A. 305 707 424. RCS Créteil. Publication légale: La Gazette de la Région du Nord du 27 mars 1999. Oppositions : Séquestre juridique de l'Ordre des avocats à Paris (75001), 11 place Dauphiné, et pour la validité, étude Pérard, Bue, Dupont, 7 rue des Fabricants, B.P. 297, 59055 Roubaix cedex 1.

23/04/1999

Bodacc A

Création d'établissement

RCS *. RCS Versailles B 313 334 856 MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : 300 000 F. Adresse du siège social : 100, rue Saint- Lazare 75009 Paris Etablissement principal: Activité : pret-à-porter pour homme, femme et enfant. Adresse : Parly II, extension centre commercial régional, niveau 1, lot 1-6 78150 Le Chesnay Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 8 300 000 F. Date d'effet : 12 mars 1999. Précédent propriétaire : : GUEPARD S.A. RCS RCS B 305 707 424 Publication légale: La Semaine de L'Ile-de-France du 26 mars 1999. Oppositions : Me Bac, 16, rue Saint- Simon, 78000 Versailles et pour la correspondance, Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats, 11, place Dauphine, 75 Paris 1er.

21/03/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 313 334 856 RC 78-B 5824 MARC LAURENT. Forme : S.A Nom commercial: Célio. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un administrateur : MEYOHAS (Nathan).

27/02/1999

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 313 334 856 RC 98-B 384 MARC LAURENT. Forme : S.A Nom commercial: Célio. Adresse du siège social : 100 rue Saint-Lazare 75009 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente de vetements pour hommes, femmes et enfants. Adresse : 52 rue Jeanne-d'Arc et 105 rue du Gros- Horloge 76000 Rouen Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 4 900 000 F Date de début d' activité: 22 janvier 1999. Précédent propriétaire : MANARES-COVETT. RCS Amiens B 854 200 821 RC 57-B 559 Publication légale: Les Affiches de Normandie du 3 février 1999. Oppositions : S.C.P. Dupif, Carucci et Golliot, huissiers de justice, 28 rue Camille-Saint-Saens, 76000 Rouen.

29/11/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 313 334 856 MARC LAURENT. Forme : S. A. Capital : 55 288 000 F. Adresse du siège social : 100 rue Saint-Lazare 75009 Paris Etablissement principal: Activité : droit au bail des locaux. Adresse : centre commercial Les Arcades n° 224 93160 Noisy-le-Grand Droit au bail acquis par cession au prix stipulé de 3 000 000 de F. Date d'effet : 2 novembre 1998. Précédent propriétaire : SOCIETE ADRIEN CAIRES. RCS B 313 299 191 Publication légale: Le Publicateur légal du 13 novembre 1998. Oppositions : Me Cabanes-Gelly, notaire, 9 rue de Paris, 93380 Pierrefitte.

12/09/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 313 334 856 MARC LAURENT. Forme : S. A. Capital : 55 288 000 F. Adresse du siège social : 100 rue Saint-Lazare 75009 Paris Etablissement principal: Activité : droit au bail. Adresse : 62 rue François-Mitterrand 58000 Nevers Cession du droit au bail au prix stipulé de 1 600 000 F. Date d'effet : 17 aout 1998. Précédent propriétaire : JOANNA S.A.R.L. RCS Nevers B 382 851 889 RC 91- B 163 Publication légale: L'Echo charitois du 28 aout 1998. Oppositions : S.C.P. Lecomte et Métayer, notaires associés, 6 avenue Saint-Just, Nevers.

23/08/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 313 334 856 RC 78-B 5824 MARC LAURENT. Forme : S.A Nom commercial: Célio. Activité : achat, vente de tous articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, de bonneterie, de lingerie, de vetements, d'articles de sport et de loisirs, de chaussures, de maroquinerie plus généralement de tous articles d'équipement de la personne. Commentaires : modification survenue sur l'activité et l' administration. Administration : modification du président du conseil d' administration : GROSMAN (Laurent). Modification du directeur général et administrateur : GROSMAN (Marc). Nomination d'un administrateur : LAUNAY (Pascal). Modification du commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDIT.

16/06/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 313 334 856 MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : 55 288 000 F. Adresse du siège social : 100 rue Saint- Lazare, 75009 Paris Droit au bail dépendant du fonds principal acquis par cession, au prix stipulé de 2 000 000 de F Etablissement principal: Activité : droit au bail. Adresse : centre commercial La Place-des-Halles, local 251, 67000 Strasbourg. Date d'effet : 15 avril 1998 Précédente propriétaire CHAUSSURES CENDRY. RCS Nancy B 016 250 433 Publication légale: Les Affiches d' Alsace Lorraine du 5 mai 1998. Oppositions : pour la correspondance, Me Cuif (Alain), notaire, 2 place A.- Maginot, 54000 Nancy et au lieu du bail cédé pour la validité.

26/04/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 313 334 856 RC 78-B 5824 MARC LAURENT. Forme : S.A Nom commercial: Célio. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination d'un administrateur : LIKIERMAN (George, Michael).

12/12/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Paris B 313 334 856 RC RC 78- B 5824 MARC LAURENT. Forme : S.A Nom commercial: Célio. Adresse du siège social : 100, rue Saint-Lazare 75009 Paris Etablissement principal: Adresse : 100, rue Saint-Lazare 75009 Paris. Commentaires : modification survenue sur l'adresse du siège social et de l' établissement principal.

06/12/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 313 334 856 MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : 55 288 000 F. Adresse du siège social : 96 rue Saint- Lazare 75009 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : droit au bail. Adresse : 53-57 rue du Gros-Horloge 76000 Rouen Droit au bail dépendant de l'établissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 13 000 000 de F Date de début d'activité: 26 janvier 1998. Précédent propriétaire : NORMANDIE CHAUSSURES. RCS Rouen B 570 502 518 RC 57-B 251 Publication légale: Les Affiches de Normandie du 29 octobre 1997. Oppositions : Etude de Me Heurteaux, huissier de justice, 6 quai du Havre, 76000 Rouen et au Bureau d'Etudes Juridiques et Fiscales Grégoire, 81 boulevard de Courcelles, 75008 Paris pour la correspondance.

31/10/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS *. RCS Paris B 313 334 856 MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : 55 288 000 F. Adresse du siège social : 96, rue Saint-Lazare 75009 Paris Etablissement principal: Activité : droit au bail des locaux. Adresse : 31, boulevard Saint- Michel 75005 Paris Droit au bail acquis par cession au prix stipulé de 4 500 000 F. Date d'effet : 1er octobre 1997. Précédent propriétaire : : S.A. JACQUARD DU MONDE PARIS. RCS RCS B 401 573 456 Publication légale: Le Publicateur Légal du 15 octobre 1997. Oppositions : Me Bruno Anger, chez Fidal Direction Paris et International, 27, rue de Courcelles, 75008 Paris.

19/10/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 313 334 856 S.A MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : 55 288 000 F. Adresse du siège social : 96 rue Saint- Lazare 75009 Paris Etablissement principal: Activité : salon de thé avec restauration, patisserie, confiserie, glacier, snack-bar, bar et vente de café à emporter. Adresse : 150 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 28 000 000 de F. Date d'effet : 2 février 1998. Précédent propriétaire : ELY CLUB. RCS B 562 074 773 Publication légale: La Gazette du Palais du 2 octobre 1997. Oppositions : Cabinet R.T. Conseil Avocat, 3 rue Antoine-Hajje, 75015 Paris.

20/09/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 313 334 856 RC 78-B 5824 MARC LAURENT. Forme : S.A Nom commercial: Célio. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : administrateur partant : BRANGER (Jean-Jacques). Nomination d'un administrateur : HOLDER (Francis).

02/05/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 552 015 307 ETAM DISTRIBUTION. Forme : S.A. Capital : . Adresse du siège social : 69-73 boulevard Victor-Hugo 93400 Saint-Ouen Etablissement principal: Activité : droit au bail. Adresse : centre commercial Bures Orsay, local n°s 11 et 13 91940 Les Ulis Droit au bail acquis par achat au prix stipulé de 500 000 F. Date d'effet : 17 mars 1997. Précédent propriétaire : MARC LAURENT. RCS B 313 334 856 Publication légale: Les Affiches versaillaises et de Seine-et-Oise du 10 avril 1997. Oppositions : au fonds.

23/03/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 313 334 856 RC 78-B 5824 MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : 55 288 000 F Nom commercial: Célio. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation) et l' administration. Administration : modification d'un administrateur : CLINVEST.

23/03/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 313 334 856 RC 78-B 5824 MARC LAURENT. Forme : S.A Nom commercial: Célio. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : suppression d'un administrateur : FIORENTINO (Marc).

24/03/1996

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 313 334 856 RC 92-B 1695 MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : Nom commercial: Célio. Adresse du siège social : 96 rue Saint-Lazare 75009 Paris Etablissement principal: Adresse : centre commercial Les Trois Moulins 92130 Issy-les-Moulineaux. Activité : pret-à-porter masculin et accessoires ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Adresse : Les Colonnades, centre commercial Les Quatre Temps 92800 Puteaux. Activité : négoce de vetements et d'accessoires de toilette pour hommes, femmes et enfants création, fabrication, transformation, vente en demi-gros, import-export Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 1 300 000 F Date de début d'activité: 26 mars 1992. Date d'effet : 1er janvier 1996. Précédent propriétaire : SOCIETE 4e PARENTHESE. RCS B 333 786 721 Publication légale: Les Petites affiches du 23 février 1996. Oppositions : Etude de Me Gorins, 6 rue du Crouet, 75008 Paris pour la correspondance et au fonds pour la validité.

22/03/1996

Bodacc A

Création d'établissement

RCS *. RCS Paris B 313 334 856 MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : 1 382 000 F. Adresse du siège social : 96, rue Saint- Lazare 75009 Paris Etablissement principal: Activité : droit au bail des locaux. Adresse : 66, boulevard du Montparnasse, centre commercial tour Maine-Montparnasse 75015 Paris Droit au bail acquis par cession au prix stipulé de 1 250 000 F. Date d'effet : 1er mars 1996. Précédent propriétaire : : MONTPARNACADI. RCS RCS B 341 116 721 Publication légale: Le Publicateur Légal du 6 mars 1996. Oppositions : Office Juridique et Judiciaire de l' Entreprise O.J.J.E., 140, rue du Chevaleret, 75013 Paris.

18/02/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Paris B 313 334 856 RC 78-B 5824 MARC LAURENT. Forme : S.A Nom commercial: Célio. Administration : président du conseil d'administration : GROSMAN ( Marc). Directeur général et administrateur : GROSMAN (Laurent). Administrateurs : FRAIBERGER (Alain) BRANGER (Jean-Jacques) FIORENTINO ( Marc) CREDIT LYONNAIS INVESTISSEMENT- CLINVEST APAX PARTNERS ET COMPAGNIE VENTURES. Commissaires aux comptes titulaires : MOITRIER (Gérard) B.D.A. Commissaires aux comptes suppléants : NACCACHE (Claude) DELOITTE TOUCHE TOHMATSU-PARIS AUDIT. Commentaires : modification survenue sur l' administration.

29/11/1995

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 313 334 856 MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : 1 382 200 F. Adresse du siège social : 96 rue Saint-Lazare 75009 Paris Etablissement principal: Adresse : centre commercial Nice Etoile, 319 niveau n° 1 06000 Nice Cession du droit au bail au prix stipulé de 2 600 000 F. Date d'effet : 16 octobre 1995. Précédent propriétaire : AZRIEL S.A.R.L. RCS Nice B 318 570 983 Publication légale: Les Petites affiches des Alpes- Maritimes du 26 octobre 1995. Oppositions : S.C.P. d'Huissiers Bernard et Olivier Leydet, 5 rue du Congrès, 06000 Nice et gestion des oppositions au Cabinet de Me Lucaioli-Laperle, 96 avenue Victor-Hugo, 75116 Paris.

23/06/1995

Bodacc A

Création d'établissement

RCS *. RCS Paris B 313 334 856 RC RC 78- B 5824 MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : 1 382 200 F Nom commercial: Célio. Adresse du siège social : 96, rue Saint- Lazare 75009 Paris Etablissement principal: Activité : achat et vente de tous articles vestimentaires pour hommes, dames et enfants, bonneterie, lingerie, chaussures, maroquinerie et tous articles de nouveautés. Adresse : 96, rue Saint-Lazare 75009 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : commerce de pret-à-porter. Adresse : 83, avenue du Général-Leclerc 75014 Paris Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 7 000 000 de F Date de début d'activité: 1er juin 1978. Précédent propriétaire : : SECOMO - SOCIETE DE CREATION ET DE COMMERCIALISATION D'ARTICLES DE MODE Publication légale: Le Publicateur Légal du 10 mars 1995. Oppositions : au fonds.

25/05/1995

Bodacc A

Création d'établissement

RCS. RCS Carcassonne B 313 334 856 MARC LAURENT S.A. Forme : S.A. Capital : 1 382 200 F. Adresse du siège social : 96, rue Saint-Lazare 75009 Paris. Administration : président-directeur général : GROSMAN ( Marc) Droit au bail acquis par cession au prix stipulé de 1 870 000 F Etablissement principal: Adresse : angle rue Georges-Clemenceau et rue l'Aigle-d' Or 11000 Carcassonne. Date d'effet : 3 avril 1995 Précédents propriétaires- exploitants : CUIN Philippe CUIN Pierre CUIN André Publication légale: Narbonne Echo du 14 avril 1995. Oppositions : étude de Me Romieu, avocat, 31, boulevard Omer-Sarraut, 11000 Carcassonne.

23/04/1995

Bodacc A

Création d'établissement

RCS. RCS Paris B 313 334 856 MARC LAURENT S.A. Forme : S.A. Capital : 1 382 200 F. Adresse du siège social : 96, rue Saint-Lazare 75009 Paris Fonds secondaire acquis par achat au prix stipulé de 4 550 000 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Enseigne : Mélodie Alcatraz. Activité : pret-à-porter féminin. Adresse : 27, rue Gambetta 86000 Poitiers. Date d'effet : 28 février 1995. Précédent propriétaire : : S.A. ELODIE. RCS RCS Poitiers B 315 173 815 Publication légale: Le Courrier Français Vienne du 17 mars 1995. Oppositions : Me Ménard, Pizon, Rousseau, notaires, 28, rue Carnot, 86000 Poitiers.

18/04/1995

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 313 334 856 MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : Nom commercial: Célio. Adresse du siège social : 96 rue Saint-Lazare 75009 Paris ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : pret-à-porter pour hommes et femmes, tous accessoires s'y rapportant. Adresse : centre commercial Auchan, local n° 64 57210 Semecourt Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 2 000 000 de F. Commentaires : suppression du fonds sis centre commercial Auchan, local n° 54, 57210 Semecourt. Date d'effet : 1er septembre 1994. Précédent propriétaire : SOCIETE MONTAGUE BURTON S.A. RCS B 552 123 911 Publication légale: Le Républicain lorrain du 11 septembre 1994. Oppositions : Me Conrad, 1 bis place Saint-Martin, 57000 Metz.

25/03/1995

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 313 334 856 MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : 1 382 200 F. Adresse du siège social : 96 rue Saint-Lazare 75009 Paris Etablissement principal: Adresse : 83 avenue du Général-Leclerc 75014 Paris. Activité : commerce de pret-à -porter masculin Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 7 000 000 de F. Date d'effet : 27 février 1995. Précédent propriétaire : SOCIETE DE CREATION ET DE COMMERCIALISATION D'ARTICLES DE MODE. RCS B 330 066 432 Publication légale: Le Publicateur légal du 9 mars 1995. Oppositions : Me Attal, 2 avenue Hoche, 75008 Paris et pour la validité au fonds.

24/03/1995

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Paris B 313 334 856 RC 93-B 491 MARC LAURENT. Forme : S.A. Capital : 1 320 000 F. Adresse du siège social : 96 rue Saint-Lazare 75009 Paris. Administration : P.-D.G. : GROSMAN (Marc) Etablissement principal: Adresse : centre commercial Jaude 63000 Clermont-Ferrand Droit au bail acquis par achat au prix stipulé de 3 175 000 F. Date d'effet : 20 février 1995. Précédent propriétaire : ETABLISSEMENTS BERT. RCS Grenoble B 313 014 805 Publication légale: La Montagne du 22 février 1995. Oppositions : centre commercial Jaude, 63000 Clermont- Ferrand et pour la correspondance chez Me Deletraz, Cabinet Riondet, 13 rue de Verdun, B.P. 67, 38232 Meylan Cedex.

20/01/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Paris B 313 334 856 RC RC 78- B 5824 MARC LAURENT. Forme : S.A Nom commercial: Célio. Administration : président-directeur général : GROSMAN ( Marc) Administrateurs : GROSMAN ( Laurent) FRAIBERGER (Alain) BRANGER (Jean-Jacques) FIORENTINO ( Marc) CREDIT LYONNAIS INVESTISSEMENT CLINVEST APAX PARTNERS ET COMPAGNIE VENTURES. Commissaires aux comptes titulaires : MOITRIER (Gérard) B.D. A. Commissaires aux comptes suppléants NACCACHE (Claude) DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - PARIS AUDIT. Commentaires : modification survenue sur l' administration.

 

 

Company events history

 

Date

Description

24/08/2017

Bodacc C : Deposit accounts notice

24/08/2017

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

22/08/2017

Update Rating

22/08/2017

Update Limit

22/08/2017

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

08/08/2017

Amendment

12/05/2017

Payment incident closed

30/03/2017

Payment incident detected

01/03/2017

Payment incident closed

31/01/2017

New accounts available

21/12/2016

Bodacc C : Deposit accounts notice

20/12/2016

Update Limit

20/12/2016

Update Rating

20/12/2016

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

07/12/2016

Amendment

07/12/2016

Minutes of general meeting of shareholders

31/08/2016

Payment incident detected

02/07/2016

Payment incident closed

12/02/2016

Payment incident detected

31/01/2016

New accounts available

11/07/2015

Bodacc C : Deposit accounts notice

03/07/2015

Minutes of general meeting of shareholders

03/07/2015

Amendment

26/06/2015

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

29/05/2015

Payment incident closed

31/01/2015

New accounts available

05/12/2014

Payment incident closed

21/11/2014

Payment incident closed

10/10/2014

Payment incident detected

06/10/2014

Payment incident closed

23/09/2014

Payment incident detected

09/09/2014

Payment incident detected

04/09/2014

Payment incident detected

01/09/2014

Bodacc C : Deposit accounts notice

28/08/2014

Payment incident closed

28/08/2014

Payment incident detected

27/08/2014

Invalid balance sheet

26/08/2014

Payment incident detected

13/08/2014

Minutes of general meeting of shareholders

13/08/2014

Amendment

12/08/2014

Payment incident detected

08/08/2014

Payment incident detected

06/08/2014

Payment incident detected

22/07/2014

Payment incident detected

10/07/2014

Payment incident closed

24/06/2014

Payment incident detected

17/06/2014

Payment incident detected

13/06/2014

Payment incident detected

12/06/2014

Payment incident detected

16/05/2014

Payment incident detected

12/03/2014

Bodacc A : Sale and transfer

07/03/2014

Disengagement in other companies

07/03/2014

Bodacc A : Sale and transfer

05/03/2014

Bodacc A : Sale and transfer

02/03/2014

Bodacc A : Sale and transfer

27/02/2014

Bodacc A : Sale and transfer

26/02/2014

Bodacc A : Sale and transfer

25/02/2014

Bodacc A : Sale and transfer

23/02/2014

Bodacc A : Sale and transfer

08/02/2014

Disengagement in other companies

29/01/2014

Other modification of Establishment

29/01/2014

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer

29/01/2014

Formation of Establishment

16/01/2014

Bodacc A : Sale and transfer

02/01/2014

Other modification of Establishment

02/01/2014

Formation of Establishment

18/12/2013

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer

01/12/2013

Modification to Establishment Address or Identifier

24/10/2013

Payment incident detected

14/10/2013

Update Limit

11/09/2013

Amendment

02/09/2013

Bodacc C : Deposit accounts notice

28/08/2013

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

28/05/2013

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

28/02/2013

Payment incident closed

31/01/2013

New accounts available

09/01/2013

Bodacc A : Sale and transfer

21/11/2012

Bodacc A : Sale and transfer

13/11/2012

Bodacc A : Sale and transfer

11/11/2012

Bodacc B: Various editing or changing

02/11/2012

Minutes of general meeting of shareholders

02/11/2012

Amendment

11/10/2012

Payment incident detected

17/09/2012

Bodacc C : Deposit accounts notice

07/09/2012

Bodacc A : Sale and transfer

01/09/2012

Formation of Establishment

10/08/2012

Bodacc A : Sale and transfer

02/08/2012

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

02/07/2012

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

29/06/2012

Legal Gazette: Appointment of the social representative

12/06/2012

Bodacc A : Sale and transfer

10/05/2012

Minutes of general meeting of shareholders

10/05/2012

Merger

10/05/2012

Declaration of conformity

10/05/2012

Updated articles of association

04/05/2012

Payment incident closed

03/05/2012

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

13/02/2012

Changes to the Board of Directors

13/02/2012

Minutes of general meeting of shareholders

31/01/2012

New accounts available

24/01/2012

Other modification of Establishment

23/01/2012

Other modification of Establishment

23/01/2012

Formation of Establishment

30/12/2011

Bodacc A : Sale and transfer

20/12/2011

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

20/12/2011

Bodacc C : Deposit accounts notice

14/12/2011

Merger

01/12/2011

Modification to Establishment Address or Identifier

23/11/2011

Amendment

01/11/2011

Modification to Establishment Address or Identifier

01/10/2011

Formation of Establishment

01/08/2011

Modification to Establishment Address or Identifier

27/05/2011

Bodacc A : Sale and transfer

29/04/2011

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

10/03/2011

Payment incident detected

09/03/2011

Bodacc A : Sale and transfer

01/02/2011

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

31/01/2011

New accounts available

17/12/2010

Payment incident detected

13/12/2010

Formation of Establishment

03/12/2010

New subsidiarie(s) detected

19/11/2010

Bodacc B: Various editing or changing

09/11/2010

Minutes of general meeting of shareholders

09/11/2010

New chairman (CEO, CoB)

03/11/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

07/09/2010

Bodacc C : Deposit accounts notice

28/07/2010

Minutes of general meeting of shareholders

28/07/2010

Amendment

31/01/2010

New accounts available

01/12/2009

Closure of Establishment

09/11/2009

Modification to Establishment Address or Identifier

29/10/2009

Bodacc B: Various editing or changing

23/10/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

22/10/2009

Bodacc B: Various editing or changing

20/10/2009

Minutes of general meeting of shareholders

20/10/2009

Changes to the Board of Directors

20/10/2009

Amendment

13/10/2009

Amendment

13/10/2009

Updated articles of association

13/10/2009

Capital increase

01/10/2009

Other modification of Establishment

18/08/2009

Bodacc A : Sale and transfer

27/05/2009

Update of Company Workforce

27/05/2009

Other modification of Establishment

24/05/2009

Other modification of Establishment

24/05/2009

Formation of Establishment

31/01/2009

New accounts available

06/01/2009

New Bodacc B ads detected

06/01/2009

Bodacc B: Various editing or changing

23/12/2008

Amendment

23/12/2008

Appointment/resignation of company officers

23/12/2008

Changes to the Board of Directors

23/12/2008

Minutes of general meeting of shareholders

23/12/2008

New chairman (CEO, CoB)

23/12/2008

Private document

01/12/2008

Formation of Establishment

20/10/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

01/10/2008

Formation of Establishment

30/09/2008

Other modification of Establishment

24/09/2008

Minutes of Board meeting

24/09/2008

Formation of Establishment

24/09/2008

Changes to the Board of Directors

24/09/2008

Appointment/resignation of company officers

24/09/2008

Changes to the Board of Directors

24/09/2008

Private document

24/09/2008

Amendment

31/07/2008

Formation of Establishment

20/06/2008

Bodacc B: Various editing or changing

20/06/2008

New Bodacc B ads detected

10/06/2008

Updated articles of association

10/06/2008

Updated articles of association

10/06/2008

Other modification of Establishment

10/06/2008

Minutes of Board meeting

10/06/2008

Minutes of Board meeting

10/06/2008

Changes to the Board of Directors

10/06/2008

Capital increase

10/06/2008

Capital increase

10/06/2008

Appointment/resignation of company officers

10/06/2008

Amendment

10/06/2008

Private document

28/05/2008

Other modification of Establishment

05/05/2008

Updated articles of association

05/05/2008

Private document

05/05/2008

Minutes of general meeting of shareholders

05/05/2008

Change to corporate purpose

05/05/2008

Change to corporate purpose

05/05/2008

Updated articles of association

05/05/2008

Amendment

22/04/2008

Other modification of Establishment

01/04/2008

Formation of Establishment

04/02/2008

Collection of preferential rights activated for this company

31/01/2008

New accounts available

17/01/2008

Formation of Establishment

28/12/2007

Private document

28/12/2007

Updated articles of association

28/12/2007

Other modification of Establishment

28/12/2007

Minutes of general meeting of shareholders

28/12/2007

Minutes of general meeting of shareholders

28/12/2007

Declaration of conformity

28/12/2007

Declaration of conformity

28/12/2007

Updated articles of association

05/12/2007

Audit or Management Report

01/12/2007

Formation of Establishment

30/11/2007

Private document

30/11/2007

Audit or Management Report

30/11/2007

Audit or Management Report

06/11/2007

Private document

06/11/2007

Planned merger

06/11/2007

Merger

10/10/2007

Application and court order

10/10/2007

Amendment

10/10/2007

Application and court order

01/10/2007

Modification to Establishment Address or Identifier

06/07/2007

Declaration of conformity

06/07/2007

Minutes of general meeting of shareholders

06/07/2007

Private document

25/06/2007

Formation of Establishment

15/06/2007

Declaration of conformity

15/06/2007

Declaration of conformity

15/06/2007

Minutes of general meeting of shareholders

15/06/2007

Minutes of general meeting of shareholders

15/06/2007

Private document

15/06/2007

Updated articles of association

15/06/2007

Updated articles of association

15/06/2007

Other modification of Establishment

30/05/2007

Formation of Establishment

30/05/2007

Other modification of Establishment

29/05/2007

Appointment/resignation of company officers

29/05/2007

Audit or Management Report

29/05/2007

Audit or Management Report

29/05/2007

Minutes of general meeting of shareholders

29/05/2007

Minutes of general meeting of shareholders

29/05/2007

New company name

29/05/2007

New legal form – new category

29/05/2007

New legal form – no new category

29/05/2007

Other modification of Establishment (error correction)

29/05/2007

Private document

29/05/2007

Update of Company Acronym

29/05/2007

Updated articles of association

29/05/2007

Updated articles of association

15/05/2007

Private document

15/05/2007

Audit or Management Report

15/05/2007

Merger

15/05/2007

Audit or Management Report

27/04/2007

Merger

27/04/2007

Private document

27/04/2007

Planned merger

04/04/2007

Application and court order

04/04/2007

Amendment

04/04/2007

Application and court order

03/04/2007

Update of Company Legal Form

03/04/2007

Modification to Company Identifier

03/04/2007

Update of Company Name

31/01/2007

New consolidated accounts available

31/01/2007

New accounts available

27/11/2006

Minutes of general meeting of shareholders

27/11/2006

Minutes of general meeting of shareholders

27/11/2006

Appointment/resignation of company officers

27/11/2006

Private document

27/11/2006

Amendment

27/11/2006

Appointment/resignation of company officers

22/11/2006

Minutes of general meeting of shareholders

22/11/2006

Minutes of general meeting of shareholders

22/11/2006

Appointment/resignation of company officers

22/11/2006

Appointment/resignation of company officers

22/11/2006

Private document

27/02/2006

Minutes of general meeting of shareholders

27/02/2006

Appointment/resignation of company officers

27/02/2006

Amendment

27/02/2006

Private document

15/02/2006

Private document

15/02/2006

Planned merger

15/02/2006

Minutes of general meeting of shareholders

15/02/2006

Merger

15/02/2006

Declaration of conformity

15/02/2006

Amendment

15/02/2006

Updated articles of association

31/01/2006

New accounts available

08/12/2005

Private document

08/12/2005

Audit or Management Report

07/12/2005

Audit or Management Report

07/12/2005

Amendment

07/12/2005

Partial contribution

31/10/2005

Amendment

31/10/2005

Application and court order

21/10/2005

Private document

21/10/2005

Planned merger

21/10/2005

Merger

18/10/2005

Private document

18/10/2005

Appointment/resignation of company officers

18/10/2005

Amendment

18/10/2005

Minutes of general meeting of shareholders

05/08/2005

Updated articles of association

05/08/2005

Private document

05/08/2005

Appointment/resignation of company officers

05/08/2005

Declaration of conformity

05/08/2005

Minutes of general meeting of shareholders

05/08/2005

Amendment

03/08/2005

Amendment

03/08/2005

Minutes of general meeting of shareholders

03/08/2005

Private document

03/08/2005

Appointment/resignation of company officers

05/07/2005

Merger

05/07/2005

Audit or Management Report

05/07/2005

Private document

05/07/2005

Planned merger

25/04/2005

Application and court order

25/04/2005

Amendment

13/04/2005

Merger

13/03/2005

Planned merger

13/03/2005

Private document

31/01/2005

New accounts available

04/01/2005

Capital reduction

04/01/2005

Updated articles of association

04/01/2005

Amendment

04/01/2005

Minutes of general meeting of shareholders

04/01/2005

Private document

01/12/2004

Amendment

01/12/2004

Declaration of conformity

01/12/2004

Merger

01/12/2004

Minutes of Board meeting

01/12/2004

Minutes of general meeting of shareholders

01/12/2004

Planned merger

01/12/2004

Private document

01/12/2004

Updated articles of association

26/11/2004

Updated articles of association

26/11/2004

Private document

26/11/2004

Amendment

26/11/2004

Appointment/resignation of company officers

26/11/2004

Changes to the Board of Directors

26/11/2004

Minutes of general meeting of shareholders

26/11/2004

New chairman (CEO, CoB)

18/11/2004

Minutes of general meeting of shareholders

18/11/2004

Private document

18/11/2004

Capital reduction

08/11/2004

Audit or Management Report

08/11/2004

Merger

08/11/2004

Private document

06/10/2004

Application and court order

06/10/2004

Amendment

30/09/2004

Planned merger

30/09/2004

Merger

30/09/2004

Private document

08/06/2004

Updated articles of association

08/06/2004

Amendment

08/06/2004

Articles of association

08/06/2004

Minutes of general meeting of shareholders

16/04/2004

Appointment/resignation of company officers

16/04/2004

Minutes of general meeting of shareholders

16/04/2004

Private document

16/04/2004

Amendment

31/01/2004

New accounts available

01/01/2004

Updated articles of association

01/01/2004

Private document

01/01/2004

Minutes of general meeting of shareholders

01/01/2004

Appointment/resignation of company officers

17/11/2003

Minutes of general meeting of shareholders

17/11/2003

Change to the administration of a public limited company

17/11/2003

Private document

17/11/2003

Updated articles of association

17/11/2003

New auditor

17/11/2003

Appointment/resignation of company officers

17/11/2003

Amendment

08/08/2003

Application and court order

07/08/2003

Extension of term

07/08/2003

Application and court order

23/07/2003

Application and court order

23/07/2003

Amendment

20/06/2003

Amendment

20/06/2003

Updated articles of association

20/06/2003

Private document

20/06/2003

Appointment/resignation of company officers

20/06/2003

Changes to the Board of Directors

20/06/2003

Minutes of Board meeting

20/06/2003

Minutes of general meeting of shareholders

20/06/2003

New auditor

05/06/2003

Merger

05/06/2003

Private document

05/06/2003

Planned merger

30/05/2003

Updated articles of association

30/05/2003

Registration after transfer

30/05/2003

Private document

30/05/2003

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

30/05/2003

Minutes of Board meeting

30/05/2003

Amendment

31/01/2003

New accounts available

26/06/2002

Amendment

26/06/2002

Appointment/resignation of company officers

26/06/2002

Private document

26/06/2002

Minutes of Board meeting

26/06/2002

Minutes of general meeting of shareholders

26/06/2002

Changes to the Board of Directors

11/10/2001

Amendment

11/10/2001

Capital increase

11/10/2001

Minutes of general meeting of shareholders

11/10/2001

Private document

07/09/2001

Merger

07/09/2001

Updated articles of association

07/09/2001

Amendment

07/09/2001

Declaration of conformity

07/09/2001

Minutes of general meeting of shareholders

07/09/2001

Minutes of Board meeting

07/09/2001

Private document

13/08/2001

Minutes of Board meeting

13/08/2001

Private document

13/08/2001

Minutes of general meeting of shareholders

13/08/2001

Declaration of conformity

31/07/2001

Private document

31/07/2001

Minutes of general meeting of shareholders

31/07/2001

Conversion of equity to euro

31/07/2001

Capital increase

31/07/2001

Amendment

31/07/2001

Updated articles of association

18/06/2001

Amendment

18/06/2001

Application and court order

18/06/2001

Appointment/resignation of company officers

08/06/2001

Planned merger

08/06/2001

Private document

11/01/2001

Amendment

11/01/2001

Appointment/resignation of company officers

11/01/2001

Changes to the Board of Directors

11/01/2001

Minutes of general meeting of shareholders

11/01/2001

Private document

18/03/2000

Modification to Establishment Address or Identifier

08/03/1999

Amendment

08/03/1999

Appointment/resignation of company officers

08/03/1999

Private document

08/03/1999

Minutes of general meeting of shareholders

08/03/1999

Changes to the Board of Directors

10/08/1998

Minutes of general meeting of shareholders

10/08/1998

New chairman (CEO, CoB)

10/08/1998

Private document

10/08/1998

Updated articles of association

10/08/1998

Amendment

10/08/1998

Appointment/resignation of company officers

10/08/1998

Change to corporate purpose

10/08/1998

Changes to the Board of Directors

10/08/1998

Minutes of Board meeting

14/04/1998

Minutes of general meeting of shareholders

14/04/1998

Private document

14/04/1998

Appointment/resignation of company officers

14/04/1998

Changes to the Board of Directors

26/11/1997

Amendment

26/11/1997

Updated articles of association

26/11/1997

Private document

26/11/1997

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

26/11/1997

Minutes of Board meeting

04/09/1997

Minutes of general meeting of shareholders

04/09/1997

Changes to the Board of Directors

04/09/1997

Appointment/resignation of company officers

04/09/1997

Amendment

04/09/1997

Private document

10/03/1997

Amendment

10/03/1997

Appointment/resignation of company officers

10/03/1997

Capital increase

10/03/1997

Changes to the Board of Directors

10/03/1997

Minutes of Board meeting

10/03/1997

Private document

10/03/1997

Updated articles of association

02/02/1996

Amendment

02/02/1996

Appointment/resignation of company officers

03/01/1995

New auditor

03/01/1995

Minutes of general meeting of shareholders

03/01/1995

Amendment

16/12/1993

Amendment

16/12/1993

Audit or Management Report

04/11/1993

Updated articles of association

04/11/1993

Minutes of Board meeting

04/11/1993

Fund deposit certificate

04/11/1993

Declaration of conformity

04/11/1993

Capital increase

04/11/1993

Amendment

04/11/1993

Minutes of general meeting of shareholders

21/10/1993

Amendment

21/10/1993

Audit or Management Report

27/08/1993

Changes to the Board of Directors

27/08/1993

Appointment/resignation of company officers

27/08/1993

Amendment

27/08/1993

Minutes of general meeting of shareholders

29/07/1993

Planned merger

29/07/1993

Amendment

29/07/1993

Private document

08/07/1993

Amendment

08/07/1993

Capital increase

08/07/1993

Fund deposit certificate

08/07/1993

Minutes of general meeting of shareholders

08/07/1993

Updated articles of association

08/07/1993

Declaration of conformity

28/06/1993

Application and court order

22/06/1993

Application and court order

23/07/1992

Minutes of general meeting of shareholders

23/07/1992

New auditor

23/07/1992

Amendment

23/03/1992

Amendment

23/03/1992

Appointment/resignation of company officers

23/03/1992

Changes to the Board of Directors

23/03/1992

Minutes of general meeting of shareholders

 

 

Establishment events history

 

Date

Description

05/05/2017

Update of phone numbers

26/03/2017

Update of phone numbers

22/01/2017

Update of phone numbers

20/11/2016

Update of phone numbers

01/07/2016

Modification of Head office

22/02/2014

Update of phone numbers

29/01/2014

Modification of Head office

02/01/2014

Modification of Head office

05/09/2013

Update of phone numbers

12/01/2013

Update of phone numbers

01/09/2012

Modification of Head office

23/01/2012

Modification of Head office

01/11/2011

Modification of Head office

01/10/2011

Modification of Head office

13/12/2010

Modification of Head office

19/10/2010

Update of phone numbers

01/12/2009

Modification of Head office

09/11/2009

Modification of Head office

01/10/2009

Modification of Head office

27/05/2009

Update of Establishment Workforce

24/05/2009

Modification of Head office

01/12/2008

Modification of Head office

01/10/2008

Modification of Head office

30/09/2008

Modification of Head office

24/09/2008

Modification of Head office

31/07/2008

Modification of Head office

10/07/2008

Update of phone numbers

10/06/2008

Modification of Head office

28/05/2008

Modification of Head office

22/04/2008

Modification of Head office

01/04/2008

Modification of Head office

17/01/2008

Modification of Head office

11/12/2007

Update of phone numbers

01/12/2007

Modification of Head office

01/10/2007

Modification of Head office Identification

25/06/2007

Modification of Head office

15/06/2007

Update of phone numbers

30/05/2007

Modification of Head office

29/05/2007

Modification of Head office

03/04/2007

Modification of Head office

18/03/2000

Modification of Head office

 

 

Synthesized Accounts

 

Annual Accounts

31/01/2017

31/01/2016

31/01/2015

Account period (month)

12

12

12

Account Type

Normal

Normal

Normal

Date of capture

16/08/2017

19/12/2016

25/06/2015

Activity Code

4771Z

4771Z

4771Z

Employees

2668

2827

73

 

Active account

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

SECTOR MEDIAN 2017

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

190,345,489

-3.8%

197,826,556

-5.2%

208,777,069

83,800

227042.6%

 Intangible assets

136,124,367

-2.2%

139,204,638

-1.2%

140,898,537

44,210

307804.0%

 Tangible assets

37,482,572

-9.4%

41,389,601

-18.3%

50,649,253

10,702

350155.3%

 Financial assets

16,738,549

-2.9%

17,232,315

0.0%

17,229,279

1,477

1133180.2%

Net current assets

223,048,950

40.2%

159,053,180

7.6%

147,878,564

103,999

214372.2%

 Stocks

63,210,121

39.2%

45,398,932

-5.4%

47,993,350

45,088

140094.3%

 Advanced payments

120,627

-78.8%

569,589

54.7%

368,113

0

0%

 Receivables

83,478,624

-20.7%

105,213,689

12.5%

93,506,738

10,543

791729.5%

 Securities and cash

76,239,578

868.6%

7,870,970

31.0%

6,010,363

17,649

431889.0%

 Prepaid expenses

-

-

-

-

-

641

-

Accounts of regularization

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total Assets

413,394,439

15.8%

356,879,736

0.1%

356,655,634

210,004

196750.7%

 

Passive Account

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

SECTOR MEDIAN 2017

Shareholders' equity

41,235,878

-40.5%

69,282,957

-34.2%

105,303,974

65,774

62593.3%

Share capital

8,153,904

0%

8,153,904

0%

8,153,904

8,000

101823.8%

Other capital resources

0

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

3,616,776

-44.2%

6,476,895

18.4%

5,471,527

0

0%

Liabilities

368,541,785

31.1%

281,119,884

14.3%

245,880,132

117,119

314574.3%

 Financial liabilities

218,651,002

57.4%

138,887,879

14.6%

121,211,183

40,738

536631.5%

 Advanced payments received

0

0%

189,629

-97.0%

6,326,278

0

0%

 Trade account payables

97,664,551

14.2%

85,490,633

18.6%

72,075,277

25,820

378151.6%

 Tax and social liabilities

43,657,749

-9.1%

48,043,002

21.7%

39,489,950

16,876

258597.3%

 Other debts and fixed assets liabilities

8,218,593

3.0%

7,976,202

31.8%

6,053,108

2,910

282325.9%

Account regularization

349,890

-34.3%

532,539

-26.5%

724,336

0

0%

Total liabilities

413,394,439

15.8%

356,879,736

0.1%

356,655,634

210,003

196752.2%

 

Results

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

SECTOR MEDIAN 2017

Sales of Goods

610,891,888

-2.1%

623,785,351

3.8%

600,903,854

251,719

242588.0%

Net turnover

594,565,570

-0.6%

597,981,064

3.9%

575,789,202

246,354

241246.5%

 of which net export turnover

0

0%

0

0%

0

0

0%

Operating charges

595,164,853

0.0%

595,377,915

3.8%

573,705,943

244,745

243077.5%

Operating profit/loss

15,727,034

-44.6%

28,407,436

4.4%

27,197,911

5,862

268187.9%

Financial income

66,892

-45.4%

122,453

-28.6%

171,399

0

0%

Financial charges

2,784,276

27.6%

2,181,636

-22.7%

2,823,836

971

286790.9%

Financial profit/loss

-2,717,384

-32.0%

-2,059,183

22.4%

-2,652,438

-662

-410381.0%

Pretax net operating income

13,009,651

-50.6%

26,348,253

7.3%

24,545,473

5,019

259133.9%

Extraordinary income

8,587,636

98.5%

4,327,269

434.6%

809,390

0

0%

Extraordinary charges

7,505,957

-37.2%

11,947,851

263.6%

3,285,654

56

13403394.6%

Extraordinary profit/loss

1,081,679

114.2%

-7,620,582

-207.7%

-2,476,263

0

0%

Net result

9,639,246

-15.5%

11,407,408

0.2%

11,382,063

5,068

190098.2%

 

Accounts - Active

Normal Account

31/01/2017

31/01/2016

31/01/2015

Months

12

12

12

 

Grand Total - Active Accounts (I to VI)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Grand Total (I to VI)

Net

413,394,439

15.8%

356,879,736

0.1%

356,655,634

Gross

CO

586,694,352

9.2%

537,261,380

1.7%

528,245,218

Amortisation

1A

173,299,913

-3.9%

180,381,644

5.1%

171,589,584

 

Non declared distributed capital (I)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

Gross

AA

0

0%

0

0%

0

 

Active fixed asset (II)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Total Active fixed asset (II)

Net

190,345,489

-3.8%

197,826,556

-5.2%

208,777,069

Gross

BJ

353,149,471

-4.1%

368,242,672

-0.7%

370,671,407

Amortisation

BK

162,803,982

-4.5%

170,416,116

5.3%

161,894,338

 

Intangible fixed assets

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R&D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CQ

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

1,487,004

-4.5%

1,557,191

55.1%

1,004,120

Gross

AF

2,117,342

-76.1%

8,872,492

783.6%

1,004,120

Amortisation

AG

630,337

-91.4%

7,315,300

0%

0

Goodwill

Net

134,556,950

-2.2%

137,635,366

-1.3%

139,439,277

Gross

AH

143,242,694

-1.3%

145,113,806

-1.6%

147,398,502

Amortisation

AI

8,685,744

16.1%

7,478,440

-6.0%

7,959,225

Other intangible fixed assets

Net

80,413

565.6%

12,081

-97.3%

455,140

Gross

AJ

80,413

565.6%

12,081

-99.8%

7,980,142

Amortisation

AK

0

0%

0

0%

7,525,002

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible asset

Net

136,124,367

-2.2%

139,204,638

-1.2%

140,898,537

 

Tangible fixed assets

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Lands

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AN

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AO

0

0%

0

0%

0

Buildings

Net

51,908

-6.5%

55,500

-99.9%

40,970,775

Gross

AP

109,360

0%

109,360

-99.9%

150,958,874

Amortisation

AQ

57,452

6.7%

53,860

-100.0%

109,988,099

Plant

Net

127,302

-53.0%

270,756

-75.1%

1,085,460

Gross

AR

2,431,787

-4.3%

2,540,174

-28.3%

3,544,398

Amortisation

AS

2,304,485

1.5%

2,269,417

-7.7%

2,458,938

Other tangible fixed assets

Net

35,907,063

-8.6%

39,268,027

414.2%

7,636,244

Gross

AT

186,915,336

-2.9%

192,449,435

363.9%

41,481,627

Amortisation

AU

151,008,273

-1.4%

153,181,408

352.6%

33,845,383

Fixed assets in construction

Net

1,396,299

-6.1%

1,486,303

244.7%

431,213

Gross

AV

1,396,299

-6.1%

1,486,303

244.7%

431,213

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

0

0%

309,015

-41.2%

525,561

Gross

AX

0

0%

309,015

-41.2%

525,561

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

Sub Total Tangible asset

Net

37,482,572

-9.4%

41,389,601

-18.3%

50,649,253

 

Financial assets

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

1,001,250

0%

1,001,250

0%

1,001,250

Gross

CU

1,118,941

0%

1,118,941

0%

1,118,941

Amortisation

CV

117,691

0%

117,691

0%

117,691

Inter-company receivables

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BC

0

0%

0

0%

0

Other investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BD

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BE

0

0%

0

0%

0

Loans

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BF

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BG

0

0%

0

0%

0

Other financial assets

Net

15,737,299

-3.0%

16,231,065

0.0%

16,228,029

Gross

BH

15,737,299

-3.0%

16,231,065

0.0%

16,228,029

Amortisation

BI

0

0%

0

0%

0

Sub Total Financial assets

Net

16,738,549

-2.9%

17,232,315

0.0%

17,229,279

 

Current Assets (III)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Total Current Assets

Net

223,048,950

40.2%

159,053,180

7.6%

147,878,564

Gross

CJ

233,544,881

38.2%

169,018,708

7.3%

157,573,809

Amortisation

CK

10,495,931

5.3%

9,965,528

2.8%

9,695,245

 

Stocks

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Raw materials

Net

37,222

0%

0

0%

0

Gross

BL

37,222

0%

0

0%

0

Amortisation

BM

0

0%

0

0%

0

Work in progress (goods)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BN

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

0

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BR

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BS

0

0%

0

0%

0

Goods for resale

Net

63,172,899

39.2%

45,398,932

-5.4%

47,993,350

Gross

BT

65,198,364

37.6%

47,378,650

-4.4%

49,534,094

Amortisation

BU

2,025,465

2.3%

1,979,718

28.5%

1,540,744

Sub Total Stocks

Net

63,210,121

39.2%

45,398,932

-5.4%

47,993,350

 

Advance payments to suppliers

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Advance payments to suppliers

Net

120,627

-78.8%

569,589

54.7%

368,113

Gross

BV

120,627

-78.8%

569,589

54.7%

368,113

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0

 

Debtors

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Trade accounts receivable

Net

31,220,839

-9.8%

34,610,977

-25.4%

46,411,687

Gross

BX

32,557,981

-8.7%

35,661,119

-25.2%

47,681,149

Amortisation

BY

1,337,142

27.3%

1,050,142

-17.3%

1,269,462

Other debtors

Net

40,753,018

-30.7%

58,808,138

66.1%

35,398,601

Gross

BZ

47,886,342

-27.2%

65,743,806

55.5%

42,283,640

Amortisation

CA

7,133,324

2.8%

6,935,668

0.7%

6,885,039

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

Sub Total debtors

Net

71,973,857

-23.0%

93,419,115

14.2%

81,810,288

Divers

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CD

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CE

0

0%

0

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

76,239,578

868.6%

7,870,970

31.0%

6,010,363

Gross

CF

76,239,578

868.6%

7,870,970

31.0%

6,010,363

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

Sub Total Divers

Net

76,239,578

868.6%

7,870,970

31.0%

6,010,363

 

Prepaid expenses

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Prepaid expenses

Net

11,504,767

-2.5%

11,794,574

0.8%

11,696,450

Gross

CH

11,504,767

-2.5%

11,794,574

0.8%

11,696,450

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts (IV to VI)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Expenses of loan issue to be spread

CW3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Currency differential gain

CN3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

 

References

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

Accounts - Passive

Grand Total - Passive Accounts (I to V)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Grand Total (I to V)

EE

413,394,439

15.8%

356,879,736

0.1%

356,655,634

 

Shareholder Equity (I)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Total shareholders' equity (Total I)

DL

41,235,878

-40.5%

69,282,957

-34.2%

105,303,974

Equity and shareholders' equity

DA

8,153,904

0%

8,153,904

0%

8,153,904

Issue and merger premiums

DB

13,244,334

0%

13,244,334

0%

13,244,334

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

Legal reserve

DD

883,930

0%

883,930

0%

883,930

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

Other reserves

DG

9,314,464

-73.8%

35,593,381

-50.2%

71,503,962

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

0%

0

0%

0

Profits or losses brought forward

DH

0

0%

0

0%

0

Profit or loss for the period

DI

9,639,246

-15.5%

11,407,408

0.2%

11,382,063

Investment grants

DJ

0

0%

0

0%

0

Special tax-allowable reserves

DK

0

0%

0

0%

135,782

 

Other capital resources (II)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

 

Provisions for risks and charges (III)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

3,616,776

-44.2%

6,476,895

18.4%

5,471,527

Risk provisions

DP

1,959,913

58.6%

1,235,877

-77.4%

5,471,527

Reserves for charges

DQ

1,656,863

-68.4%

5,241,018

0%

0

 

Liabilities (IV)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Total Liabilities (Total IV)

EC

368,541,785

31.1%

281,119,884

14.3%

245,880,132

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

Bank loans and liabilities

DU

153,450

29988.2%

510

-99.9%

413,315

Sundry loans and financial liabilities

DV

218,497,552

57.3%

138,887,369

15.0%

120,797,868

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

Advance payments received for current orders

DW

0

0%

189,629

-97.0%

6,326,278

Trade accounts payables

DX

97,664,551

14.2%

85,490,633

18.6%

72,075,277

Tax and social security liabilities

DY

43,657,749

-9.1%

48,043,002

21.7%

39,489,950

Fixed asset liabilities

DZ

339,925

-23.1%

441,921

14.9%

384,571

Other debts

EA

7,878,668

4.6%

7,534,281

32.9%

5,668,537

 

Translation loss (V)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Translation loss (Total V)

ED

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Deferred income

EB

349,890

-34.3%

532,539

-26.5%

724,336

 

References

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

0

0%

0

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

413,315

 

Result account

1 - Operating result (I-II)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Operating result (Total I-II)

GG

15,727,034

-44.6%

28,407,436

4.4%

27,197,911

 

2 - Financial result (V-VI)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Financial result (Total V-VI)

GV

-2,717,384

-32.0%

-2,059,183

22.4%

-2,652,438

 

3 - Pre-tax net operating income result (I to VI)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

13,009,651

-50.6%

26,348,253

7.3%

24,545,473

 

4 - Extraordinary result (VII-VIII)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

1,081,679

114.2%

-7,620,582

-207.7%

-2,476,263

 

Profit or loss

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Profit or loss

HN

9,639,246

-15.5%

11,407,408

0.2%

11,382,063

 

Total Income (I+III+V+VII)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Total Income (Total I+III+V+VII)

HL

619,546,416

-1.4%

628,235,073

4.4%

601,884,643

 

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

609,907,167

-1.1%

616,827,665

4.5%

590,502,581

 

Operating income (I)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Total operating income (Total I)

FR

610,891,888

-2.1%

623,785,351

3.8%

600,903,854

 

Operating income (details)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Sale of goods for resale

FC

543,712,958

-1.0%

549,421,976

6.0%

518,112,821

France

FA

543,712,958

-1.0%

549,421,976

6.0%

518,112,821

Export

FB

0

0%

0

0%

0

Sale of goods produced

FF

0

0%

0

0%

0

France

FD

0

0%

0

0%

0

Export

FE

0

0%

0

0%

0

Sale of services

FI

50,852,612

4.7%

48,559,088

-15.8%

57,676,381

France

FG

50,852,612

4.7%

48,559,088

-15.8%

57,676,381

Export

FH

0

0%

0

0%

0

Net turnover

FL

594,565,570

-0.6%

597,981,064

3.9%

575,789,202

France

FJ

594,565,570

-0.6%

597,981,064

3.9%

575,789,202

Export

FK

0

0%

0

0%

0

Stocked production

FM

0

0%

0

0%

0

Self-constructed assets

FN

0

0%

0

0%

0

Operating grants

FO

0

0%

0

0%

0

Release of reserves and provisions

FP

12,519,625

9.2%

11,466,407

5.4%

10,883,070

Other income

FQ

3,806,692

-73.5%

14,337,880

0.7%

14,231,581

 

Operating charges (II)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Total operating charges (Total II)

GF

595,164,853

0.0%

595,377,915

3.8%

573,705,943

 

Exploitation charges

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Purchase of goods for resale

FS

343,284,691

8.1%

317,608,903

10.4%

287,678,491

Change in stocks of goods for resale

FT

-17,840,089

-989.0%

2,006,865

176.2%

726,648

Purchase of raw materials

FU

0

0%

0

0%

0

Change in stocks of raw materials

FV

0

0%

0

0%

0

Other external purchases and charges

FW

138,556,858

5.1%

131,894,978

-6.8%

141,555,514

Tax, duty and similar payments

FX

12,445,716

-4.6%

13,047,940

1.3%

12,884,439

Payroll

FY

68,868,970

-8.8%

75,479,542

2.2%

73,885,704

Social security costs

FZ

29,174,740

-12.5%

33,356,624

19.1%

28,013,464

 

Depreciation

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Depreciation of fixed assets

GA

15,319,915

0.4%

15,264,346

-13.1%

17,575,351

Amortisation of fixed assets

GB

2,733,821

-26.8%

3,735,841

-48.7%

7,284,895

Depreciation/amortisation of current assets

GC

683,989

-8.6%

748,107

-64.5%

2,107,199

Provisions for risks and charges

GD

1,529,193

5.6%

1,448,422

19.4%

1,213,147

 

Other charges

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Other charges

GE

407,049

-48.2%

786,347

0.7%

781,092

 

Operating charges (III-IV)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

 

Financial income (V)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Total financial income (Total V)

GP

66,892

-45.4%

122,453

-28.6%

171,399

Share financial income

GJ

0

0%

0

0%

0

Other investment income & capitalised receivables

GK

0

0%

0

0%

0

Other interest and similar income

GL

56,031

-50.3%

112,724

497.0%

18,882

Released provisions and transferred charges

GM

0

0%

0

0%

152,067

Exchange gains

GN

10,861

11.6%

9,729

2062.0%

450

Net income from disposal of investment securities

GO

0

0%

0

0%

0

 

Financial charge (VI)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Total financial charge (Total VI)

GU

2,784,276

27.6%

2,181,636

-22.7%

2,823,836

Financial reserves and provisions

GQ

197,656

290.4%

50,629

-6.4%

54,074

Interest and similar charges

GR

2,582,294

21.4%

2,127,960

-23.1%

2,766,896

Exchange losses

GS

4,326

42.0%

3,047

6.3%

2,866

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary income (VII)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Total extraordinary income (Total VII)

HD

8,587,636

98.5%

4,327,269

434.6%

809,390

Extraordinary operating income

HA

953,654

0%

0

0%

0

Extraordinary income from capital transactions

HB

4,453,001

120.5%

2,019,842

1507.2%

125,677

Released provisions and transferred charges

HC

3,180,981

37.9%

2,307,427

237.5%

683,713

 

Extraordinary charges (VIII)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

7,505,957

-37.2%

11,947,851

263.6%

3,285,654

Extraordinary operating charges

HE

4,288,852

32067.2%

13,333

-58.4%

32,029

Extraordinary charges from capital transactions

HF

2,098,949

-74.4%

8,195,487

687.2%

1,041,079

Extraordinary reserves and provisions

HG

1,118,156

-70.1%

3,739,031

69.0%

2,212,545

 

Employee profit sharing (IX)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

2,380,997

-18.1%

2,907,208

6.4%

2,731,194

 

Tax on profits (X)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Tax on profits (Total X)

HK

2,071,084

-53.1%

4,413,055

-44.5%

7,955,953

 

References

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

Of which transferred charges

A1

0

0%

0

0%

0

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

0

0%

0

 

Other incomes tax return forms

Fixed Assets

Grand Total Fixed Assets (I to IV)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

OK1

1,027,338

-99.3%

151,575,327

0%

0

Decreasess by transfers

OK2

26,172,006

144.7%

10,695,733

0%

0

Gross value at the end of period

OL

353,149,472

-4.1%

368,242,670

0%

0

 

Research and development Charge (Total I)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

CO1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

CO2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

DO

0

0%

0

0%

0

 

Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Gross value at begin of period

KD

153,998,379

-1.9%

156,908,325

0%

0

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

324,673

-72.6%

1,182,816

0%

0

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

0%

26,815

0%

0

Decreasess by transfers

LV2

8,882,603

118.5%

4,065,947

0%

0

Gross value at the end of period

LW

145,440,449

-5.6%

153,998,379

0%

0

 

Tangible fixed assets (Total III)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Gross value at begin of period

LN

196,894,286

0.2%

196,416,113

0%

0

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

11,579,285

-92.7%

158,656,472

0%

0

Decreasess by budget item transfer

NG1

1,027,338

-99.3%

151,548,512

0%

0

Decreasess by transfers

NG2

16,593,451

150.3%

6,629,786

0%

0

Gross value at the end of period

NH

190,852,782

-3.1%

196,894,287

0%

0

 

Financial assets (Total IV)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Gross value at begin of period

LQ

17,350,006

0.0%

17,346,970

0%

0

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

202,185

6559.6%

3,036

0%

0

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NJ2

695,952

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

NK

16,856,239

-2.8%

17,350,006

0%

0

 

Reserve for depreciation

Situation and movement of reserve for depreciation - Grand total (I-II-III)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Reserve for depreciation value at begin of period

ON

0

0%

0

0%

0

Increases

OP

0

0%

0

0%

0

Decreasess

OQ

0

0%

0

0%

0

Reserve for depreciation value at the end of period

OR

0

0%

0

0%

0

 

Research and development charge (Total I)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0

 

Other intangible assets (Total II)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

7,315,300

-2.8%

7,525,002

0%

0

Increases

PF

9,114,187

1172.3%

716,376

0%

0

Decreasess

PG

7,113,406

668.1%

926,077

0%

0

Decreasess by budget item transfer

PH

9,316,081

27.4%

7,315,301

0%

0

 

Total fixed assets amotisation (Total III)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

155,065,938

2.4%

151,359,840

0%

0

Increases

QV

14,227,899

-46.1%

26,406,546

0%

0

Decreases

QW

15,923,628

158.1%

6,170,679

0%

0

Decreasess by budget item transfer

QX

153,370,209

-10.6%

171,595,707

0%

0

 

Movements during period affecting charge allocated over several period

Deferred charges and debt issuance costs

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0

 

Premium refund of obligations

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Net value at begin of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

 

Provisions included in balance sheet

Grand Total (I-II-III)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Value at begining of period

7C

24,477,302

4.2%

23,497,161

8.8%

21,589,406

Increases

UB

5,934,402

-39.0%

9,722,030

-24.5%

12,871,861

Decreases

UC

8,159,134

-5.4%

8,624,198

-22.2%

11,081,795

Value at the end of period

UD

22,252,570

-9.5%

24,594,993

5.2%

23,379,472

 

Includes Total allocations

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Operating

UE

4,947,003

-49.1%

9,722,030

-24.5%

12,871,861

Financial

UG

197,656

0%

0

0%

0

Exceptional

UJ

789,744

0%

0

0%

0

 

Includes Total Withdrawal

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Operating

UF

4,978,152

-42.3%

8,624,198

-22.2%

11,081,795

Financial

UH

0

0%

0

0%

0

Exceptional

UK

3,180,981

0%

0

0%

0

 

Total regulated provisions (Total I)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Value at begining of period

3Z

0

0%

135,782

-82.2%

761,910

Increases

TS

0

0%

0

0%

0

Decreases

TT

0

0%

135,782

-78.3%

626,128

Value at the end of period

TU

0

0%

0

0%

135,782

 

Total risk and charge provisions (Total II)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Value at begining of period

5Z

6,476,895

18.4%

5,471,527

20.8%

4,528,990

Increases

TV

2,318,937

-55.3%

5,187,451

51.4%

3,425,693

Decreases

TW

5,179,056

23.8%

4,182,083

68.4%

2,483,154

Value at the end of period

TX

3,616,776

-44.2%

6,476,895

18.4%

5,471,529

 

Total Provision for depreciation (Total III)

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Value at begining of period

7B

18,000,407

0.6%

17,889,852

9.8%

16,298,506

Increases

TY

3,615,465

-20.3%

4,534,579

-52.0%

9,446,168

Decreases

TZ

2,980,078

-30.8%

4,306,333

-46.0%

7,972,513

Value at the end of period

UA

18,635,794

2.9%

18,118,098

1.9%

17,772,161

 

State deadlines claims and debts at the end of period

State claims

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Gross value

VT

107,686,389

-16.8%

129,430,565

9.8%

117,889,267

1 year at most

VU

84,247,681

-20.2%

105,508,550

12.3%

93,946,804

More than one year

VV

23,438,708

-2.0%

23,922,015

-0.1%

23,942,463

 

State of loans

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Claims related to holdings (gross)

UL

0

0%

0

0%

0

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0

0%

0

0%

0

Loans (gross)

UP

0

0%

0

0%

0

Loans (1 year at most)

UR

0

0%

0

0%

0

Other financial assets (gross)

UT

15,737,299

-3.0%

16,231,065

0.0%

16,228,029

Other financial assets (1 year at most)

UV

0

0%

0

0%

0

 

Receivables statement of assets

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Customers doubtful or disputed

VA

13,395

-33.0%

19,992

-37.1%

31,806

Other claims customer

UX

32,544,586

-8.7%

35,641,127

-25.2%

47,649,343

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts

UY

63,587

-18.3%

77,872

-15.6%

92,218

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

5,424

0%

0

Income taxes

VM

379,630

-46.3%

707,400

-44.7%

1,279,537

Value added tax

VB

6,787,459

23.6%

5,490,479

37.6%

3,990,360

Other taxes and payments assimilated

VN

587,237

15.8%

507,083

0%

0

State and other public - Miscellaneous

VP

0

0%

0

0%

0

Group and Associates

VC

7,133,325

-71.4%

24,970,603

116.8%

11,516,608

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

32,935,103

-3.1%

33,984,946

33.8%

25,404,916

 

Prepaid

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Prepaid

VS

11,504,767

-2.5%

11,794,574

0.8%

11,696,450

 

State Debt

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Total debt (gross)

VY

368,541,785

31.2%

280,930,253

17.3%

239,553,854

1 year at most

VZ2

368,155,150

31.3%

280,424,145

17.4%

238,836,432

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

376,217

-20.1%

470,691

-34.4%

717,422

More than 5 years

VZ4

10,417

-70.6%

35,417

0%

0

 

Details

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

153,450

29988.2%

510

-99.9%

413,315

1 year at most

VG2

153,450

29988.2%

510

-99.9%

413,315

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VH2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

0%

0

0%

0

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

140,745,863

1.3%

138,887,369

15.0%

120,797,868

1 year at most

8A2

140,591,859

1.3%

138,731,151

15.0%

120,664,363

More than 1 year and 5 years at most

8A3

154,004

-1.4%

156,218

17.0%

133,505

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

97,664,551

14.2%

85,490,633

18.6%

72,075,277

1 year at most

8B2

97,664,551

14.2%

85,490,633

18.6%

72,075,277

More than 1 year and 5 years at most

8B3

97,664,551

14.2%

85,490,633

18.6%

72,075,277

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

0

0%

19,583,529

27.2%

15,397,464

1 year at most

8C2

0

0%

19,583,529

27.2%

15,397,464

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

12,596,947

7.7%

11,692,965

-14.5%

13,674,012

1 year at most

8D2

12,596,947

7.7%

11,692,965

-14.5%

13,674,012

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (Gross)

VW1

9,784,302

-8.3%

10,670,178

83.5%

5,815,149

1 year at most

VW2

9,784,302

-8.3%

10,670,178

83.5%

5,815,149

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

21,276,500

249.0%

6,096,329

32.4%

4,603,325

1 year at most

VQ2

21,276,500

249.0%

6,096,329

32.4%

4,603,325

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

339,925

-23.1%

441,921

14.9%

384,571

1 year at most

8J2

339,925

-23.1%

441,921

14.9%

384,571

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

77,751,689

0%

0

0%

0

1 year at most

VI2

77,751,689

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

V14

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

7,878,668

4.6%

7,534,281

32.9%

5,668,537

1 year at most

8K2

7,878,668

4.6%

7,534,281

32.9%

5,668,537

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

349,890

-34.3%

532,539

-26.5%

724,336

1 year at most

8L2

117,260

-35.8%

182,648

30.1%

140,419

More than 1 year and 5 years at most

8L3

222,213

-29.3%

314,473

-46.1%

583,917

 

References

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Loans made during the period

VJ

140,000,000

1.4%

138,000,000

15.0%

120,000,000

Debt repaid during the period

VK

138,000

-99.9%

120,000,000

0%

120,000,000

 

Table allocation results and other information

Dividends distributed

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0

 

Commitments

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0

 

Other charges Externes

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0

 

Taxes and Fees

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0

 

VAT

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0

 

Average number of employees

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Average number of employees

YP

2,668

-5.6%

2,827

3772.6%

73

 

Groups and Shareholders

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

Groups and Shareholders

ZR

0

-

-

-

-

 

Ratios

Synthetic financial performance indicators

31/01/2017

31/01/2016

31/01/2015

Score

Situation

Score

Situation

Score

Situation

HideAFDCC 2

-

-

-

-

-

-

Description

The AFDCC 2 score uses sectors of activity and company sizes for companies with a turnover of 150 000 to 75 million euros. This calculation allows a classification of the companies in three levels:

-

Healthy: the higher the score value is, the more the company is healthy.

-

Undetermined: it’s impossible to determine the situation.

-

Fragility/Failure: the lower the score value is, the more the company is in danger.

The status are completed which “+/-“ signs.

HideConan & Holder

0.07

50%

0.07

40%

0.10

30%

Description

The Conan and Holder (1979) is a recommended method for industrial companies with a turnover of 150 000 to 75 million euros. It is based only on a balance sheet. This calculation allows a classification of the most perilous situation (Score lower than 0.002) to the healthiest situation (score greater than 0.16):

-

Healthy situation: companies which maintain or develop their activity level.

-

Situation to monitor: companies which has to follow remedial measures or find a new strategy.

-

Perilous situation: companies which could have important cash difficulties and have a failure risk.

HideAltman

-

-

-

-

-

-

Description

The Altman score is a method based only on a complete balance sheet, this calculation allows a classification of the companies in three levels:

-

Good shape: companies which have a low risk (with a score value higher than 2.99).

-

Warning signs: companies which should be approached with caution and with a high risk in the next two years for bankruptcy (with a score value between 2.99 and 1.81).

-

Bankruptcy: companies which are in immediate risk (with a score value lower than 1.81).

 

Structure and Liquidity

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

SECTOR MEDIAN 2017

Fixed Asset Financing

1.21

15.2%

1.05

-0.9%

1.06

1.33

-9.0%

Global Debt

223 days

32.0%

169 days

9.7%

154 days

158 days

41.1%

Working Capital Fund overall net

44 days

340.0%

10 days

-28.6%

14 days

56 days

-21.4%

Financial independence

18.86 %

-62.2%

49.88 %

-42.6%

86.88 %

92.40 %

-79.6%

Solvability

9.97 %

-48.6%

19.41 %

-34.3%

29.53 %

35.04 %

-71.5%

Capacity debt futures

26,872.52 %

-99.8%

13,584,893.53 %

53220.3%

25,477.90 %

743.68 %

3513.5%

Coverage of current assets by net working capital overall

32.95 %

207.9%

10.70 %

-31.5%

15.63 %

42.31 %

-22.1%

General Liquidity

0.23

-39.5%

0.38

-2.6%

0.39

0.11

109.1%

Restricted Liquidity

0.44

10.0%

0.40

-4.8%

0.42

0.41

7.3%

 

Management or rotation

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

SECTOR MEDIAN 2017

Need background in operating working capital

-28 days

12.5%

-32 days

-128.6%

-14 days

20 days

-240.0%

Treasury

46 days

820.0%

5 days

25.0%

4 days

5 days

820.0%

Inventory turnover of goods

72 days

35.8%

53 days

-14.5%

62 days

160 days

-55.0%

Average length of credit granted to customers

20 days

-4.8%

21 days

-30.0%

30 days

0 days

0%

Average length of credit obtained suppliers

76 days

11.8%

68 days

13.3%

60 days

50 days

52.0%

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

-

-

-

-

-

0 days

-

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

-

-

-

-

-

504 days

-

Rotation tangible assets

311.53 %

2.6%

303.71 %

-

-

441.74 %

-29.5%

 

Profitability of the business

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

SECTOR MEDIAN 2017

Margin trading

36.71 %

-4.5%

38.43 %

-3.7%

39.89 %

42.74 %

-14.1%

Profitability of the business

3.38 %

-17.8%

4.11 %

-23.7%

5.39 %

4.72 %

-28.4%

Net profit

1.62 %

-15.2%

1.91 %

-3.5%

1.98 %

2.09 %

-22.5%

Growth rate of turnover (excluding VAT)

-0.57 %

-114.8%

3.85 %

0%

0.00 %

-1.91 %

70.2%

Rates integration

21.96 %

-10.3%

24.49 %

-3.3%

25.33 %

25.18 %

-12.8%

Rate leasing furniture

0.00 %

0%

0.00 %

0%

0.00 %

0.00 %

0%

Work Factor

75.09 %

1.0%

74.31 %

6.3%

69.88 %

72.39 %

3.7%

Weight interests

0.47 %

30.6%

0.36 %

-26.5%

0.49 %

0.39 %

20.5%

 

Return on capital

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

SECTOR MEDIAN 2017

Cash flow from the overall profitability

3.11 %

-41.4%

5.31 %

7.9%

4.92 %

4.51 %

-31.0%

Rates of economic profitability

8.00 %

-33.3%

12.00 %

-14.3%

14.00 %

9.00 %

-11.1%

Financial profitability

41,235,878.00 %

-40.5%

69,282,957.00 %

-34.2%

105,303,974.00 %

20,530.50 %

200751.8%

Return on investment

4.78 %

-26.8%

6.53 %

4.1%

6.27 %

5.61 %

-14.8%

 

Management intermediate balances

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

SECTOR MEDIAN 2017

Turnover

594,565,570

-0.6%

597,981,064

3.9%

575,789,202

246,354

241246.5%

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

SECTOR MEDIAN 2017

Sales of goods

543,712,958

-1.0%

549,421,976

6.0%

518,112,821

-

- Purchase of goods

343,284,691

8.1%

317,608,903

10.4%

287,678,491

-

+/- Stock of goods variation

-17,840,089

-989.0%

2,006,865

176.2%

726,648

-

Trading margin

218,268,356 €

-5.0%

229,806,208 €

0.0%

229,707,682 €

102,798 €

212228.5%

36.71 % CA

-4.5%

38.43 % CA

-3.7%

39.89 % CA

43.01 % CA

-14.6%

 

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

SECTOR MEDIAN 2017

Sale of goods produced

50,852,612

4.7%

48,559,088

-15.8%

57,676,381

-

+/- Stocked production

0

0%

0

0%

0

-

+ Self-constructed assets

0

0%

0

0%

0

-

Period production

50,852,612 €

4.7%

48,559,088 €

-15.8%

57,676,381 €

0 €

0%

8.55 % CA

5.3%

8.12 % CA

-19.0%

10.02 % CA

0.00 % CA

0%

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

SECTOR MEDIAN 2017

Trading margin

218,268,356

-5.0%

229,806,208

0.0%

229,707,682

102,798

212228.5%

+ Period Production

50,852,612

4.7%

48,559,088

-15.8%

57,676,381

0

0%

- Purchase of raw materials

0

0%

0

0%

0

-

+/- Change in stocks of raw materiels

0

0%

0

0%

0

-

- Other external purchases and charges

138,556,858

5.1%

131,894,978

-6.8%

141,555,514

-

Added value

130,564,110 €

-10.9%

146,470,318 €

0.4%

145,828,549 €

67,594 €

193059.3%

21.96 % CA

-10.3%

24.49 % CA

-3.3%

25.33 % CA

25.19 % CA

-12.8%

 

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

SECTOR MEDIAN 2017

Added value

130,564,110 €

-10.9%

146,470,318 €

0.4%

145,828,549 €

67,594 €

193059.3%

+ Operating grants

0

0%

0

0%

0

-

- Tax, duty and similar payments

12,445,716

-4.6%

13,047,940

1.3%

12,884,439

-

- Personal charges

98,043,710

-9.9%

108,836,166

6.8%

101,899,168

-

Gross operating surplus

20,074,684 €

-18.3%

24,586,212 €

-20.8%

31,044,942 €

10,681 €

187847.6%

3.38 % CA

-17.8%

4.11 % CA

-23.7%

5.39 % CA

4.72 % CA

-28.4%

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

SECTOR MEDIAN 2017

Gross operating surplus

20,074,684 €

-18.3%

24,586,212 €

-20.8%

31,044,942 €

10,681 €

187847.6%

+ Release of reserves and provisions

12,519,625

9.2%

11,466,407

5.4%

10,883,070

-

+ Other operating income

3,806,692

-73.5%

14,337,880

0.7%

14,231,581

-

- Depreciation/ Amortisation

20,266,918

-4.4%

21,196,716

-24.8%

28,180,592

-

- Other charges

407,049

-48.2%

786,347

0.7%

781,092

-

Operating result

15,727,034 €

-44.6%

28,407,436 €

4.4%

27,197,909 €

5,864 €

268119.2%

2.65 % CA

-44.2%

4.75 % CA

0.6%

4.72 % CA

2.58 % CA

2.7%

 

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

SECTOR MEDIAN 2017

Operating result

15,727,034 €

-44.6%

28,407,436 €

4.4%

27,197,909 €

5,864 €

268119.2%

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

-

+ Financial income

66,892

-45.4%

122,453

-28.6%

171,399

-

- Financial charges

2,784,276

27.6%

2,181,636

-22.7%

2,823,836

-

Pre-tax result

13,009,650 €

-50.6%

26,348,253 €

7.3%

24,545,472 €

5,025 €

258798.5%

2.19 % CA

-50.3%

4.41 % CA

3.5%

4.26 % CA

2.18 % CA

0.5%

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

SECTOR MEDIAN 2017

Extraordinary income

8,587,636

98.5%

4,327,269

434.6%

809,390

0

0%

- Extraordinary charges

7,505,957

-37.2%

11,947,851

263.6%

3,285,654

-

Extraordinary result

1,081,679 €

114.2%

-7,620,582 €

-207.7%

-2,476,264 €

0 €

0%

0.18 % CA

114.2%

-1.27 % CA

-195.3%

-0.43 % CA

0.00 % CA

0%

 

31/01/2017

Variation

31/01/2016

Variation

31/01/2015

SECTOR MEDIAN 2017

Pre-tax result

13,009,650 €

-50.6%

26,348,253 €

7.3%

24,545,472 €

5,025 €

258798.5%

Extraordinary result

1,081,679 €

114.2%

-7,620,582 €

-207.7%

-2,476,264 €

0 €

0%

- Employee profit sharing

2,380,997

-18.1%

2,907,208

6.4%

2,731,194

-

- Tax on profits

2,071,084

-53.1%

4,413,055

-44.5%

7,955,953

-

Net result

9,639,248 €

-15.5%

11,407,408 €

0.2%

11,382,061 €

5,069 €

190060.7%

1.62 % CA

-15.2%

1.91 % CA

-3.5%

1.98 % CA

2.10 % CA

-22.9%

 

Synthesized Accounts

31/01/2007

Account period (month)

12

Account Type

Consolidated

Activity Code

4771Z

 

Active account

31/01/2007

Capital not called

0

Total fixed assets

220,144,000

 Intangible assets

134,028,000

 Tangible assets

65,785,000

 Financial assets

12,668,000

Net current assets

106,637,000

 Stocks

42,800,000

 Advanced payments

470,000

 Receivables

24,661,000

 Securities and cash

38,706,000

Accounts of regularization

1,002,000

Total Assets

327,783,000

 

Passive account

31/01/2007

Shareholders' equity

110,620,000

Share capital

7,978,000

Other capital resources

-1,068,000

Risk Provisions

12,771,000

Liabilities

205,460,000

 Financial liabilities

90,354,000

 Advanced payments received

0

 Trade account payables

80,882,000

 Tax and social liabilities

31,226,000

 Other debts and fixed assets liabilities

2,998,000

Account regularization

0

Total liabilities

327,783,000

 

Result

31/01/2007

Sales of Goods

470,038,000

Net turnover

457,710,000

 of which net export turnover

90,566,000

Operating charges

410,829,000

Operating profit/loss

59,209,000

Financial income

6,202,000

Financial charges

8,051,000

Financial profit/loss

-1,849,000

Pretax net operating income

57,360,000

Extraordinary income

18,127,000

Extraordinary charges

23,196,000

Extraordinary profit/loss

-5,069,000

 

Consolidation

31/01/2007

Net result before amortisation of goodwill

37,986,000

Goodwill amortisation allocation

0

Net result of equity affiliates companies

0

Net result of integrated companies

0

Group result (consolidated net result)

37,986,000

Share of minority interest (Result except group)

-240,000

Net result - group share (part of parent company)

38,226,000

 

Accounts - Active

Normal Account

31/01/2007

Account period (month)

12

 

Grand Total - Active Accounts (I to VI)

31/01/2007

Grand Total (I to VI)

Net

327,783,000

Gross

CO

469,413,000

Amortisation

1A

141,630,000

 

Capital subscribed not called (I)

31/01/2007

Capital suscribed not called (I)

AA3

0

 

Active fixed asset (II)

31/01/2007

Total Active fixed asset (II)

Net

220,144,000

Gross

BJ

351,691,000

Amortisation

BK

131,547,000

 

Intangible fixed assets

31/01/2007

Start-up cost

Net

0

Gross

AB

0

Amortisation

AC

0

R&D expenses

Net

0

Gross

CX

0

Amortisation

CQ

0

Distributorships, patents

Net

1,006,000

Gross

AF

1,127,000

Amortisation

AG

121,000

Goodwill

Net

130,912,000

Gross

AH

148,081,000

Amortisation

AI

17,169,000

Other intangible fixed assets

Net

2,110,000

Gross

AJ

5,111,000

Amortisation

AK

3,001,000

Pre-payments and downpayments

Net

0

Gross

AL

0

Amortisation

AM

0

Sub Total Intangible asset

Net

134,028,000

 

Tangible fixed assets

31/01/2007

Acquisition difference

Net

7,664,000

Gross

A11

12,974,000

Amortisation

A12

12,974,000

Goodwill

Net

0

Gross

A21

0

Amortisation

A22

0

Difference from the first consolidation

Net

0

Gross

A31

0

Amortisation

A32

0

Lands

Net

733,000

Gross

AN

733,000

Amortisation

AO

0

Buildings

Net

34,545,000

Gross

AP

102,086,000

Amortisation

AQ

67,541,000

Plant

Net

647,000

Gross

AR

4,662,000

Amortisation

AS

4,015,000

Other tangible fixed assets

Net

28,418,000

Gross

AT

62,580,000

Amortisation

AU

34,162,000

Fixed assets in construction

Net

0

Gross

AV

0

Amortisation

AW

0

Advances and payments on account

Net

1,442,000

Gross

AX

1,442,000

Amortisation

AY

0

Sub Total Tangible asset

Net

73,449,000

 

Financial assets

31/01/2007

Associates at equity

Net

0

Gross

CS

0

Amortisation

CT

0

Other participations

Net

377,000

Gross

CU

377,000

Amortisation

CV

0

Inter-company receivables

Net

0

Gross

BB

0

Amortisation

BC

0

Other investment securities

Net

0

Gross

BD

0

Amortisation

BE

0

Loans

Net

0

Gross

BF

0

Amortisation

BG

0

Other financial assets

Net

12,291,000

Gross

BH

12,518,000

Amortisation

BI

227,000

Other financial assets

Net

0

Gross

A41

0

Amortisation

A42

0

Sub Total Financial assets

Net

12,668,000

 

Current Assets (III)

31/01/2007

Total Assets

Net

106,637,000

Gross

CJ

116,720,000

Amortisation

CK

10,083,000

 

Stocks

31/01/2007

Raw materials

Net

0

Gross

BL

0

Amortisation

BM

0

Work in progress (goods)

Net

42,800,000

Gross

BN

51,896,000

Amortisation

BO

9,096,000

Work in progress (services)

Net

0

Gross

BP

0

Amortisation

BQ

0

Semi-finished and finished products

Net

0

Gross

BR

0

Amortisation

BS

0

Goods for resale

Net

0

Gross

BT

0

Amortisation

BU

0

Sub Total Stocks

Net

42,800,000

 

Advance payments to suppliers

31/01/2007

Advance payments to suppliers

Net

470,000

Gross

BV

470,000

Amortisation

BW

0

 

Debtors

31/01/2007

Trade accounts receivable

Net

8,031,000

Gross

BX

8,982,000

Amortisation

BY

951,000

Other debtors

Net

5,760,000

Gross

BZ

5,796,000

Amortisation

CA

36,000

Capital subscribed and called up

Net

0

Gross

CB

0

Amortisation

CC

0

Sub Total debtors

Net

13,791,000

 

Divers

31/01/2007

Investment securities

Net

20,731,000

Gross

CD

20,731,000

Amortisation

CE

0

Cash and cash equivalents

Net

17,975,000

Gross

CF

17,975,000

Amortisation

CG

0

Sub Total Divers

Net

0

 

Prepaid expenses

31/01/2007

Prepaid expenses

Net

10,870,000

Gross

CH

10,870,000

Amortisation

CI

0

 

Equalization accounts (IV to VI)

31/01/2007

Expenses of loan issue to be spread

CW3

1,002,000

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

Currency differential gain

CN3

0

 

References

31/01/2007

Due within one year

CP

0

Due after one year

CR

0

 

Accounts - Passive

Grand Total - Passive Accounts (I to IV)

31/01/2007

Grand Total (I to IV)

EE

327,783,000

 

Shareholder Equity (I)

31/01/2007

Total shareholders' equity (Total I)

DL

110,620,000

Equity and shareholders' equity

DA

7,978,000

Issue and merger premiums

DB

10,022,000

Revaluation differentials

DC

0

Of which equity differential

EK

0

Legal reserve

DD

0

Statutory or contractual reserve

DE

0

Special regulated reserves

DF

0

Other reserves

DG

54,394,000

Profits or losses brought forward

DH

0

Conversion differences

P1

0

Net result - group part

P2

38,226,000

Investment grants

DJ

0

Special tax-allowable reserves

DK

0

 

Other capital resources (II)

31/01/2007

Total other capital resources (Total II)

DO

-1,068,000

Income from participating securities

DM

0

Conditional loans

DN

0

Others

P3

-1,068,000

 

Provisions for risks and charges (III)

31/01/2007

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

12,771,000

Conversion differences

P4

0

In reserves

P5

-240,000

In results

P6

240,000

Total III

P7

0

Delayed tax

P8

4,626,000

Acquisition differences

P9

0

Risk provisions

DP

4,925,000

Reserves for charges

DQ

3,220,000

 

Liabilities (IV)

31/01/2007

Total Liabilities (Total IV)

EC

205,460,000

Convertible debentures

DS

0

Other debentures

DT

0

Bank loans and liabilities

DU

81,207,000

Sundry loans and financial liabilities

DV

9,147,000

Of which participating loans

EI

0

Advance payments received for current orders

DW

0

Trade accounts payables

DX

80,882,000

Tax and social security liabilities

DY

31,226,000

Fixed asset liabilities

DZ

546,000

Other debts

EA

2,452,000

 

Translation loss (V)

31/01/2007

Translation loss (Total V)

ED

0

 

Equalization accounts

31/01/2007

Deferred income

EB

0

 

References

31/01/2007

Of which tax-allowable reserve

EF

0

Deferred income and liabilities

EG

0

Of which current bank facilities

EH

0

 

Result account

1- Operating result (I-II)

31/01/2007

Operating result (Total I-II)

GG

59,209,000

 

2 - Financial result (V - VI)

31/01/2007

Financial result (Total V-VI)

GV

-1,849,000

 

3 - Pre-tax net operating income result (I - VI)

31/01/2007

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

57,360,000

 

4 - Extraordinary result (VII-VIII)

31/01/2007

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

-5,069,000

 

Consolidation

31/01/2007

Delayed tax

R1

-2,118,000

Net result before amortisation of acquisition differences

R2

37,986,000

Endowment to amortisation of acquisition differences

R3

0

Net result of companies set in equivalence

R4

0

Net result of integrated companies

R5

0

Group result (consolidated net result)

R6

37,986,000

Cross-reference : equipment leasing

R7

-240,000

Cross-reference : property leasing

R8

38,226,000

 

Operating income (I)

31/01/2007

Total operating income (Total I)

FR

470,038,000

 

Operating income (details)

31/01/2007

Sale of goods for resale

FC

0

France

FA

0

Export

FB

0

Sale of goods produced

FF

457,710,000

France

FD

367,145,000

Export

FE

90,566,000

Sale of services

FI

0

France

FG

0

Export

FH

0

Net turnover

FL

457,710,000

France

FJ

367,145,000

Export

FK

90,566,000

Stocked production

FM

-1,014,000

Self-constructed assets

FN

0

Operating grants

FO

122,000

Release of reserves and provisions

FP

10,890,000

Other income

FQ

2,330,000

 

Operating charges (II)

31/01/2007

Total operating charges (Total II)

GF

410,829,000

 

Exploitation charges

31/01/2007

Purchase of goods for resale

FS

0

Change in stocks of goods for resale

FT

0

Purchase of raw materials

FU

172,360,000

Change in stocks of raw materials

FV

0

Other external purchases and charges

FW

106,482,000

Tax, duty and similar payments

FX

7,580,000

Payroll

FY

67,439,000

Social security costs

FZ

21,975,000

 

Depreciation

31/01/2007

Depreciation of fixed assets

GA

20,833,000

Amortisation of fixed assets

GB

0

Depreciation/amortisation of current assets

GC

8,350,000

Provisions for risks and charges

GD

3,121,000

 

Other charges

31/01/2007

Other charges

GE

2,689,000

 

Operating charges (III-IV)

31/01/2007

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

 

Financial income (V)

31/01/2007

Total financial income (Total V)

GP

6,202,000

Share financial income

GJ

0

Other investment income & capitalised receivables

GK

854,000

Other interest and similar income

GL

822,000

Released provisions and transferred charges

GM

115,000

Exchange gains

GN

4,411,000

Net income from disposal of investment securities

GO

0

 

Financial charge (VI)

31/01/2007

Total financial charge (Total VI)

GU

8,051,000

Financial reserves and provisions

GQ

304,000

Interest and similar charges

GR

4,476,000

Exchange losses

GS

3,271,000

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

 

Extraordinary income (VII)

31/01/2007

Total extraordinary income (Total VII)

HD

18,127,000

Extraordinary operating income

HA

6,251,000

Extraordinary income from capital transactions

HB

1,244,000

Released provisions and transferred charges

HC

10,632,000

 

Extraordinary charges (VIII)

31/01/2007

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

23,196,000

Extraordinary operating charges

HE

6,743,000

Extraordinary charges from capital transactions

HF

8,067,000

Extraordinary reserves and provisions

HG

8,386,000

 

Employee profit sharing (IX)

31/01/2007

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

0

 

Tax on profits (X)

31/01/2007

Tax on profits (Total X)

HK

16,423,000

 

References

31/01/2007

Of which equipment leases

HP

0

Of which property leases

HQ

0

 

 

Key Performance Indicators

 

Find below a comparison of the company based on the industry code (primary) with other companies from the same industry. The following analysis has been based on the industry code 4771Z - Retail sale of clothing in specialised stores.

Graphical analysis

Net TurnoverCompany ResultSector Average31/01/201731/01/201631/01/20150M250M500M750M

31/01/2017

31/01/2016

31/01/2015

Company Result

594,565,570 €

597,981,064 €

575,789,202 €

Sector Average

50,693,088 €

1,351,843 €

1,401,842 €

 

Net ProfitCompany ResultSector Average31/01/201731/01/201631/01/20150M5M10M15M

31/01/2017

31/01/2016

31/01/2015

Company Result

9,639,246 €

11,407,408 €

11,382,063 €

Sector Average

6,072 €

10,049 €

7,150 €

 

Net Export TurnoverCompany ResultSector Average31/01/201731/01/201631/01/20150k50k100k

31/01/2017

31/01/2016

31/01/2015

Company Result

0 €

0 €

0 €

Sector Average

74,871 €

91,257 €

92,561 €

 

Account TotalCompany ResultSector Average31/01/201731/01/201631/01/20150M200M400M600M

31/01/2017

31/01/2016

31/01/2015

Company Result

413,394,439 €

356,879,736 €

356,655,634 €

Sector Average

1,128,779 €

939,258 €

997,895 €

 

Shareholders EquityCompany ResultSector Average31/01/201731/01/201631/01/20150M50M100M150M

31/01/2017

31/01/2016

31/01/2015

Company Result

41,235,878 €

69,282,957 €

105,303,974 €

Sector Average

429,799 €

362,509 €

356,963 €

 

LiabilitiesCompany ResultSector Average31/01/201731/01/201631/01/20150M200M400M

31/01/2017

31/01/2016

31/01/2015

Company Result

368,541,785 €

281,119,884 €

245,880,132 €

Sector Average

689,710 €

564,550 €

626,309 €

 

Need background in operating working capitalCompany ResultSector Average31/01/201731/01/201631/01/2015-50050100

31/01/2017

31/01/2016

31/01/2015

Company Result

-28 €

-32 €

-14 €

Sector Average

67 €

53 €

47 €

 

Gross operating surplus (EBE)Company ResultSector Average31/01/201731/01/201631/01/20150M10M20M30M40M

31/01/2017

31/01/2016

31/01/2015

Company Result

20,074,684 €

24,586,212 €

31,044,942 €

Sector Average

11,449,452 €

63,132 €

69,429 €

 

 

 

 

 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

INR 65.04

UK Pound

1

INR 92.28

Euro

1

INR 80.62

Euro

1

INR 80.25

 

Note : Above are approximate rates obtained from sources believed to be correct

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

DIV

 

 

Report Prepared by :

TPT

 


 

RATING EXPLANATIONS

 

Credit Rating

 

Explanation

Rating Comments

A++

Minimum Risk

Business dealings permissible with minimum risk of default

A+

Low Risk

Business dealings permissible with low risk of default

A

Acceptable Risk

Business dealings permissible with moderate risk of default

B

Medium Risk

Business dealings permissible on a regular monitoring basis

C

Medium High Risk

Business dealings permissible preferably on secured basis

D

High Risk

Business dealing not recommended or on secured terms only

NB

New Business

No recommendation can be done due to business in infancy stage

NT

No Trace

No recommendation can be done as the business is not traceable

 

NB is stated where there is insufficient information to facilitate rating. However, it is not to be considered as unfavourable.

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors are as follows:

 

·         Financial condition covering various ratios

·         Company background and operations size

·         Promoters / Management background

·         Payment record

·         Litigation against the subject

·         Industry scenario / competitor analysis

·         Supplier / Customer / Banker review (wherever available)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.