MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

508693

Report Date :

11.05.2018

 

 

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

WILFRIED HEINZEL AKTIENGESELLSCHAFT

 

 

Registered Office :

Wagramerstraße 28-30, A-1223 Wien

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

31.12.2016

 

 

Date of Incorporation :

1991

 

 

Legal Form :

Joint Stock Company

 

 

Line of Business :

·         Wholesale of paper in bulk

·         Wholesale of chemical products

 

 

No. of Employees :

75 [2018]

 

 

RATING & COMMENTS

(Mira Inform has adopted New Rating mechanism w.e.f. 23rd January 2017)

 

MIRA’s Rating :

A

 

Credit Rating

Explanation

Rating Comments

A

Acceptable Risk

Business dealings permissible with moderate risk of default

 

Status :

Satisfactory

 

 

Payment Behaviour :

Slow but Correct

 

 

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List

 

Country Name

Previous Rating

(30.09.2017)

Current Rating

(31.12.2017)

Austria

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low Risk

 

A2

Moderately Low Risk

 

B1

Moderate Risk

 

B2

Moderately High Risk

 

C1

High Risk

 

C2

Very High Risk

 

D

 


 

AUSTRIA - ECONOMIC OVERVIEW

 

Austria, with its well-developed market economy, skilled labor force, and high standard of living, is closely tied to other EU economies, especially Germany's. Its economy features a large service sector, a relatively sound industrial sector, and a small, but highly developed agricultural sector.

Economic growth has been relatively weak in recent years, approaching 1% in 2015, but rising to 2.3% in 2017. Austria's 5.8% unemployment rate, while low by European standards, is at its highest rate since the end of World War II, driven by an increased number of refugees and EU migrants entering the labor market. Without extensive vocational training programs and generous early retirement, the unemployment rate would be even higher.

Although Austria's fiscal position compares favorably with other euro-zone countries, it faces several external risks, such as unexpectedly weak world economic growth threatening the export market, Austrian banks' continued exposure to Central and Eastern Europe, repercussions from the Hypo Alpe Adria bank collapse, political and economic uncertainties caused by the European sovereign debt crisis, the current refugee crisis, and continued unrest in Russia/Ukraine. The budget deficit stood at 1% of GDP in 2017 and public debt declined slightly to 81.7% of GDP in 2017 after reaching a post-war high of 84.6% in 2016.

 

Source : CIA

 


Company name and address

 

Wilfried Heinzel Aktiengesellschaft

 

Wagramerstraße 28-30

A-1223 Wien

 

 

Phone:

(0043) 1 26011

Fax:

(0043) 1 2636363

E-mail:

office@austria.heinzelsales.com

Internet:

http://www.heinzelsales.com

 

 

 

Activities

 

ÖNACE 46761 50% Wholesale of paper in bulk

ÖNACE 46750 50% Wholesale of chemical products

 

 

Financial data

 

Financial details can also be entered during the period, irrespective of the balance sheet date.

 

total turnover (total sales)

2017

EUR

398.940.000,00

(estimated)

total turnover (total sales)

2016

EUR

393.045.416,91

(exact)

total turnover (total sales)

2015

EUR

323.213.072,94

(exact)

total turnover (total sales)

2014

EUR

290.073.414,65

(exact)

total turnover (total sales)

2013

EUR

230.884.118,09

(exact)

 

turnover (sales) - group

2016

EUR

1.763.330.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2015

EUR

1.480.410.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2014

EUR

1.406.502.000,00

(exact)

turnover (sales) - group

2013

EUR

1.329.000.000,00

(approx.)

turnover (sales) - group

2012

EUR

1.037.000.000,00

(approx.)

 

total stock

2018

EUR

21.381.000,00

(approx.)

 

total investments

2016

EUR

694.807,58

(exact)

 

total company vehicles

2018

 

14

(approx.)

 

total employees

2018

 

75

(approx.)

 

 

General company information

 

Company name

Wilfried Heinzel Aktiengesellschaft

Year of incorporation

1991

Type of company

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles

Legal form

joint stock company since 1991-07-11

Trade names

Heinzel Pulp and Paper Group

Companies house number

FN 55340 h Wien since 1991-08-26

Import

Russia

USA

European Union

 

Export

world-wide

 

VAT number

ATU 15294802

number - Austrian National Bank

1630466

Last balance sheet:

2016

Banking connection

UniCredit Bank Austria AG

BLZ 12000

main bank connection

Raiffeisen Bank International AG

BLZ 31000

main bank connection

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

BLZ 20111

secondary banking connection

 

 

Locations

 

operational

A-1223 Wien, Wagramerstraße 28-30

registered headquarters, rented premises

 

0043 1 26011

office@austria.heinzelsales.com

operational

A-1223 Wien, Postfach 57

postbox

operational

A-1223 Wien, Wagramer Straße 28-30

registered office

former

A-1020 Wien, Engerthstraße 161-163

registered headquarters,

former

A-1010 Wien, Kärntner Ring 2

registered headquarters,

former

A-1020 Wien, Engerthstr. 161-163

registered office,

 

 

Private data

 

Surname

Date of birth

Address

Executive positions

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Gerhard Gessl

1957-07-30

A-1223 Wien

Wagramerstraße 28-30 (c/o)

joint signing clerk

2

Jürgen Nemeth

1973-08-07

A-2460 Bruck Leitha

Telering 21

joint signing clerk

0

Peter Schak

1961-06-20

A-1223 Wien

Wagramerstraße 28-30 (c/o)

joint signing clerk

0

Sandra Warmuth

1982-01-10

A-2483 Ebreichsdorf

Gutshofzeile 1

joint signing clerk

0

Mag. Dietmar Geigl

1973-08-23

A-2345 Brunn Gebirge

Feldstraße 19

member of the executive board

2

Mag. Sebastian Heinzel

1977-08-20

A-1040 Wien

Margarethenstraße 5

member of the executive board

13

Moncef Reisner

1956-07-23

A-1223 Wien

Wagramerstraße 28-30 (c/o)

member of the executive board

1

Dipl-Ing.Dr. Kurt Maier

1961-04-28

A-8047 Graz

Am Steinergrund 28

chairman of the supervisory board

29

Mag. Barbara Potisk Eibensteiner

1968-09-09

A-1030 Wien

Modecenterstraße 14

deputy chairman of the supervisory board

18

Nadja Blenk

1975-02-16

A-2011 Sierndorf

Zelkinggasse 29

member of the supervisory board

0

Mag. Helmut Limbeck

1968-01-18

A-7122 Gols

Sportplatzgasse 23

member of the supervisory board

12

Andrew Paul

1955-03-29

A-7201 Neudörfl

Straße III

member of the supervisory board, head of sales, head of marketing

9

Ulrike Ullrich Springer

1969-03-17

A-1210 Wien

Leopoldauerstraße 19

member of the supervisory board

0

 

 

Business unit manager

 

Surname

Date of birth

Address

Executive positions

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Karin Schnabl

 

A-1223 Wien

Wagramerstraße 28-30(c/o)

head of accounting

0

Sabine Irmler

1964-06-27

A-1223 Wien

Wagramerstraße 28-30(c/o)

head of personnel

0

 

 

Ownership structure and related companies

 

Company name

Address

Shareholdings in %

Since

Commercial register no.

Shares in this company are held by:

Heinzel Holding GmbH

A-4655 Vorchdorf

Einsiedlingerstraße 47

90 %

 

FN 96380 k

P & S BETEILIGUNGSGMBH

A-7201 Neudörfl

Straße III

10 %

2002-03-25

FN 220199 y

 

This company holds 100% of the shares in:

Heinzel Pulpsales GmbH

A-2371 Hinterbrühl

Gaadnerstraße 80

100 %

2009-09-11

FN 332630 m

 

Affiliated companies and further participations:

Heinzel, Bunzl Service GmbH

A-1220 Wien

Wagramerstraße 28-30

 

 

FN 242766 i

Europapier International AG

A-2371 Hinterbrühl

Gaadner Straße 80

 

 

FN 332815 i

Kraftwerk Katzling GmbH

A-8761 Pöls

Dr. Luigi Angelistraße 9

 

 

FN 405472 h

Kraftwerk Laakirchen GmbH

A-4663 Laakirchen

Schillerstraße 5

 

 

FN 405474 k

Laakirchen Papier AG

A-4663 Laakirchen

Schillerstraße 5

 

 

FN 171841 h

Zellstoff Pöls Aktiengesellschaft

A-8761 Pöls

Dr. Luigi Angelistraße 9

 

 

FN 200511 w

Heinzel Paper GmbH

A-2371 Hinterbrühl

Gaadnerstraße 80

 

 

FN 332306 k

Heinzel EMACS Beteiligungs AG

A-1223 Wien

Wagramerstraße 28-30

 

 

FN 252220 m

 

 

Financials

 

Balance Sheet (absolute) all amounts in EUR

 

 

2016-12-31

EDP programs

357.611,00

Franchises, patents, licences, trademarks and similar rights and advantages

3.436.153,00

Advanced payments

54.380,00

Sum intangible assets

3.848.144,00

 

Other operating and business equipment

479.411,00

Sum tangible assets

479.411,00

 

Shares on related firms

4.061.696,75

Other shareholdings

13.222,00

Other financial assets, values and securities of fixed assets

137.734,24

Sum financial assets

4.212.652,99

 

Sum fixed assets

8.540.207,99

 

Finished products

16.876.466,74

Advanced payments

4.504.824,10

Sum stock

21.381.290,84

 

Claims from delivered goods and performed services

66.485.611,81

Claims against companies with shareholding relationship

185.658,81

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

13.815.786,09

Other claims and assets

1.097.823,82

Sum claims

81.584.880,53

 

Cash on hand, cheques and bank deposits

4.234.880,32

Sum cash and bank

4.234.880,32

 

Sonstige Aktiva

236.701,00

Sum current assets

107.201.051,69

 

Deferred charges

12.000,13

Sum deferred charges

12.000,13

Assets

115.989.960,81

 

Subscribed/declared capital

1.825.000,00

Committed capital reserves

181.752,94

Legal reserves

747,06

Free reserves

3.988.755,88

Balance sheet profit/balance sheet loss

24.907.545,21

Thereof profit/loss carried forward

17.408.990,71

Sum equity capital

30.903.801,09

 

Reserves for severance pays

1.003.348,90

Reserves for pensions

137.734,44

Other reserves

3.705.254,46

Sum reserves

4.846.337,80

 

Liabilities against credit institutes

5.508.010,86

Received advanced payments for orders

1.269.345,56

Liabilities from delivered goods and performed services

51.942.550,43

Liabilities against related firms

20.028.866,32

Liabilities against firm with shareholding relationship

130.006,40

Other liabilities

1.361.042,35

Sum liabilities

80.239.821,92

 

Liabilities and shareholders'equity

115.989.960,81

Balance sheet sum

115.989.960,81

 

 

P / L Account (absolute) all amounts in EUR

 

 

2016-12-31

Gross sales

393.045.416,91

Total turnover or gross profit

393.045.416,91

 

Profits from retirement of fixed assets, except financial assets

28.188,00

Income from dissolution of reserves

16.280,44

Other operating profits

324.340,30

Other operating profits totally

368.808,74

 

Costs for obtained services

-24.766.406,20

Material costs

-347.552.133,93

Costs for obtained services totally

-372.318.540,13

 

Salaries

-6.060.157,14

Legal fringe benefits and other payments depending on salaries

-1.367.615,32

Personnel expenses totally

-7.427.772,46

 

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation

-2.764.931,07

Depreciation tangible assets / intangible assets totally

-2.764.931,07

 

Other operating costs

-7.422.364,84

Total costs

-7.422.364,84

 

Operating result totally

3.480.617,15

 

Profits from shareholdings

4.918.829,13

Income from other securities and loans of financial assets

34,27

Interest income, securties income and similar income

160.280,45

Interest and similar disbursements

-244.823,39

Financial profits totally

4.834.320,46

 

Results from usual business activity totally

8.314.937,61

 

Taxes on income and profits

-816.383,11

Taxes on income and profits totally

-816.383,11

 

Annual surplus/annual deficit totally

7.498.554,50

 

Annual profit/annual loss totally

7.498.554,50

 

Profit and loss carried forward from previous year

17.408.990,71

Transfer of profits totally

17.408.990,71

 

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account

24.907.545,21

 

 

Key ratios

 

 

2016

Cashflow II

10.263.485,57

Debt amortisation period in years

7,75

Bank indebtedness

4,75

Equity capital share in %

26,94

Social capital share

0,98

Fixed assets coverage in %

375,22

Net profit ratio

2,12

Capital turnover

3,39

Return on investment in %

7,38

Cashflow in % of operating performance

2,61

Cashflow I

11.079.868,68

Gross productivity

52,92

Net productivity

2,79

Operating performance

393.045.416,91

Inventories in % of operating performance

5,44

Gross profit

20.726.876,78

 

 

Commercial register

 

Source of data from commercial register: Republic of Austria represented by the Federal Ministry of Justice

 

firm (style)

1 Wilfried Heinzel Aktiengesellschaft

legal form

1 Aktiengesellschaft

registered office

1 politischer Gemeinde Wien

business adress

11 Wagramer Straße 28-30
1223 Wien

capital

18 EUR 1.825.000,00

reference date annual accounts

1 31.Dezember

annual accounts

50 zum 31.12.2016 eingereicht am 11.05.2017

consolidated accounts

18 zum 31.12.2000 eingereicht am 17.05.2001

power of representation

1 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder
durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten.
Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
selbständige Vertretungsbefugnis erteilen.

other provisions

47 Der Vorstand besteht aus einer Person, zwei, drei oder vier
Personen

 

board of directors

O    Moncef Reisner, geb. 23.07.1956
42    vertritt seit 01.04.2012 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
AJ    Mag. Dietmar Geigl, geb. 23.08.1973
35    vertritt seit 01.04.2010 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
AN    Mag. Sebastian Heinzel, geb. 20.08.1977
46    vertritt seit 16.02.2015 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

 

proxy

N    Gerhard Gessl, geb. 30.07.1957
2    vertritt seit 08.03.1994 gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied oder einem Gesamtprokuristen
Q    Peter Schak, geb. 20.06.1961
6    vertritt seit 20.12.1994 gemeinsam mit
einem Vorstandmitglied oder einem Gesamtprokuristen
AE    Jürgen Nemeth, geb. 07.08.1973
39    vertritt seit 28.06.2011 gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-
prokuristen
AR    Sandra Warmuth, geb. 10.01.1982
54    vertritt seit 12.04.2018 gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-
prokuristen

 

supervisory board

B    Andrew Paul, geb. 29.03.1955
51    Mitglied
51            AC    Mag. Helmut Limbeck, geb. 18.01.1968
38    Mitglied
38            AI    Ulrike Ullrich-Springer, geb. 17.03.1969
28    Mitglied
28            AL    Nadja Blenk, geb. 16.02.1975
32    Mitglied
32            AO    Dipl.Ing.Dr. Kurt Maier, geb. 28.04.1961
48    Vorsitzende/r
48            AQ    Mag. Barbara Potisk-Eibensteiner, geb. 09.09.1968
52    Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
52

 

general table


Handelsgericht Wien
1   eingetragen am 04.11.1993        Geschäftsfall 007 921 Fr 458/93 m
Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
2   eingetragen am 08.03.1994        Geschäftsfall 007 702 Fr 2383/94 t
Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.03.1994
3   eingetragen am 25.05.1994        Geschäftsfall 007 702 Fr 6352/94 d
Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.05.1994
4   eingetragen am 18.06.1994        Geschäftsfall 007 702 Fr 7436/94 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.06.1994
5   eingetragen am 23.08.1994        Geschäftsfall 007 702 Fr 11018/94 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.08.1994
6   eingetragen am 28.12.1994        Geschäftsfall 007 702 Fr 15509/94 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.12.1994
7   eingetragen am 07.11.1995        Geschäftsfall 007 702 Fr 11411/95 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.10.1995
8   eingetragen am 02.08.1996        Geschäftsfall 007 072 Fr 5426/96 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 31.07.1996
9   eingetragen am 11.02.1997        Geschäftsfall 007 072 Fr 1060/97 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.02.1997
10  eingetragen am 26.08.1997        Geschäftsfall 007 072 Fr 7336/97 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.07.1997
11  eingetragen am 29.01.1998        Geschäftsfall 007 072 Fr 804/98 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.01.1998
12  eingetragen am 14.08.1998        Geschäftsfall 007 072 Fr 6615/98 v
Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.07.1998
13  eingetragen am 19.08.1998        Geschäftsfall 007 072 Fr 7212/98 x
Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.08.1998
14  eingetragen am 16.03.1999        Geschäftsfall 007 072 Fr 2260/99 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 09.02.1999
15  eingetragen am 14.09.1999        Geschäftsfall 007 072 Fr 9466/99 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.07.1999
16  eingetragen am 04.01.2000        Geschäftsfall 007 072 Fr 71/00 f
Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.12.1999
17  eingetragen am 20.07.2000        Geschäftsfall 007 072 Fr 8369/00 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.07.2000
18  eingetragen am 22.05.2001        Geschäftsfall 007 072 Fr 8028/01 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.05.2001
19  eingetragen am 31.01.2002        Geschäftsfall 007 072 Fr 1209/02 x
Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.01.2002
20  eingetragen am 17.05.2002        Geschäftsfall 007 072 Fr 4361/02 g
Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 11.04.2002
21  eingetragen am 22.05.2003        Geschäftsfall 007 072 Fr 5848/03 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.05.2003
22  eingetragen am 23.09.2003        Geschäftsfall 007 072 Fr 10098/03 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 27.08.2003
23  eingetragen am 23.01.2004        Geschäftsfall 007 072 Fr 606/04 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.01.2004
24  eingetragen am 04.06.2004        Geschäftsfall 007 072 Fr 6324/04 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 01.06.2004
25  eingetragen am 25.01.2005        Geschäftsfall 007 072 Fr 714/05 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.01.2005
26  eingetragen am 03.05.2005        Geschäftsfall 007 072 Fr 4873/05 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.04.2005
27  eingetragen am 12.09.2006        Geschäftsfall 007 072 Fr 9618/06 y
Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 28.08.2006
28  eingetragen am 27.07.2007        Geschäftsfall 007 072 Fr 7415/07 t
Antrag auf Änderung  eingelangt am 24.07.2007
29  eingetragen am 19.09.2007        Geschäftsfall 007 072 Fr 8254/07 a
Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.08.2007
30  eingetragen am 02.07.2008        Geschäftsfall 007 072 Fr 7512/08 v
Antrag auf Änderung  eingelangt am 27.06.2008
31  eingetragen am 18.07.2008        Geschäftsfall 007 072 Fr 8237/08 i
Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.07.2008
32  eingetragen am 19.11.2008        Geschäftsfall 007 072 Fr 14182/08 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.11.2008
33  eingetragen am 27.06.2009        Geschäftsfall 007 075 Fr 7679/09 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.06.2009
34  eingetragen am 20.01.2010        Geschäftsfall 007 073 Fr 774/10 i
Antrag auf Änderung  eingelangt am 15.01.2010
35  eingetragen am 15.06.2010        Geschäftsfall 007 073 Fr 8507/10 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.06.2010
36  eingetragen am 18.01.2011        Geschäftsfall 007 072 Fr 601/11 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.01.2011
37  eingetragen am 05.05.2011        Geschäftsfall 007 072 Fr 8076/11 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.05.2011
38  eingetragen am 02.07.2011        Geschäftsfall 007 072 Fr 12251/11 p
Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.06.2011
39  eingetragen am 27.09.2011        Geschäftsfall 007 072 Fr 17952/11 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.09.2011
40  eingetragen am 09.06.2012        Geschäftsfall 007 072 Fr 5224/12 p
Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.06.2012
41  eingetragen am 03.07.2012        Geschäftsfall 007 072 Fr 7295/12 i
Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.06.2012
42  eingetragen am 23.08.2012        Geschäftsfall 007 072 Fr 9342/12 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.08.2012
43  eingetragen am 11.06.2013        Geschäftsfall 007 072 Fr 5558/13 p
Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.06.2013
44  eingetragen am 01.07.2014        Geschäftsfall 007 072 Fr 9048/14 f
Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 25.06.2014
45  eingetragen am 17.07.2014        Geschäftsfall 007 072 Fr 9961/14 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 15.07.2014
46  eingetragen am 24.02.2015        Geschäftsfall 007 072 Fr 818/15 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.01.2015
47  eingetragen am 08.05.2015        Geschäftsfall 007 072 Fr 3970/15 x
Antrag auf Änderung  eingelangt am 06.05.2015
48  eingetragen am 05.05.2016        Geschäftsfall 007 072 Fr 3759/16 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.04.2016
49  eingetragen am 07.10.2016        Geschäftsfall 007 072 Fr 13978/16 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.10.2016
50  eingetragen am 16.05.2017        Geschäftsfall 007 072 Fr 4181/17 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 11.05.2017
51  eingetragen am 02.08.2017        Geschäftsfall 007 072 Fr 6892/17 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 17.07.2017
52  eingetragen am 25.10.2017        Geschäftsfall 007 072 Fr 14653/17 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 11.10.2017
53  eingetragen am 28.03.2018        Geschäftsfall 007 072 Fr 2832/18 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.03.2018
54  eingetragen am 28.04.2018        Geschäftsfall 007 072 Fr 4130/18 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.04.2018

 

 

Historical development

 

Year of incorporation

1991

Date of registration

1991-08-26

 

 

Change in share capital

 

from

to

asset

 

1993-11-04

2001-05-22

ATS

25.000.000,00

 

 

Former executives

 

from

to

position

name

1993-11-04

2017-08-02

member of the executive board

Andrew Paul

1994-12-28

2004-01-23

joint signing clerk

Djurdjevka Stojanovic

2005-01-25

2010-01-20

joint signing clerk

Doris Führer

1993-11-04

1997-02-11

joint signing clerk

Wilhelm Hofmann

2005-01-25

2011-05-05

joint signing clerk

Abdelkerim Farhat Moalla

1999-03-16

2007-07-27

member of the supervisory board

Sabine Irmler

2010-06-15

2012-08-23

deputy chairman of the executive board

Moncef Reisner

1994-03-08

2010-06-15

joint signing clerk

Moncef Reisner

1993-11-04

2003-09-23

member of the executive board

Heinz Zinner

2003-09-23

2004-06-04

joint signing clerk

Helmut Limbeck

2004-06-04

2010-06-15

member of the executive board

Helmut Limbeck

 

2000-01-01

shareholder

Evelyn Heinzel

2002-01-31

2008-07-18

joint signing clerk

Abdulkarim Al Resheg

2001-05-22

2016-05-05

chairman of the supervisory board

Alfred Heinzel

2000-07-20

2001-05-22

deputy chairman of the supervisory board

Alfred Heinzel

1993-11-04

1995-11-07

member of the supervisory board

Alfred Heinzel

1993-11-04

2007-07-27

member of the supervisory board

Henriette Joska

1991-01-10

2007-07-27

employee's representative on the supervisory board

Henriette Joska

2008-07-02

2011-07-02

member of the supervisory board

Wolfgang Pfarl

2011-07-02

2013-06-11

deputy chairman of the supervisory board

Wolfgang Pfarl

1997-08-26

2003-05-22

member of the supervisory board

Wilhelm Demuth

2003-05-22

2004-06-04

member of the executive board

Hans Müksch

1993-11-04

2003-05-22

joint signing clerk

Hans Müksch

2005-01-25

2011-01-18

joint signing clerk

Jürgen Nemeth

1993-11-04

1995-11-07

chairman of the supervisory board

Wilfried Heinzel

2005-05-03

2017-05-16

member of the supervisory board

Martha Dobringer

1993-11-04

2016-05-05

member of the supervisory board

Johannes Klezl-Norberg

1995-11-07

2000-07-20

member of the supervisory board

Ulf Ragnarsson Frölander

2009-06-27

2010-06-15

deputy chairman of the executive board

Dietmar Geigl

2007-09-19

2010-06-15

joint signing clerk

Dietmar Geigl

2000-01-04

2018-03-28

joint signing clerk

Peter Nassey

1993-11-04

1994-08-23

member of the supervisory board

Elfriede Mühlhauser

2013-06-11

2016-05-05

deputy chairman of the supervisory board

Rolf Johannesson

2003-05-22

2007-07-27

member of the supervisory board

Heinrich Georg Stahl

2007-07-27

2011-07-02

deputy chairman of the supervisory board

Heinrich Georg Stahl

1998-01-29

2014-07-17

joint signing clerk

Dijana Schak

1995-11-07

2001-05-22

chairman of the supervisory board

Karl Ludwig

2001-05-22

2007-07-27

deputy chairman of the supervisory board

Karl Ludwig

1993-11-04

1995-11-07

deputy chairman of the supervisory board

Karl Ludwig

1996-08-02

2005-05-03

member of the supervisory board

Reinhard Karl

2016-05-05

2017-10-25

deputy chairman of the supervisory board

Riia Sillave

1994-08-23

1999-03-16

employee's representative on the supervisory board

Elisabeth Denk

1994-08-23

1999-03-16

member of the supervisory board

Elisabeth Denk

2007-07-27

2008-11-19

member of the supervisory board

Martina Bauhofer

1993-11-04

1994-06-18

joint signing clerk

Peter Hutter

1993-11-04

1997-02-11

member of the supervisory board

Franz Rappold

1993-11-04

1994-03-08

joint signing clerk

Hellmuth Kruspl

1997-02-11

2001-05-22

joint signing clerk

Norbert Hofmann

 

 

Former shareholders

 

from

to

position

name

birth date

 

2000-01-01

shareholder

Evelyn Heinzel

1950-11-29

 

 

shareholder

Dr. Heinz Zinner Beteiligungsgesellschaft m.b.H.

 

 

1999-01-01

shareholder

Erste Bank Beteiligungen Gesellschaft m.b.H.

 

 

 

Former shareholdings

 

from

to

company name

 

1989-12-04

Wilfried Heinzel Beteiligungsgesellschaft m.b.H.

1999-12-03

2005-02-02

Zelpa Handelsgesellschaft m.b.H.

 

1994-12-31

"Cellulosa Pulp and Paper Trading"- Handelsgesellschaft m.b.H. in Liqu.

 

1997-05-22

Heinzel-Harmanec Handelsgesellschaft m.b.H.

1981-11-17

1991-12-18

Wilfried Heinzel Rohstoff- Handelsgesellschaft m.b.H.

 

 


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

INR 67.38

UK Pound

1

INR 91.39

Euro

1

INR 79.89

Euro

1

INR 80.35 

 

Note : Above are approximate rates obtained from sources believed to be correct

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

NIY

 

 

Report Prepared by :

SYL

                                                


 

RATING EXPLANATIONS

 

Credit Rating

Explanation

Rating Comments

A++

Minimum Risk

Business dealings permissible with minimum risk of default

A+

Low Risk

Business dealings permissible with low risk of default

A

Acceptable Risk

Business dealings permissible with moderate risk of default

B

Medium Risk

Business dealings permissible on a regular monitoring basis

C

Medium High Risk

Business dealings permissible preferably on secured basis

D

High Risk

Business dealing not recommended or on secured terms only

NB

New Business

No recommendation can be done due to business in infancy stage

NT

No Trace

No recommendation can be done as the business is not traceable

 

NB is stated where there is insufficient information to facilitate rating. However, it is not to be considered as unfavourable.

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors are as follows:

 

·         Financial condition covering various ratios

·         Company background and operations size

·         Promoters / Management background

·         Payment record

·         Litigation against the subject

·         Industry scenario / competitor analysis

·         Supplier / Customer / Banker review (wherever available)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.