MIPL-Logo

3decades

 

MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

509076

Report Date :

16.05.2018

 

 

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

WINTERSTEIGER AG

 

 

Formerly Known As :

·         WINTERSTEIGER GESELLSCHAFT M.B.H.

·         WINTERSTEIGER GMBH

 

 

Registered Office :

Johann Michael Dimmelstraße 9, A-4910 Ried Innkreis

 

 

Country :

Austria

 

 

Financials (as on) :

31.12.2016

 

 

Date of Incorporation :

1983

 

 

Legal Form :

Joint Stock Company

 

 

Line of Business :

·         Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c

·         Manufacture of agricultural and forestry machinery

·         Manufacture of power-driven hand tools

 

 

No. of Employees :

526

 

 

 

 

 

 

RATING & COMMENTS

(Mira Inform has adopted New Rating mechanism w.e.f. 23rd January 2017)

 

MIRA’s Rating :

A

 

Credit Rating

Explanation

Rating Comments

A

Acceptable Risk

Business dealings permissible with moderate risk of default

 

Status :

Good

 

 

Payment Behaviour :

No Complaints

 

 

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List

 

Country Name

Previous Rating

(30.09.2017)

Current Rating

(31.12.2017)

Austria

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low Risk

 

A2

Moderately Low Risk

 

B1

Moderate Risk

 

B2

Moderately High Risk

 

C1

High Risk

 

C2

Very High Risk

 

D

 


 

AUSTRIA - ECONOMIC OVERVIEW

 

Austria, with its well-developed market economy, skilled labor force, and high standard of living, is closely tied to other EU economies, especially Germany's. Its economy features a large service sector, a relatively sound industrial sector, and a small, but highly developed agricultural sector.

Economic growth has been relatively weak in recent years, approaching 1% in 2015, but rising to 2.3% in 2017. Austria's 5.8% unemployment rate, while low by European standards, is at its highest rate since the end of World War II, driven by an increased number of refugees and EU migrants entering the labor market. Without extensive vocational training programs and generous early retirement, the unemployment rate would be even higher.

Although Austria's fiscal position compares favorably with other euro-zone countries, it faces several external risks, such as unexpectedly weak world economic growth threatening the export market, Austrian banks' continued exposure to Central and Eastern Europe, repercussions from the Hypo Alpe Adria bank collapse, political and economic uncertainties caused by the European sovereign debt crisis, the current refugee crisis, and continued unrest in Russia/Ukraine. The budget deficit stood at 1% of GDP in 2017 and public debt declined slightly to 81.7% of GDP in 2017 after reaching a post-war high of 84.6% in 2016

 

Source : CIA

 


 

Company name and address

 

Wintersteiger AG

 

Johann Michael Dimmelstraße 9

A-4910 Ried Innkreis

 

Phone:

(0043) 7752 919

Fax:

(0043) 7752 919 - 55

E-mail:

office@wintersteiger.at

Internet:

http://www.wintersteiger.com

 

 

Activities

 

ÖNACE 28290 50% Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c.

ÖNACE 28300 30% Manufacture of agricultural and forestry machinery

ÖNACE 28240 20% Manufacture of power-driven hand tools

 

 

Financial data

 

Financial details can also be entered during the period, irrespective of the balance sheet date.

 

total turnover (total sales)

2017

EUR

95.700.000,00

(estimated)

total turnover (total sales)

2016

EUR

94.284.507,06

(exact)

total turnover (total sales)

2015

EUR

84.192.628,85

(exact)

total turnover (total sales)

2014

EUR

84.212.541,02

(exact)

total turnover (total sales)

2013

EUR

83.370.456,50

(exact)

 

turnover (sales) - group

2016

EUR

140.641.447,96

(exact)

turnover (sales) - group

2015

EUR

138.927.449,59

(exact)

turnover (sales) - group

2014

EUR

135.849.380,50

(exact)

turnover (sales) - group

2013

EUR

141.929.285,57

(exact)

turnover (sales) - group

2012

EUR

126.184.181,00

(exact)

 

total stock

2018

EUR

17.952.000,00

(approx.)

 

total investments

2015

EUR

5.877.288,03

(exact)

 

total employees

2018

 

526

(approx.)

 

 

General company information

 

Company name

Wintersteiger AG

Year of incorporation

1983

Type of company

Manufacturing

Legal form

joint stock company since 2004-09-23

Companies house number

FN 111807 y Ried im Innkreis since 1983-07-12

Import

China

France

Germany

Italy

Switzerland

USA

 

Export

world-wide

 

ARA-number

7799

VAT number

ATU 23702704

number - Austrian National Bank

176982

Last balance sheet:

2016

Banking connection

UniCredit Bank Austria AG

BLZ 12000

main bank connection

Oberbank AG

BLZ 15000

main bank connection

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

BLZ 34000

main bank connection

 

 

Locations

 

operational

A-4910 Ried im Innkreis, J.-M. Dimmelstr. 9

registered office

operational

A-4910 Ried Innkreis, Johann Michael Dimmelstraße 9

registered headquarters, owned property

 

0043 7752 919

office@wintersteiger.at

 

 

Private data

 

Surname

Date of birth

Address

Executive positions

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Ing. Andreas Doubrava

1977-10-12

A-4872 Neukirchen Vöckla

Sonnleiten 9

joint signing clerk

1

Mag. Ernst Wageneder

1970-09-27

A-4753 Taiskirchen im Innkreis

Wiesenhang 24

joint signing clerk

0

Dr. Florestan von Boxberg

1961-09-20

D-69120 Heidelberg

Hainsbachweg 5

chairman of the executive board

3

Mag. Harold Wilfried Kostka

1972-02-24

A-4654 Bad Wimsbach Neydharting

Seulbergerstraße 17

member of the executive board

2

Dipl-Ing. Christian Rauscher

1967-09-23

A-5230 Mattighofen

Grabenstraße 6

member of the executive board

8

Wolff Lange

1957-10-21

D-20354 Hamburg

Gänsemarkt 21-23

chairman of the supervisory board

0

Klaus Jaenecke

1955-12-27

D-80539 München

Maximilianstraße 35a

deputy chairman of the supervisory board

0

Karl Bachinger

1965-09-02

A-4950 Altheim

Diepolding 8

member of the supervisory board

0

Rainer Bernhardt

1950-11-27

D-22967 Tremsbüttel

Kiebitzmoor 4

member of the supervisory board

0

Dipl-Ing. Raimund Diederichs

1955-01-29

A-1190 Wien

Cobenzlgasse 32

member of the supervisory board

1

Dr. Michael Hule

1960-05-27

A-1190 Wien

Langackergasse 28A

member of the supervisory board

24

Georg Ibinger

1960-05-26

A-4924 Waldzell

Wirmling 12

member of the supervisory board

0

August Wimmer

1959-06-23

A-4941 Mehrnbach

Käfermühl 6

member of the supervisory board

0

 

 

Business unit manager

 

Surname

Date of birth

Address

Executive positions

Further executive positions (as registered in the companies' house)

Gerhard Gadermair

 

A-4910 Ried Innkreis

Johann Michael Dimmelstraße 9(c/o)

head of accounting

0

Ing. Helmut Gruber

 

A-4910 Ried Innkreis

Johann Michael Dimmelstraße 9(c/o)

head of purchasing

0

Franz Gangl

 

A-4910 Ried Innkreis

Johann Michael Dimmelstraße 9(c/o)

head of marketing

0

Gerald Zwicklhuber

 

A-4910 Ried Innkreis

Johann Michael Dimmelstraße 9(c/o)

head of EDP

0

Gerhard Hattinger

 

A-4910 Ried Innkreis

Johann Michael Dimmelstraße 9(c/o)

technical director

0

 

 

Ownership structure and related companies

 

Company name

Address

Shareholdings in %

Since

Commercial register no.

Shares in this company are held by:

LJH-Holding GmbH

D-21521 Wohltorf

Waldstr. 7

74,9 %

 

 

ULM Management GmbH

D-20148 Hamburg

Mittelweg 124

25,1 %

 

 

 

This company holds 100% of the shares in:

Gruber Automations GmbH

A-4931 Mettmach

Kirchheimerstraße 3

100 %

2012-11-17

FN 268044 h

This company holds less than 50% of the shares in:

Techno-Z Ried Technologiezentrum GmbH

A-4910 Ried Innkreis

Molkereistraße 4

2,37 %

2010-10-07

FN 186116 a

 

 

 

 

 

 

Financials

 

Balance Sheet (absolute) all amounts in EUR

 

 

2016-12-31

Franchises, patents, licences, trademarks and similar rights and advantages

466.555,00

Sum intangible assets

466.555,00

 

Land and leasehold rights with buildings thereon including building on land owned by third parties

8.455.036,75

Other operating and business equipment

1.411.079,00

Technical plants and machines

693.619,00

Advanced payments and constructions in progress

409.418,33

Sum tangible assets

10.969.153,08

 

Shares on related firms

22.882.161,00

Other shareholdings

38.305,34

Loans to related firms

11.694.000,00

Sum financial assets

34.614.466,34

 

Sum fixed assets

46.050.174,42

 

Raw-, auxiliary materials and supplies

6.588.342,87

Unfinished products

5.854.743,83

Finished products

5.457.265,03

Advanced payments

52.050,77

Sum stock

17.952.402,50

 

Claims from delivered goods and performed services

9.540.891,29

Claims against related firmes Claims against companies with shareholding relationship

12.245.841,49

Other claims and assets

2.403.096,20

Sum claims

24.189.828,98

 

Cash on hand, cheques and bank deposits

1.037.958,53

Sum cash and bank

1.037.958,53

 

Sum current assets

43.180.190,01

 

Deferred charges

597.640,01

Sum deferred charges

597.640,01

Assets

89.828.004,44

 

Subscribed/declared capital

15.000.000,00

Legal reserves

1.500.000,00

Other reserves

1.450.467,26

Balance sheet profit/balance sheet loss

38.710.525,48

Thereof profit/loss carried forward

34.270.803,91

Sum equity capital

56.660.992,74

 

Reserves for severance pays

5.294.462,00

Tax reserves

1.627.930,00

Other reserves

6.383.616,00

Sum reserves

13.306.008,00

 

Liabilities against credit institutes

11.818.234,00

Received advanced payments for orders

1.224.357,50

Liabilities from delivered goods and performed services

2.926.305,09

Liabilities against related firms

11.698,11

Other liabilities

3.601.925,07

Sum liabilities

19.582.519,77

 

Deferred income

278.483,93

Sum deferred income

278.483,93

 

Liabilities and shareholders'equity

89.828.004,44

Balance sheet sum

89.828.004,44

 

 

P / L Account (absolute) all amounts in EUR

 

2016-12-31

Gross sales

94.284.507,06

Increase or decrease in finished and unfinished goods and in service claims

573.938,03

Other manufacturing costs capitalized

19.419,80

Total turnover or gross profit

94.877.864,89

 

Other operating profits

1.131.310,96

Other operating profits totally

1.131.310,96

 

Costs for obtained services

-4.477.235,80

Material costs

-38.298.825,21

Costs for obtained services totally

-42.776.061,01

 

Wages

-9.456.540,56

Salaries

-16.918.336,90

Costs for severance pays

-677.834,88

Costs for old age pension

-70.000,00

Legal fringe benefits and other payments depending on salaries

-6.562.872,83

Other social fringe benefits

-260.158,33

Personnel expenses totally

-33.945.743,50

 

Depreciation of intangible assets, tangible assets,activated expenses for the set up and expansion of business operation

-1.723.041,74

Depreciation tangible assets / intangible assets totally

-1.723.041,74

 

Other operating costs

-12.219.847,68

Total costs

-12.219.847,68

 

Operating result totally

5.344.481,92

 

Profits from shareholdings

3.296.161,08

Income from other securities and loans of financial assets

459.096,59

Interest income, securties income and similar income

53.142,83

Profits from the retirement of and investment in financial assets

1.178.005,00

Disbursements from other financial assets and from securities of current assets (e.g. depreciations)

-4.003.881,32

Interest and similar disbursements

-711.232,47

Financial profits totally

271.291,71

 

Results from usual business activity totally

5.615.773,63

 

Taxes on income and profits

-1.176.052,06

Taxes on income and profits totally

-1.176.052,06

 

Annual surplus/annual deficit totally

4.439.721,57

 

Annual profit/annual loss totally

4.439.721,57

 

Profit and loss carried forward from previous year

34.270.803,91

Transfer of profits totally

34.270.803,91

 

B/S profit/ B/S loss from profit and loss account

38.710.525,48

 

 

Key ratios

 

2016

Cashflow II

6.162.763,31

Debt amortisation period in years

4,97

Bank indebtedness

13,16

Equity capital share in %

63,95

Social capital share

5,89

Fixed assets coverage in %

134,54

Net profit ratio

5,92

Capital turnover

1,06

Return on investment in %

7,04

Cashflow in % of operating performance

6,50

Cashflow I

7.338.815,37

Gross productivity

2,79

Net productivity

1,53

Operating performance

94.877.864,89

Inventories in % of operating performance

18,92

Gross profit

52.101.803,88

 

 

Land Register

 

Last check

2016-04-11

 

Entry number

Cadastral community

Journal number

1837

Ried im Innkreis                     O 46149

4685/2014

 

Section A – type of property:


GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
618/40  G GST-Fläche        *    20321
Bauf.(10)              13851
Sonst(50)               6470  Johann-Michael-Dimmel-Straße 9
Legende:
G: Grundstück im Grenzkataster
*: Fläche rechnerisch ermittelt
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude)
Sonst(50): Sonstige (Betriebsflächen)

1  a 1228/1988 Antrag 1988-03-04 Zuschreibung Gst 618/41 aus EZ 2949
2  a 2448/2002 Beschluss 2002-06-19 Zuschreibung Gst .1103 aus EZ 1315
3  a 3177/2011 Kaufvertrag 2011-06-16 Zuschreibung Gst 618/63 aus EZ 3380,
618/61 aus EZ 2743, 618/62 aus EZ 2745, 618/43 aus EZ 1855
4  a 711/1967 2081/1979 4684/2014 Grunddienstbarkeit des Heranbaurechtes an
Gst 618/28 hins Gst 618/59 EZ 1747 für Gst 618/40
b 6463/2007 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 19
c 3177/2011 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 3380
5  a 3126/1977 Bauplatz (auf) Gst 618/61 gem Bescheid 1977-08-01
b 866/1981 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 19
c 3177/2011 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 2743
6  a 2683/1977 Bauplatz (auf) Gst 618/62 gem Bescheid 1977-05-02
b 1626/1981 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 19
c 3177/2011 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 2745
7  a 2257/1986 5922/1987 Bauplatz (auf) Gst 618/43
b 3177/2011 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 1855
c gelöscht
8  a 3232/2000 4684/2014 Grunddienstbarkeit des Geh- und Fahrtrechtes sowie
Zugangsrechtes hins Gst 618/66 für Gst 618/40
b 3177/2011 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 1855
9  a 358/2012 Kaufvertrag 2012-01-05 Zuschreibung Gst 618/57 aus EZ 1101
11  a 4671/2014 BEV 1373/2014/46 §12 VermG Änderung hins Gst 618/40

Section B – ownership structure:


1 ANTEIL: 1/1
Wintersteiger AG
ADR: Dimmelstraße 9, Ried im Innkreis   4910
c 3656/1990 IM RANG 5991/1989 Urkunde 1989-12-20 Eigentumsrecht
vorgemerkt
d 2217/1992 Rechtfertigung
e 1372/1997 Namensänderung
g 4312/2004 Namensänderung
h 2950/2011 Änderung der Anschrift

Section C – encumbrances:


14  a 6463/2007  4685/2014
DIENSTBARKEIT der Errichtung des Betriebes und der
Benützung des öffentlichen Kanals und der Leitung für
Straßenbeleuchtung gem Pkt 11.2. Kaufvertrag 2007-12-03
hins Gst 618/40 für Gst 618/1
b 3177/2011 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ
3380
15  a 6463/2007
DIENSTBARKEIT der Errichtung, des Betriebes und der
Benützung der Gasleitung, der Wasserleitung sowie der
Stromleitungen einschließlich der Erdungsleitungen gem Pkt
11.3. Kaufvertrag 2007-12-03 hins Gst 618/40 für Energie
Ried Gesellschaft m.b.H.
b 3177/2011 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ
3380
16  a 3232/2000 4685/2014
DIENSTBARKEIT des Geh- und Fahrtrechtes gem § 2
Dienstbarkeitsvertrag 2000-05-25 hins Gst 618/40 für Gst
618/66
b 3177/2011 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ
1855

 

 

Commercial register

 

Source of data from commercial register: Republic of Austria represented by the Federal Ministry of Justice

 

firm (style)

33 Wintersteiger AG

legal form

33 Aktiengesellschaft

registered office

1 politischer Gemeinde Ried im Innkreis

business adress

1 J.-M. Dimmelstr. 9
4910 Ried im Innkreis

capital

42 EUR 15.000.000,00

reference date annual accounts

1 31.Dezember

annual accounts

84 zum 31.12.2016 eingereicht am 22.09.2017

consolidated accounts

85 zum 31.12.2016 eingereicht am 22.09.2017

power of representation

33 Die Gesellschaft wird, wenn nur ein Vorstandsmitglied be-
stellt ist, durch dieses, sonst durch zwei Vorstandsmitglie-
der gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat ist allerdings berechtigt, auch eine abwei-
chende Vertretungsregelung zu bestimmen, insbesondere einem
oder mehreren Vorstandsmitgliedern auch Einzelvertretungsbe-
fugnis zu erteilen.
Prokuristen sind zur Vertretung der Gesellschaft jedenfalls
nur gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied berechtigt.

other provisions

33 Der Vorstand besteht aus mindestens einer und höchstens
fünf Personen.

 

board of directors

AI    Dipl.-Ing. Christian Rauscher, geb. 23.09.1967
64    Mitglied
64    vertritt seit 01.08.2013 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
AJ    Mag. Harold Kostka, geb. 24.02.1972
67    Mitglied
67    vertritt seit 15.09.2014 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen/
einer Prokuristin
AN    Dr. Florestan von Boxberg, geb. 20.09.1961
78    Vorsitzende/r
78    vertritt seit 01.09.2016 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen/
einer Prokuristin

 

proxy

AM    Ing. DI (FH) Andreas Doubrava MSc, geb. 12.10.1977
77    vertritt seit 23.09.2015 gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied
AP    Mag. Ernst Wageneder, geb. 27.09.1970
86    vertritt seit 16.01.2018 gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied

 

supervisory board

G    Dr. Michael Hule
1    Mitglied
1            O    Georg Ibinger, geb. 26.05.1960
35    Mitglied
35            AC    Wolff Lange, geb. 21.10.1957
47    Vorsitzende/r
47            AF    Klaus F. Jaenecke, geb. 27.12.1955
47    Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
47            AH    Rainer Bernhardt, geb. 27.11.1950
61    Mitglied
61            AK    Dipl.-Ing. Raimund Diederichs, geb. 29.01.1955
71    Mitglied
71            AL    Karl Bachinger, geb. 02.09.1965
72    Mitglied
72            AO    August Wimmer, geb. 23.06.1959
81    Mitglied
81

 

general table


Landesgericht Ried im Innkreis
1   eingetragen am 05.08.1994        Geschäftsfall 469 914 Fr 84/94 d
Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
2   eingetragen am 05.08.1994        Geschäftsfall 469 914 Fr 87/94 h
Übernahme in das ADV-Firmenbuch
3   eingetragen am 10.08.1994        Geschäftsfall 469 005 Fr 440/94 v
Antrag auf Änderung  eingelangt am 27.07.1994
4   eingetragen am 22.04.1995        Geschäftsfall 469 016 Fr 713/95 i
Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.04.1995
5   eingetragen am 29.07.1995        Geschäftsfall 469 016 Fr 1426/95 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 25.07.1995
6   eingetragen am 25.04.1996        Geschäftsfall 469 016 Fr 502/96 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.04.1996
7   eingetragen am 07.08.1996        Geschäftsfall 469 016 Fr 1005/96 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 06.08.1996
8   eingetragen am 29.08.1996        Geschäftsfall 469 016 Fr 1084/96 p
Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.08.1996
9   eingetragen am 07.06.1997        Geschäftsfall 469 016 Fr 785/97 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 06.06.1997
10  eingetragen am 04.09.1997        Geschäftsfall 469 016 Fr 1258/97 d
Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.09.1997
11  eingetragen am 30.06.1998        Geschäftsfall 469 016 Fr 1067/98 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.06.1998
12  eingetragen am 25.09.1998        Geschäftsfall 469 016 Fr 1767/98 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 24.09.1998
13  eingetragen am 23.06.1999        Geschäftsfall 469 016 Fr 1304/99 p
Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.06.1999
14  eingetragen am 29.06.2000        Geschäftsfall 469 016 Fr 1223/00 x
Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.06.2000
15  eingetragen am 05.08.2000        Geschäftsfall 469 016 Fr 1560/00 t
Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.08.2000
16  eingetragen am 03.10.2000        Geschäftsfall 469 016 Fr 1884/00 v
Antrag auf Änderung  eingelangt am 26.09.2000
17  eingetragen am 21.03.2001        Geschäftsfall 469 016 Fr 473/01 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.03.2001
18  eingetragen am 26.07.2001        Geschäftsfall 469 016 Fr 1157/01 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 24.07.2001
19  eingetragen am 10.11.2001        Geschäftsfall 469 016 Fr 2375/01 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 09.11.2001
20  eingetragen am 17.04.2002        Geschäftsfall 469 016 Fr 778/02 i
Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.04.2002
21  eingetragen am 02.07.2002        Geschäftsfall 469 016 Fr 1284/02 d
Antrag auf Änderung  eingelangt am 28.06.2002
22  eingetragen am 10.08.2002        Geschäftsfall 469 016 Fr 1552/02 y
Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 09.08.2002
23  eingetragen am 02.10.2002        Geschäftsfall 469 016 Fr 2019/02 i
Antrag auf Änderung  eingelangt am 01.10.2002
24  eingetragen am 11.10.2002        Geschäftsfall 469 016 Fr 2169/02 f
Antrag auf Änderung  eingelangt am 10.10.2002
25  eingetragen am 14.12.2002        Geschäftsfall 469 016 Fr 3238/02 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.12.2002
26  eingetragen am 04.01.2003        Geschäftsfall 469 016 Fr 8/03 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.01.2003
27  eingetragen am 02.07.2003        Geschäftsfall 469 016 Fr 1262/03 f
Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 01.07.2003
28  eingetragen am 11.07.2003        Geschäftsfall 469 016 Fr 1345/03 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 09.07.2003
29  eingetragen am 06.11.2003        Geschäftsfall 469 016 Fr 2480/03 x
Antrag auf Änderung  eingelangt am 05.11.2003
30  eingetragen am 05.12.2003        Geschäftsfall 469 016 Fr 2847/03 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.12.2003
31  eingetragen am 22.07.2004        Geschäftsfall 469 016 Fr 1416/04 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.07.2004
32  eingetragen am 06.08.2004        Geschäftsfall 469 016 Fr 1479/04 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 02.08.2004
33  eingetragen am 12.10.2004        Geschäftsfall 469 016 Fr 2149/04 v
Antrag auf Änderung  eingelangt am 30.09.2004
34  eingetragen am 20.05.2005        Geschäftsfall 469 016 Fr 1055/05 v
Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.05.2005
35  eingetragen am 28.06.2005        Geschäftsfall 469 016 Fr 1290/05 p
Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.06.2005
36  eingetragen am 29.03.2006        Geschäftsfall 469 016 Fr 771/06 i
Antrag auf Änderung  eingelangt am 24.03.2006
37  eingetragen am 30.03.2006        Geschäftsfall 469 016 Fr 772/06 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 24.03.2006
38  eingetragen am 22.06.2006        Geschäftsfall 469 016 Fr 1489/06 s
Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.06.2006
39  eingetragen am 13.07.2006        Geschäftsfall 469 016 Fr 1670/06 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 11.07.2006
40  eingetragen am 21.07.2006        Geschäftsfall 469 016 Fr 1754/06 f
amtswegige Berichtigung
41  eingetragen am 15.08.2006        Geschäftsfall 469 016 Fr 1887/06 a
Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 04.08.2006
42  eingetragen am 26.06.2007        Geschäftsfall 469 016 Fr 1707/07 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 22.06.2007
43  eingetragen am 17.05.2008        Geschäftsfall 469 016 Fr 1312/08 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 15.05.2008
44  eingetragen am 20.05.2008        Geschäftsfall 469 016 Fr 1329/08 y
Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.05.2008
45  eingetragen am 19.08.2008        Geschäftsfall 469 016 Fr 2104/08 m
Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.08.2008
46  eingetragen am 19.09.2008        Geschäftsfall 469 016 Fr 2505/08 b
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 16.09.2008
47  eingetragen am 20.01.2009        Geschäftsfall 469 016 Fr 210/09 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 16.01.2009
48  eingetragen am 03.07.2009        Geschäftsfall 469 016 Fr 2237/09 t
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 02.07.2009
49  eingetragen am 09.09.2010        Geschäftsfall 469 016 Fr 2678/10 z
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 08.09.2010
50  eingetragen am 11.09.2010        Geschäftsfall 469 016 Fr 2677/10 y
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 08.09.2010
51  eingetragen am 22.04.2011        Geschäftsfall 469 016 Fr 2030/11 f
Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.04.2011
52  eingetragen am 01.07.2011        Geschäftsfall 469 016 Fr 2819/11 s
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 30.06.2011
53  eingetragen am 02.07.2011        Geschäftsfall 469 016 Fr 2818/11 p
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 30.06.2011
54  eingetragen am 03.04.2012        Geschäftsfall 469 016 Fr 697/12 d
Antrag auf Änderung  eingelangt am 21.03.2012
55  eingetragen am 05.04.2012        Geschäftsfall 469 016 Fr 847/12 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.04.2012
56  eingetragen am 14.06.2012        Geschäftsfall 469 016 Fr 1410/12 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.06.2012
57  eingetragen am 19.06.2012        Geschäftsfall 469 016 Fr 1444/12 b
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 18.06.2012
58  eingetragen am 20.06.2012        Geschäftsfall 469 016 Fr 1445/12 d
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 18.06.2012
59  eingetragen am 16.11.2012        Geschäftsfall 469 016 Fr 3932/12 k
Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.11.2012
60  eingetragen am 23.03.2013        Geschäftsfall 469 016 Fr 1410/12 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 13.06.2012
61  eingetragen am 11.04.2013        Geschäftsfall 469 016 Fr 875/13 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 09.04.2013
62  eingetragen am 10.08.2013        Geschäftsfall 469 016 Fr 2184/13 z
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 09.08.2013
63  eingetragen am 13.08.2013        Geschäftsfall 469 016 Fr 2183/13 y
Elektronische Einreichung Jahresabschluss Konzernabschluss
eingelangt am 09.08.2013
64  eingetragen am 07.09.2013        Geschäftsfall 469 016 Fr 2513/13 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.09.2013
65  eingetragen am 08.01.2014        Geschäftsfall 469 016 Fr 19/14 z
Antrag auf Änderung  eingelangt am 03.01.2014
66  eingetragen am 12.08.2014        Geschäftsfall 469 016 Fr 1944/14 f
Antrag auf Änderung  eingelangt am 04.08.2014
67  eingetragen am 20.09.2014        Geschäftsfall 469 016 Fr 2745/14 h
Antrag auf Änderung  eingelangt am 19.09.2014
68  eingetragen am 08.10.2014        Geschäftsfall 469 016 Fr 3022/14 s
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 25.09.2014
69  eingetragen am 09.10.2014        Geschäftsfall 469 016 Fr 3021/14 p
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 25.09.2014
70  eingetragen am 31.03.2015        Geschäftsfall 469 016 Fr 579/15 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 27.03.2015
71  eingetragen am 01.04.2015        Geschäftsfall 469 016 Fr 581/15 i
Antrag auf Änderung  eingelangt am 27.03.2015
72  eingetragen am 25.04.2015        Geschäftsfall 469 016 Fr 831/15 b
Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.04.2015
73  eingetragen am 20.05.2015        Geschäftsfall 469 016 Fr 1004/15 g
Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.05.2015
74  eingetragen am 02.10.2015        Geschäftsfall 469 016 Fr 3528/15 v
Antrag auf Änderung  eingelangt am 01.10.2015
75  eingetragen am 02.10.2015        Geschäftsfall 469 016 Fr 2878/15 m
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 24.09.2015
76  eingetragen am 03.10.2015        Geschäftsfall 469 016 Fr 2877/15 k
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 24.09.2015
77  eingetragen am 10.10.2015        Geschäftsfall 469 016 Fr 3610/15 p
Antrag auf Änderung  eingelangt am 07.10.2015
78  eingetragen am 10.09.2016        Geschäftsfall 469 016 Fr 2371/16 a
Antrag auf Änderung  eingelangt am 08.09.2016
79  eingetragen am 21.09.2016        Geschäftsfall 469 016 Fr 2659/16 z
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 20.09.2016
80  eingetragen am 22.09.2016        Geschäftsfall 469 016 Fr 2658/16 y
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 20.09.2016
81  eingetragen am 25.02.2017        Geschäftsfall 469 016 Fr 316/17 m
Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.02.2017
82  eingetragen am 25.08.2017        Geschäftsfall 469 016 Fr 1952/17 v
Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.08.2017
83  eingetragen am 02.09.2017        Geschäftsfall 469 016 Fr 2107/17 x
Antrag auf Änderung  eingelangt am 31.08.2017
84  eingetragen am 12.10.2017        Geschäftsfall 469 016 Fr 2798/17 m
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 22.09.2017
85  eingetragen am 13.10.2017        Geschäftsfall 469 016 Fr 2797/17 k
Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 22.09.2017
86  eingetragen am 24.01.2018        Geschäftsfall 469 016 Fr 162/18 w
Antrag auf Änderung  eingelangt am 23.01.2018


 

 

Historical development

 

Year of incorporation

1983

Date of registration

1983-07-12

 

 

Change of company name

 

from

to

company name

1994-08-05

1994-08-05

Wintersteiger Gesellschaft m.b.H.

1994-08-05

2004-10-12

Wintersteiger GmbH

 

 

 

Change of legal form

 

from

to

company name

1994-08-05

2004-10-12

limited liability company

 

 

Change in share capital

 

from

to

asset

 

1994-08-05

1995-07-29

ATS

32.000.000,00

1995-07-29

2000-06-29

ATS

50.000.000,00

2000-06-29

2001-07-26

ATS

70.000.000,00

2001-07-26

2004-07-22

EUR

7.000.000,00

2004-07-22

2007-06-26

EUR

10.000.000,00

 

 

Former executives

 

from

to

position

name

1996-08-07

1997-06-07

joint signing clerk

Rudolf Hittmair

2003-07-11

2003-11-06

member of the supervisory board

Walter Durchschlag

2000-08-05

2001-11-10

member of the supervisory board

Walter Durchschlag

2003-11-06

2004-10-12

deputy chairman of the supervisory board

Walter Durchschlag

2001-11-10

2003-07-11

manager

Walter Durchschlag

1994-08-10

1996-04-25

manager

Nikolaus Maximoff

2013-03-23

2015-10-02

chairman of the executive board

Reiner Thalacker

2012-06-14

2013-03-23

member of the executive board

Reiner Thalacker

2002-12-14

2004-08-06

manager

Michael Neuwirth

2001-11-10

2002-12-14

joint signing clerk

Michael Neuwirth

1996-08-07

1998-09-25

member of the supervisory board

Karl Ozlsberger

1995-07-29

1996-08-07

manager

Karl Ozlsberger

1995-04-22

1995-07-29

member of the supervisory board

Karl Ozlsberger

2005-06-28

2006-06-22

member of the supervisory board

Herbert Litzlbauer

1996-04-25

2004-10-12

member of the supervisory board

Herbert Litzlbauer

1994-08-05

2004-10-12

partner

Rainer Bartram

1994-08-05

2009-01-20

chairman of the supervisory board

Rainer Bartram

1994-08-05

2000-10-03

partner

Margot Mayrhuber

2006-03-30

2006-07-13

member of the supervisory board

Wolff Lange

2006-07-13

2009-01-20

deputy chairman of the supervisory board

Wolff Lange

1994-08-05

2001-03-21

partner

Roger Prasser

1994-08-05

1994-08-10

manager

Roger Prasser

1995-07-29

2002-04-17

joint signing clerk

Wolfgang Vilsecker

2008-05-17

2014-01-08

member of the executive board

Roland Greul

2002-10-02

2008-05-17

joint signing clerk

Roland Greul

1996-04-25

2004-10-12

member of the supervisory board

Georg Ibinger

1996-04-25

2001-11-10

manager

Peter Kuchner

2003-01-04

2004-10-12

manager

Walter Aumayr

2004-10-12

2012-11-16

member of the executive board

Walter Aumayr

2004-08-06

2004-10-12

manager

Günther Kamml

2004-10-12

2008-05-17

member of the executive board

Günther Kamml

2008-08-19

2012-04-03

member of the executive board

Markus Piber

1995-07-29

2003-07-11

joint signing clerk

Franz Nöbauer

2006-07-21

2013-04-11

member of the supervisory board

Johannes Kikinger

2004-10-12

2006-07-21

deputy chairman of the supervisory board

Johannes Kikinger

1994-08-05

2001-03-21

partner

Peter Süß

1994-08-05

1995-07-29

manager

Peter Süß

2001-11-10

2002-10-11

joint signing clerk

Gerhard Machtlinger

2006-06-22

2015-05-20

member of the supervisory board

Georg Seifriedsberger

1998-06-30

2002-07-02

joint signing clerk

Berthold Lindorfer

2001-11-10

2003-07-11

member of the supervisory board

Eric Heinke

1995-07-29

1996-08-07

member of the supervisory board

Eric Heinke

 

Former shareholders

 

from

to

position

name

birth date

1994-08-05

2004-10-12

partner

Rainer Bartram

1924-03-03

1994-08-05

2000-10-03

partner

Margot Mayrhuber

1956-07-02

1994-08-05

2001-03-21

partner

Peter Süß

1946-11-27

1994-08-05

2001-03-21

partner

Roger Prasser

1953-04-23

2001-03-21

2004-10-12

partner

UBF Mittelstandsfinanzierungs AG in Abwicklung

 

 

 

Former shareholdings

 

from

to

company name

2011-05-31

2014-08-12

Boot-Doc Handels-G.m.b.H.

2008-02-20

2008-10-10

CimaTech CAD/CAM Services GmbH in Liqu.

 

1990-01-10

Wintersteiger Gesellschaft m.b.H. & Co.

 

 

Mergers

 

On

position

name

2014-08-12

merged with

Boot-Doc Handels-G.m.b.H.


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

INR 60.53

UK Pound

1

INR 91.49

Euro

1

INR 80.53

AUD

1

INR 50.75

 

Note : Above are approximate rates obtained from sources believed to be correct

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

VAR

 

 

Report Prepared by :

KET

                                                


 

RATING EXPLANATIONS

 

Credit Rating

Explanation

Rating Comments

A++

Minimum Risk

Business dealings permissible with minimum risk of default

A+

Low Risk

Business dealings permissible with low risk of default

A

Acceptable Risk

Business dealings permissible with moderate risk of default

B

Medium Risk

Business dealings permissible on a regular monitoring basis

C

Medium High Risk

Business dealings permissible preferably on secured basis

D

High Risk

Business dealing not recommended or on secured terms only

NB

New Business

No recommendation can be done due to business in infancy stage

NT

No Trace

No recommendation can be done as the business is not traceable

 

NB is stated where there is insufficient information to facilitate rating. However, it is not to be considered as unfavourable.

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors are as follows:

 

·         Financial condition covering various ratios

·         Company background and operations size

·         Promoters / Management background

·         Payment record

·         Litigation against the subject

·         Industry scenario / competitor analysis

·         Supplier / Customer / Banker review (wherever available)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.