MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

509857

Report Date :

17.05.2018

 

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

JULES

 

 

Registered Office :

152 Avenue Alfred Motte, Cs 90565, 59060 Roubaix Cedex 1

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2015

 

 

Date of Incorporation :

January 1964

 

 

Com. Reg. No.:

RCS Lille Metropole B 305 154 262

 

 

Legal Form :

Simplified Joint Stock Company

 

 

Line of Business :

Retail Sale of Clothing in Specialized Establishments (4771Z)

 

 

No. of Employees :

2017 [2015]

 


 

RATING & COMMENTS

(Mira Inform has adopted New Rating mechanism w.e.f. 23rd January 2017)

 

MIRA’s Rating :

A

 

Credit Rating

 

Explanation

Rating Comments

A

Acceptable Risk

Business dealings permissible with moderate risk of default

 

Status :

Good

 

 

Payment Behaviour :

No Complaints

 

 

Litigation :

Clear

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List

 

Country Name

Previous Rating

(30.09.2017)

Current Rating

(31.12.2017)

France

A1

A1

 

Risk Category

 

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low Risk

 

A2

Moderately Low Risk

 

B1

Moderate Risk

 

B2

Moderately High Risk

 

C1

High Risk

 

C2

Very High Risk

 

D

 


 

FRANCE - ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. France is the most visited country in the world with 83 million foreign tourists in 2016, including 530,000 visitors for the 2016 Euro Cup. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that mitigate economic inequality.

France's real GDP grew by 1.6% in 2017, up from 1.2% the year before. The unemployment rate (including overseas territories) increased from 7.8% in 2008 to 10.2% in 2015, before falling to 9.5% in 2017. Youth unemployment in metropolitan France decreased from 24.6% in the fourth quarter of 2014 to 24% in the fourth quarter of 2016.

France’s public finances have historically been strained by high spending and low growth. Despite measures to restore public finances, the budget deficit rose from 3.3% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009. In 2017, the budget deficit improved to 2.9% of GDP, bringing it in compliance with the EU-mandated 3% deficit target. Meanwhile, France's public debt rose from 89.5% of GDP in 2012 to 96.9% in 2017.

Since entering office in May 2017, President Emmanuel MACRON launched a series of economic reforms to improve competitiveness and boost economic growth. President MACRON campaigned on reforming France’s labor code and in late 2017 implemented a range of reforms to increase flexibility in the labor market by making it easier for firms to hire and fire and simplifying negotiations between employers and employees. In addition to labor reforms, President MACRON’s proposed 2018 budget cuts public spending, taxes, and social security contributions to spur private investment and increase purchasing power

 

Source : CIA

 

 


Company summary

 

SIRET

305 154 262 00037

Name

JULES

Acronym

-

Trade name

JULES

Status

Economically active

Postal Address

JULES
152 AVENUE ALFRED MOTTE
CS 90565
59060 ROUBAIX CEDEX 1
FRANCE

Share Capital

30,990,501 Euros

Telephone

08 00 30 15 27

Activity (APE)

Retail sale of clothing in specialized establishments (4771Z)

RCS Registration

RCS Lille Metropole B 305 154 262

Formation Date

01/1964

EUR VAT Number

FR78305154262

Deregistration Date

-

Last account Date

31/12/2015

Court Registry Number

19 9 6B01411

Incorporation Date

01/1976

Registration Court

Lille Metropole (59)

Fax

-

Nationality

France

Legal form

Simplified Joint Stock Company

Currency

Euros

 

 

Key Financials

 

YEAR TO DATE

TURNOVER

GROSS OPERATING SURPLUS

SHAREHOLDER'S EQUITY

NET RESULT

EMPLOYEES

31/12/2015

354,306,011 €

14.87% Turnover

113,130,684 €

28,006,413 €

2017 employees

31/12/2014

351,599,803 €

13.86% Turnover

103,632,266 €

18,507,995 €

1860 employees

31/12/2013

321,388,603 €

13.73% Turnover

102,974,296 €

17,850,025 €

1879 employees

 

Directors

Current Directors

7

 

 

Ultimate Holding Company

Name

Company Number

SODEREC

344364666

Affiliation links.

1 company in 1 country.

 

 

Judgment and Preferential

Judgment

No judgement

Preferential Right

No social security and tax office preferential right to date

 

 

Establishment Details

 

Type of Establishment

Head Office

Production Role

-

APE/NAF Code

7010Z

Activity

Activities of head offices

Formation Date

12/1995

Reason for Formation

Formation

Closure Date

-

Reason for Closure

-

Reactivation Date

-

Seasonality

-

Activity Nature

-

Activity Location

Other

Trading Address

152 AVENUE ALFRED MOTTE 
59100 ROUBAIX

Department

Nord (59)

Location Surface

-

District

5

City

ROUBAIX

Status

Economically active

Business Pages FT®

VETEMENTS POUR HOMMES (DETAIL)

Region

-

Area

98

Size of Urban Area

Urban unit with 200 000 to 1 999 999 inhabitants

 

Ultimate Parent(s)

1 ultimate parent company/companies for this company

Company Name

Activity (APE)

APE/NAF Code

City

Post Code

SODEREC

Activities of holding companies

6420Z

ROUBAIX

59100

 

Other Establishment(s)

Regionality

Legal unit with multiple establishments in many areas but no one grouping more than 50% of workforce

Mono-activity status

Legal unit with multiple establishments having main activities in many divisions, which one activity grouping from 80 to 99% of workforce

Branches

340 branch entities in this company

 

Company Name

Company Type

APE/NAF Code

Activity

City

Post Code

JULES

Head Office

4771Z

Retail sale of clothing in specialized stores

ROUBAIX

59100

JULES

Branch

4771Z

Retail sale of clothing in specialized stores

GAP

05000

JULES

Branch

4771Z

Retail sale of clothing in specialized stores

NICE

06200

JULES

Branch

4771Z

Retail sale of clothing in specialized stores

MARSEILLE 11

13011

JULES

Branch

4771Z

Retail sale of clothing in specialized stores

MARSEILLE 15

13015

 

Workforces

Workforce at address

100 to 199 employees

Company workforce

1 000 to 1 999 employees

 

 

Workforce account

2 000 to 4 999 employees

 

 

31/12/2015

 

 

 

Commentary

 

The comments are ordered according to the class of risk. Companies are compared with regard to other companies of the same type. Thus a positive comment for one category can be negative for another or can change depending on its value. This is a purely statistical decision.

The company has 7 directors

Industry code with low risk rating

The creditor days are 51.61

The total assets are 242,544,365 €

The shareholder's equity is 113,130,684 €

The risk provisions are 7,269,237 €

The liabilities are 122,144,444 €

Low risk workforce size

The net turnover is 354,306,011 €

The pre-tax profit is 40,026,749 €

The net current assets are 114,582,565 €

The sales to current assets ratio is 3.09

The ratio total assets to total liabilities is 1.87

The stock to turnover ratio is 11.23

The return on total assets employed is 16.50

Department code with medium risk rating

The increase in the gearing percentage over the last two accounting periods is 11 %

 

Industry comparison

Activity (APE)

Retail sale of clothing in specialized establishments (4771Z)

 

Collective procedures

No judgment information for the company

 

Preferential rights details and history

Summary of preferential rights

Company monitored since

18/04/2008

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

 

Group Data

Ultimate parent company

SODEREC

Direct parent

HAPPY CHIC - 100 %

Group – Number of companies

16

Linkages – Number of companies

1

Number of countries

2

 

 

NAME

SIREN

PARTS

LAST ACCOUNT PUBLISHED

1

SODEREC

344364666

-

-

2

TEXO

509509121

100 %

31/12/2016

3

HAPPY CHIC

509508628

81.02 %

31/12/2016

4

JULES

305154262

100 %

31/12/2015

5

JULES SPAIN

1536687

100 %

31/12/2015

JULES ITALIA S.R.L.

MI1880133

100 %

31/12/2016

JULES & CIE

-

100 %

-

JULES BELGIE

-

100 %

-

4

BRICE

312560584

100 %

31/12/2015

5

SOCIETE BELGE DE DISTRIBUTION TEXTILE SPRL

463103041

100 %

31/12/2016

SCI BONNEUIL

348867615

100 %

-

GIE COMMERCANTS CTRE COMMERCIAL ARCADES

313631269

0.10 %

-

BZB

482435898

100 %

31/12/2015

HAPPYCHIC LOGISTIQUE

518862750

100 %

31/12/2015

HAPPYCHIC PRODUCTION INTERNATIONAL

795013200

100 %

31/12/2015

HAPPYCHIC SERVICES

518862164

100 %

31/12/2015

CLEPAPOLO

513010512

99.90 %

-

SOPARHAPPYCHIC

453929747

11.04 %

31/12/2016

 

Shareholders

Type of shareholders

Company: 100%Company

 

Shareholders

HAPPY CHIC: 100%HAPPY CHIC

 

Linkages

COMPANY NAME

SIREN

LAST ACCOUNT PUBLISHED

TURNOVER

SA BRICE

-

-

-

 

Shareholder(s)

Name

HAPPYCHIC

Name of representative

GARBINO JEAN-CHRISTOPHE

Manager position

President

Date of birth

07/08/1969

Place of birth

AGEN

Type

Moral person

Name at birth

 

Director(s)

Name

M. CHABRERIE HERVÉ

Manager position

Managing director

Date of birth

29/05/1963

Place of birth

LE BLANC-MESNIL

Type

Individual

Name at birth

Name

M. ALLEGRI LUCA

Manager position

Managing director

Date of birth

16/04/1971

Place of birth

MILAN(ITALIE)

Type

Individual

Name at birth

 

Statutory Auditor

Name

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Name of representative

Manager position

Statutory auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

Name

M. NICOLAS YVES

Manager position

Deputy auditor

Date of birth

21/03/1955

Place of birth

LA VOULTE-SUR-RHÔNE

Type

Individual

Name at birth

 

Name

Mme. BAILLEUX NATHALIE

Manager position

Deputy auditor

Date of birth

11/07/1963

Place of birth

VALENCIENNES

Type

Individual

Name at birth

Name

BMD ASSOCIÉS

Name of representative

Manager position

Statutory auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

Previous Directors

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

President

HAPPYCHIC

06/04/1963 - LILLE

President

HAPPYCHIC

06/04/1963 - LILLE 59000

President

M. HYVERT PHILIPPE

-

President

M. HYVERT PHILIPPE

12/04/1962 - ST ETIENNE (42000)

Managing director

M. GUISLAIN PIERRE-YVES

22/05/1971 - LINSELLES

Managing director

M. GUISLAIN PIERRE-YVES

22/05/1971 - LINSELLES (59126)

Deputy auditor

Mme. BAILLEUX NATHALIE

11/07/1963 - VALENCIENNES (59300)

Deputy auditor

M. NICOLAS YVES

21/03/1955 - LA VOULTE-SUR-RHÔNE (07800)

 

Status history

No Status History

 

 

Recent publications in Gazettes

 

Publication date

Gazette Name

Description

22/02/2018

Bodacc B

Modification et mutation diverse

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

1449 - 305 154 262 RCS Lille Métropole. JULES. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Directeur général partant : Guislain, Pierre-Yves ; nomination du Directeur général : Chabrerie, Hervé ; nomination du Directeur général : Allegri, Lucas. Capital : 30990501 EUR. Activité : 
Adresse du siège social : 152 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix. 
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

02/02/2018

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Le Syndicat agricole


Date de décision : 18/12/2017
La société 305154262 - JULES, CTRE COMMERC 3 FONTAINES, 95000 CERGY 
Fait l'objet du départ de Monsieur Pierre-Yves GUISLAIN

02/02/2018

JAL

Appointment of the social representative

Le Syndicat agricole


Date de décision : 18/12/2017
Nominé : Non renseignée Luca ALLEGRl, 01210 FERNEY VOLTAIRE
En la fonction de : Directeur général

14/09/2017

Bodacc B

Modification et mutation diverse

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

1014 - 305 154 262 RCS Lille Métropole. JULES. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : modification du Président HAPPYCHIC représenté par , GARBINO Jean-Christophe Adresse : 86 rue Jean Jaurès 59420 Mouvaux. Capital : 30990501 EUR. Activité : 
Adresse du siège social : 152 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix. 
Commentaires : modification survenue sur le représentant permanent.

18/08/2017

JAL

Appointment of the social representative

Le Syndicat agricole


Date de décision : 30/06/2017
Nominé : Monsieur Jean-Christophe GARBINO, 59420 MOUVAUX
En la fonction de : Président

18/08/2017

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Le Syndicat agricole


Date de décision : 30/06/2017
La société 305154262 - JULES, CTRE COMMERC 3 FONTAINES, 95000 CERGY 
Fait l'objet du départ de Monsieur GAUTHIER WATRELOT

27/04/2017

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

4166 - 305154262 RCS. JULESForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 152 avenue Alfred Motte 59100 Roubaix. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2015.

18/01/2017

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

3549 - 305154262 RCS. JULESForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 152 avenue Alfred Motte 59100 Roubaix. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2014.

15/09/2016

Bodacc A

Vente et cession : Vendeur

76 - SEINE-MARITIME

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

1158 - 484 064 076 RCS Évry. B3J. Forme : Société à responsabilité limitée. Adresse : avenue de l'Europe, Centre Commercial Cora, 91300 Massy. 
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 125000 Euros. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : vente de prêt-à-porter masculin exploité sous l'enseigne JULES. Adresse : 21 rue des Martyrs, 76500 Elbeuf. 
Précédent propriétaire : JULES. 305 154 262 RCS Lille métropole. 
Date de commencement de l’activité : 31/08/2016. Oppositions : Me Jean-Marc SALLES, notaire, 80 rue des Martyrs 76500 Elbeuf. Descriptif : Acte notarié du 31/08/2016. Siège de l'ancien propriétaire : 152 avenue Alfred Motte 59100 Roubaix. Siège du nouveau propriétaire : avenue de l'Europe Centre commercial Cora 91300 Massy. Délai d'opposition : 10 jours à compter de la publicité au BODACC. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

18/05/2015

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

2401 - 305154262 RCS. JULESForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 152 avenue Alfred Motte 59100 Roubaix. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2013.

19/12/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

45 - LOIRET

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

227 - 305 154 262 RCS Lille Métropole. JULES. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 152 avenue Alfred Motté, 59100 Roubaix. 
Origine du fonds : Achat au prix stipulé de 206000,00 euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Vente de prêt à porter masculin. Adresse : 22 rue Dorée, 45200 Montargis. 
Précédent propriétaire : MODERN' TEXTIL. 835 550 286 RCS Orléans. 
A dater du : 24/12/1996. Date de commencement de l’activité : 31/10/2014. Publication légale : Le Journal de Gien du 13/11/2014. Oppositions : Maître Emmanuel collet 47 rue Gambetta 45200 Montargis pour la validité. Descriptif : Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale. Date d’effet : 31/10/2014.

19/12/2014

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

45 - LOIRET

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

226 - 305 154 262 RCS Orléans. JULES. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 30990501 EUR. Adresse : 152 avenue Alfred Motté, 59100 Roubaix. 
Origine du fonds : Achat au prix stipulé de 206000,00 euros. Etablissement : Etablissement principal. Activité : Un fonds de commerce de vente de prêt à porter masculin. Enseigne : Jules. Adresse : 22 rue Dorée, 45200 Montargis. 
Précédent propriétaire : MODERN' TEXTIL. 835 550 286 RCS Orléans. 
Date de commencement de l’activité : 31/10/2014. Publication légale : Le Journal de Gien du 13/11/2014. Oppositions : Me Emmanuel collet, notaire 47 rue Gambetta 45200 Montargis pour la validité. Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

13/11/2014

JAL

Activity or goodwill cession: Buyer

Journal de Gien (Le)


Date de décision : 31/10/2014 
Cédant : 835550286 - MODERN TEXTIL SARL, JULES, 35 B RUE JOUFFROY D'ABBANS, 75017 PARIS 17
Cessionnaire : 305154262 - JULES, JULES, 152 AV ALFRED MOTTE, 59100 ROUBAIX
Prix de vente : 206000 €
Date d’effet : 31/10/2014 

15/05/2014

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

4569 - 305154262 RCS. JULESForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 152 avenue Alfred Motte 59100 Roubaix. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2012.

08/07/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE

3602 - 305154262 RCS. JULESForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 152 avenue Alfred Motte 59100 Roubaix. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011.

11/10/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

591 - 305 154 262 RCS Roubaix / Tourcoing. JULES. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : modification du Président de la société Hyvert, Philippe, nomination du Président de la société : HAPPYCHIC représenté par WATRELOT Gauthier nom d'usage : ² Adresse : 35 rue du Trie 59510 Hem, nomination du Directeur général : Guislain, Pierre-Yves, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : BMD Associés, modification du Commissaire aux comptes suppléant De Reu, Benoit, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Bailleux, Nathalie. Capital : 30990501 EUR. Activité : 
Adresse du siège social : 152 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix. 
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

04/08/2012

JAL

Appointment of the social representative

Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord


Date de décision : 18/07/2012
Société faisant l'objet d'une nomination : 305154262 - JULES, 152 AV ALFRED MOTTE, 59100 ROUBAIX 
Nominé : 509508628 - HAPPY CHIC, 152 AV ALFRED MOTTE, 59100 ROUBAIX 
En la fonction de : Président
Nominé : Monsieur Pierre-Yves GUISLAIN, 59910 BONDUES
En la fonction de : Directeur général

04/08/2012

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord


Date de décision : 18/07/2012
La société 305154262 - JULES, 152 AV ALFRED MOTTE, 59100 ROUBAIX 
Fait l'objet du départ de Monsieur Philippe HYVERT, 
De Monsieur Benoît DE REU

25/11/2011

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

4370 - 305154262 RCS. JULESForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 152 avenue Alfred Motte 59100 Roubaix. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2010.

06/11/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1054 - 305 154 262 RCS Roubaix-Tourcoing. JULES. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président de la société : HYVERT Philippe Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit. Capital : 30990501 EUR. Activité : Commerce de gros et de détail ainsi que la fabrication de tous articles textiles. Adresse de l’établissement principal : 152 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix. 
Adresse du siège social : 152 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix. 
Commentaires : Augmentation de capital. Date de commencement de l’activité : 20/12/1995. Date d’effet : 30/06/2011.

31/07/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

420 - 305 154 262 RCS Valenciennes. JULES. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 152 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix. 
Origine du fonds : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 380.000,00 EUR. Etablissement : Etablissement secondaire. Activité : Vente de prêt à porter. Adresse : 21 et 23 place d'Armes, 59300 Valenciennes. 
Précédent propriétaire : XMF. 429 638 786 RCS Valenciennes. 
A dater du : 20/12/1996. Date de commencement de l’activité : 01/04/1996. Publication légale : LA GAZETTE DU NORD PAS DE CALAIS du 01/07/2011. Oppositions : Office Notarial de Me STREIFF Vivien, 10 place Verte à CONDE SUR L'ESCAUT. Descriptif : Inscription compl¿mentaire suite ¿ achat. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale. Date d’effet : 20/01/2010.

25/06/2011

JAL

Activity or goodwill cession

Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord


Date de décision : 20/01/2010 
Cédant : 429638786 - XMF, 5 RUE DU DUREMONT, ZI, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN
Cessionnaire : 305154262 - JULES, 152 AV ALFRED MOTTE, 59100 ROUBAIX
Prix de vente : 380000 €
Date d’effet : 20/01/2010 

22/05/2011

JAL

Proposed merger

Progrès (Le)/Edition du Rhône


Date de décision : 06/05/2011
Absorbant : 305154262 - JULES, 152 AV ALFRED MOTTE, 59100 ROUBAIX
Absorbé : 349222430 - MILAN, 27 RUE VICTOR HUGO, 69002 LYON 2EME
Date d'effet : 11/05/2011

13/03/2011

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

64 - PYRENEES-ATLANTIQUES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

783 - 305 154 262 RCS Roubaix. JULES. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 33546507.75 EUR. Adresse : 152 avenue Alfred Motté, 59100 Roubaix. 
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 520000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Vente de prêt à porter et accessoires pour hommes. Adresse : 22 et 24 rue Serviez, 64000 Pau. 
Précédent propriétaire : BRICE. 312 560 584 RCS Roubaix. 
Date de commencement de l’activité : 01/02/2011. Publication légale : Petites Affiches Béarnaises du 22/02/2011. Oppositions : Office notarial de Maître Philippe GIRAUD, notaire 18, boulevard des Pyrénées 64000 Pau. Descriptif : Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

02/03/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

2165 - 305 154 262 RCS Roubaix-Tourcoing. JULES. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président de la société : HYVERT Philippe Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit. Capital : 33619570.50 EUR. Activité : Commerce de gros et de détail ainsi que la fabrication de tous articles textiles. Adresse de l’établissement principal : 152 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix. 
Adresse du siège social : 152 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix. 
Commentaires : Augmentation de capital. Date de commencement de l’activité : 20/12/1995. Date d’effet : 08/09/2010.

22/02/2011

JAL

Activity or goodwill cession

Petites Affiches Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques (Les)


Date de décision : 01/02/2011 
Cédant : 312560584 - BRICE, BRICE, 152 AV ALFRED MOTTE, 59100 ROUBAIX
Cessionnaire : 305154262 - JULES, 152 AV ALFRED MOTTE, 59100 ROUBAIX
Prix de vente : 520000 €
Date d’effet : 01/02/2011 

19/02/2011

JAL

Modification of the share capital

Gazette Nord Pas de Calais/Edition du Nord


Date de décision : 08/09/2010
La société : 305154262 - JULES, 152 AV ALFRED MOTTE, 59100 ROUBAIX a subi une augmentation de son capital social désormais de 33 619 571 € 
Date d'effet : 08/09/2010

15/09/2010

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

33 - GIRONDE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

287 - 305 154 262 RCS Bordeaux. JULES. Forme : Société par actions simplifiée. Capital : 33546507.75 EUR. Adresse : 152 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix. 
Origine du fonds : Achat d'un fonds de commerce. Etablissement : Etablissement principal. Activité : vente de prêt à porter et accessoires (n'étant pas compris la cession de marchandises, la reprise de matériel, de mobilier de mobilier d'exploitation ou de stock, ne l'enseigne). Adresse : Centre Commercial Cap Océan, Carrefour Local N°28, 33260 la Teste-de-Buch. 
Précédent propriétaire : TB. L. 450 191 127 RCS Bordeaux. 
Date de commencement de l’activité : 01/01/0001. Publication légale : Les Echos Judiciaires Girondins du 13/08/2010. Oppositions : Au Mandataire Cabinet ALTA CONSEIL, Maître Catherine DESAGE, 1 impasse des Mûriers, 33700 Mérignac pour la validité et pour la correspondance. Descriptif : Fonds acquis par achat au prix stipul¿ de 350000 Euros. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

13/08/2010

JAL

Activity or goodwill cession

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS


Date de décision : 31/07/2010 
Cédant : 450191127 - T.B.L., FORMEN, CTRE COMMERCIAL CAP OCEAN, 33260 LA TESTE DE BUCH
Cessionnaire : 305154262 - JULES, 152 AV ALFRED MOTTE, 59100 ROUBAIX
Prix de vente : 350000 €

30/12/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

7592 - 305154262 RCS. JULESForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 152 avenue Alfred Motte 59100 Roubaix. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

30/12/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

7593 - 305154262 RCS. JULESForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 152 avenue Alfred Motte 59100 Roubaix. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

30/11/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

1335 - 305 154 262 RCS Roubaix-Tourcoing. JULES. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président de la société : HYVERT Philippe Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit. Capital : 33546507.75 EUR. Activité : Commerce de gros et de détail ainsi que la fabrication de tous articles textiles. Adresse de l’établissement principal : 152 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix. 
Adresse du siège social : 152 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix. 
Commentaires : Augmentation de capital. Date de commencement de l’activité : 20/12/1995. Date d’effet : 25/09/2009.

23/09/2009

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

01 - AIN

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE

16 - 305 154 262 RCS Roubaix. JULES. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 152 avenue Alfred Motté, 59100 Roubaix. 
Origine du fonds : acquis par achat au prix stipulé de 500000 Euros. Etablissement : Etablissement complémentaire. Activité : Vente de vêtements. Adresse : Leclerc Locaux 45 Et 46 Zone d'Activités Commerciales des Baterses Centre Commercial, 1700 Beynost. 
Précédent propriétaire : OVER SIDE. 337 852 594 RCS Bourg-en-Bresse. 
Date de commencement de l’activité : 16/03/2009. Publication légale : Voix de l'Ain du 10/04/2009. Oppositions : ME GILLES BEAUDOT 4, avenue Alsace Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse. Commentaires : Autre achat, apport, attribution.

15/05/2009

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

01 - AIN

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE

2 - 305 154 262 RCS Roubaix. JULES. Forme : Société par actions simplifiée. Adresse : 152 avenue Alfred Motté, 59100 Roubaix. 
Origine du fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 500000 Euros. Etablissement : Établissement principal. Activité : vente de jeans et vêtements sportwear pour hommes femmes et enfants. Adresse : Zone d'Activités Commerciales des Baterses Centre Commercial Leclerc Locaux 45 Et 46, 1700 Beynost. 
Précédent propriétaire : SOCIETE EN NOM COLLECTIF OVER-SIDE. 337 852 594 RCS Lyon. 
Date de commencement de l’activité : 16/03/2009. Publication légale : voix de l ain du 10/04/2009. Oppositions : etude de me BEAUDOT notaire avenue alsace lorraine 01000 Bourg en Bresse. Commentaires : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire).

02/12/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

692 - 305 154 262 RCS Roubaix-Tourcoing. JULES. Forme : Société par actions simplifiée. Administration : Président de la société : HYVERT Philippe. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : DE REU Benoit. Capital : 33453010 EUR. Activité : Commerce de gros et de détail ainsi que la fabrication de tous articles textiles. Adresse de l’établissement principal : 152 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix. 
Adresse du siège social : 152 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix. 
Commentaires : Augmentation de capital. Date de commencement de l’activité : 20/12/1995. Date d’effet : 25/09/2008.

27/07/2008

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

84 - VAUCLUSE

GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

3091 - 305 154 262 RCS Roubaix. JULES. Forme : S.A.S. Adresse : 152 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix. 
Origine du fonds : Fonds secondaire acquis par achat au prix stipulé de 285 000 euros. Etablissement : établissement principal. Activité : vente de chaussures de sport, vêtements de sport et accessoires s'y rapportant. Adresse : Centre Commercial Carrefour Orange - ZAC du Coudoulet Lieudit Costières du Coudoulet, 84100 Orange. 
Précédent propriétaire : VAUCLUSE SPORT DIFFUSION. 343 236 436 RCS Roubaix. 
Date de commencement de l’activité : 01/05/2008. Publication légale : Les Petites Affiches de Vaucluse du 24/06/2008. Oppositions : Maître Ruiz-Bernard Valérie notaire 16 avenue du Général Charles de Gaulles - 84150 Jonquières. Commentaires : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale.

23/07/2008

Bodacc A

Vente et cession : Acheteur

84 - VAUCLUSE

GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

1883 - 305 154 262 RCS Roubaix. JULES. Forme : S.A.S. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix, France. 
Origine du fonds : fonds principal acquis par achat, au prix stipulé de 285 000 euros. Activité : vente de chaussures de sport, vêtement de sport et accessoires s'y rapportant. Adresse : Centre Commercial Carrefour, Orange, ZAC du Coudoulet, lieudit, 84100 Orange, France. 
Précédent propriétaire : VAUCLUSE SPORT DIFFUSION SARL. 343 236 436 RCS Carpentras. 
Date de commencement de l’activité : 01/05/2008. Publication légale : PAV du 24/06/2008. Oppositions : Maître RUIZ (Bernard), notaire à Jonquières, 84150, 16, avenue du Général-de-Gaulle. Commentaires : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation.

12/03/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

59 - NORD

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

6639 - 305154262 RCS. JULESForme : Société par actions simplifiée. Adresse : 152 avenue Alfred Motte 59100 Roubaix. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2006.

02/11/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1913 - Ancienne situation du siège social : RCS Roubaix-Tourcoing B 305 154 262. RC 96-B 259. JULES. Forme : S.A.S. Capital : 33 397 881,25 euros. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Administration : nouveau président : HYVERT (Philippe). Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : DE REU (Benoît). Ancien président : MULLIEZ (Marc). Nouvelle situation du siège social - Capital : 33 426 947 euros. Etablissement principal - Activité : vente en gros ou au détail et fabrication de tous articles textiles. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Date d'effet : 28 septembre 2007.

21/09/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

884 - Ancienne situation du siège social : RCS Roubaix-Tourcoing B 305 154 262. RC 96-B 259. JULES. Forme : S.A.S. Capital : 33 127 697 euros. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Nouvelle situation du siège social - Capital : 33 397 881 euros. Etablissement principal - Activité : vente en gros ou au détail et fabrication de tous articles textiles. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Date d'effet : 20 juillet 2007.

07/06/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1030 - RCS Roubaix-Tourcoing B 305 154 262. RC 96-B 259. JULES. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte,, 59100 Administration : président : MULLIEZ (Marc). Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : DE REU (Benoît). Ancienne administration : ancien commissaire aux comptes titulaire : MONFRAIX (Paul). Ancien commissaire aux comptes suppléant : S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Etablissement principal - Activité : vente en gros ou au détail et fabrication de tous articles textiles. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Date d'effet : 19 mars 2007.

03/05/2007

Bodacc A

Vente et cession

0237 - RCS Roubaix-Tourcoing 305 154 262. JULES. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix. Etablissement secondaire - RC 07-B 76. A dater du : 26 mars 2007. Enseigne : Jules. Activité : vente au détail d'habillement, de prêt-à-porter masculin et d'accessoires. Adresse : centre commercial Leclerc, La Coulebart, 22100 Léhon. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 350 000 euros. Date de début d'activité : 1er mars 2007. Précédent propriétaire : NDYC. RCS Dinan 403 920 275. RC 96-B 13. Publication légale : Le Courrier indépendant du 8 mars 2007. Oppositions : Me Ledan (Pascal), notaire, 1 place du Martray, 22650 Ploubalay.

09/11/2006

Bodacc A

Vente et cession

0151 - RCS B 305 154 262. RC AP-B 60344. JULES. Forme : S.A.S. Capital : 32 127 419 euros. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix. Etablissement principal - Activité : bail commercial d'un local sis centre commercial Rives-d'Arcins, 33130 Bègles. Adresse : centre commercial Rives-d'Arcins, 33130 Bègles. Droit au bail, dépendant de l'établissement principal, acquis par cession au prix stipulé de 1 170 000 euros. Date d'effet : 1er octobre 2006. Précédent propriétaire : MER ET ESPACE S.A. RCS 412 904 971. Publication légale : Le Résistant de Libourne du 2 novembre 2006. Oppositions : Me Romain, 213 rue du Jardin-Public, 33000 Bordeaux, pour la validité et la correspondance.

05/10/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

2905 - RCS Roubaix-Tourcoing B 305 154 262. RC 96-B 259. JULES. Forme: SAS . Adresse du siège social: 152, avenue Alfred Motte,59100 Roubaix. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

18/08/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1181 - Ancienne situation du siège social : RCS Roubaix-Tourcoing B 305 154 262. RC 96-B 259. JULES. Forme : S.A.S. Capital : 32 716 435 euros. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Nouvelle situation du siège social - Capital : 33 127 697 euros. Etablissement principal - Activité : vente en gros ou au détail et fabrication de tous articles textiles. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Date d'effet : 17 juillet 2006.

17/03/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

2056 - RCS Roubaix-Tourcoing B 305 154 262. RC 96-B 259. JULES. Forme: SAS . Adresse du siège social: 152, avenue Alfred Motte,59100 Roubaix. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

10/11/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

633 - Ancienne situation du siège social : RCS Roubaix-Tourcoing B 305 154 262. RC 96-B 259. JULES. Forme : S.A.S. Capital : 32 127 419 euros. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Nouvelle situation du siège social - Capital : 32 716 435 euros. Etablissement principal - Activité : vente en gros ou au détail et fabrication de tous articles textiles. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Date d'effet : 23 septembre 2005.

29/09/2005

Bodacc A

Vente et cession

1006 - RCS Roubaix B 305 154 262. JULES. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix. Etablissement secondaire - Enseigne : Alain Manoukian. Activité : prêt-à-porter, vêtements pour hommes ou femmes et accessoires s'y rattachant. Adresse : 57 rue du Sauvage, 68100 Mulhouse. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 990 000 euros. Date de début d'activité : 8 août 2005. Précédent propriétaire exploitant : ALAIN MANOUKIAN. RCS Romans 437 380 306. Publication légale : Les Petites affiches du Haut-Rhin du 4 septembre 2005. Oppositions : Me Fritsch (Hubert), notaire, 36 rue de la Sinne, 68100 Mulhouse.

21/09/2005

Bodacc A

Vente et cession

336 - RCS 305 154 262. A dater du : 24 décembre 1998. RC 98-B 01210. JULES. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix. Etablissement secondaire - Activité : prêt-à-porter pour hommes et accessoires. Adresse : centre commercial Géant, B.P. 300, 38400 Saint-Martin-d'Hères. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 366 000 euros. Date de début d'activité : 3 septembre 2005. Précédent propriétaire : SOMATEX. RCS Grenoble 400 083 812. Publication légale : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 29 juillet 2005. Oppositions : Me Dugueyt, 23 rue des Glairons, 38400 Saint-Martin-d'Hères.

09/08/2005

Bodacc A

Vente et cession

307 - RCS Grenoble B 305 154 262. JULES. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 152, avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix. Etablissement secondaire - Activité : prêt-à-porter masculin. Adresse : centre commercial Geant, 38400 Saint-Martin-D'heres. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 366 000 euros . Date d'effet : 18 juillet 2005. Précédent propriétaire : SOMATEX. RCS 400 083 812. Publication légale : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 29 juillet 2005 . Oppositions : Me Robert Dugueyt, 23 rue des Glairons, 38400 Saint-Martin-d'Heres.

01/04/2005

Bodacc A

Vente et cession

901 - RCS Roubaix B 305 154 262. JULES. Forme : S.A.S. Capital : 32 127 419 euros. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix. Etablissement secondaire - Activité : droit au bail des locaux commerciaux. Adresse : centre commercial Cité Europe, niveau 1, 62231 Coquelles. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 450 000 euros. Date de début d'activité : 17 février 2005. Précédent propriétaire : S.A. CALL. RCS Bobigny 351 749 742. Publication légale : La Gazette de la région Nord Pas-de-Calais du 5 mars 2005. Oppositions : S.C.P. Louf Deslyper Lestoille, notaires, 99 boulevard Jacquard, 62100 Calais.

23/01/2005

Bodacc A

Vente et cession

2060 - RCS Créteil B 305 154 262. RC AP-B 40387. JULES. Forme : S.A.S. Capital : 32 127 419 euros. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix. Etablissement principal - Activité : vente de prêt-à-porter, de vêtements pour hommes et juniors. Adresse : centre commercial Créteil Soleil, local no 1920, niveau no 1, 94000 Créteil. Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 950 000 euros. Date d'effet : 14 septembre 2004. Précédent propriétaire : MEN'S S.A.S. Publication légale : Les Petites affiches du 6 janvier 2005. Oppositions : Me Lelong (Nicole), 4 rue Maurice-Tenine, 94260 Fresnes, pour la validité et la correspondance.

21/01/2005

Bodacc A

Vente et cession

1045 - RCS B 305 154 262. RC 97-B 164. JULES. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix. Etablissement secondaire - Activité : prêt-à-porter, vêtements pour hommes et juniors. Adresse : centre commercial régional Créteil Soleil, local no 1920, niveau 1, 94000 Créteil. Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 950 000 euros. Date de début d'activité : 14 septembre 2004. Précédent propriétaire : MEN'S. RCS 312 560 584. Publication légale : Les Petites affiches du 6 janvier 2005. Oppositions : Me Lelong (Nicole), 4 rue Maurice-Tenine, 94260 Fresnes, pour la validité et la correspondance.

03/10/2004

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix-Tourcoing B 305154262 JULES. Forme : S.A.S. Capital : 32 127 419 euros. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix-Tourcoing ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Enseigne : Aglaé. Activité : vente de tous textiles, de vetements dégriffés, de lingerie, d' accessoires et d'articles de Paris. Adresse : 21-23 rue de Bras, 14000 Caen Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 686 000 euros Date de début d'activité: 1 e r aout 2004. Précédent propriétaire : S.A.R.L. AGLAE. RCS Rennes 349271429 Publication légale: L'Agriculteur normand du 9 septembre 2004. Oppositions : M e Beaufils (Jean-Paul), huissier de justice associé, 42 rue Demolombe, 14000 Caen.

08/09/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 305154262 RC 96-B 259 JULES. Forme : S.A.S. Capital : 31 815 282 euros. Adresse : 152 avenue Alfred- Motte, 59100 Roubaix Nouvelle situation du siège social. Capital : 32 127 419 euros Etablissement principal: Activité : vente en gros ou au détail et fabrication de tous articles textiles. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix. Date d'effet : 29 juillet 2004.

20/04/2004

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 305154262 RC 04-B 86 JULES. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59051 Roubaix ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente de pret-à-porter pour hommes et d' accessoires. Adresse : 44 boulevard de la République, 47000 Agen Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 413 500 euros Date de début d'activité: 15 mars 2004. Précédent propriétaire : SAPP. RCS B 414586271 Publication légale: La Dépeche du Midi du 5 mars 2004. Oppositions : S.C.P. Samarut Sempol, notaires, 2 ter place du Docteur-Esquirol, 47000 Agen.

20/04/2004

Bodacc A

Création d'établissement

RCS 305154262 S.A.S. JULES. Forme : S.A.S. Capital : 31 505 890 euros. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix Etablissement principal: Activité : vente d'articles de pret-à- porter. Adresse : 44 boulevard de la République et 33 rue Garonne, 47000 Agen Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 413 500 euros Date de début d'activité: 15 février 2004. Précédent propriétaire : S.A.R.L. S. A.P.P. RCS Agen 414586271 Publication légale: La Dépeche du Midi du 5 mars 2004. Oppositions : M e Sempol (Jean, Philippe), notaire, 2 bis place du Docteur-Esquirol, 47000 Agen.

10/12/2003

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix 305154262 JULES. Forme : S.A. S. Capital : 215 000 euros. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : droit au bail commercial portant sur le local n° 17 d'une surface d'environ 156 m 2 sis au rez-de- chaussée haut du centre commercial Carrefour Centre Sud. Adresse : 257 avenue Georges-Durand, 72000 Le Mans Droit au bail, dépendant de l' établissement secondaire, acquis par achat au prix stipulé de 215 000 euros Date de début d'activité: 1 e r novembre 2003. Précédent propriétaire : SOCIETE PORTEBOEUF. RCS Le Mans 576450142 Publication légale: Ouest France du 12 novembre 2003. Oppositions : Etude de M e Draunet, huissier de justice, 10 place Gustave-Langevin, 72000 Le Mans.

26/09/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 305154262 RC 96-B 259 JULES. Forme : S.A.S. Capital : 31 505 890 euros. Adresse : 152 avenue Alfred- Motte, 59100 Roubaix Nouvelle situation du siège social. Capital : 31 815 282 euros Etablissement principal: Activité : vente en gros ou au détail et fabrication de tous articles textiles. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix. Date d'effet : 12 aout 2003.

02/07/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Roubaix-Tourcoing B 305154262 RC 96- B 259 JULES. Forme : S.A.S. Capital : 31 505 890 euros. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix. Administration : commissaire aux comptes titulaire : MONFRAIX (Paul). Commissaire aux comptes suppléant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Ancien commissaire aux comptes suppléant : LIPOVAC (Yvan) Etablissement principal: Activité : vente en gros et au détail, ainsi que la fabrication de tous articles textiles. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix. Date d'effet : 6 mai 2003.

15/01/2003

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Rennes B 305154262 A dater du: 22 octobre 2002 RC 02-B 1092 JULES. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Mott, 59100 Roubaix ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente d'articles textiles pour hommes. Adresse : centre commercial Opéra, local n° 35, 35740 Pacé Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 205 806 euros Date de début d'activité: 20 décembre 1995. Date d'effet : 1 e r septembre 2002. Précédent propriétaire : S.A.R.L. DEFIVET Publication légale: Le Paysan breton du 20 septembre 2002. Oppositions : M e Jeunet, 14 boulevard Domaine-de-la- Josserie, 35741 Pacé.

20/10/2002

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix-Tourcoing B 305154262 JULES. Forme : S.A.S. Capital : 31 505 890 euros. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix. Administration : président : MULLIEZ ( Marc) ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Enseigne : Formen. Activité : vetements, chaussures et colifichets. Adresse : Z.A.C. de la Giraudais, centre commercial Opéra, local n° 35, 35740 Pacé Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 205 806 euros. Date d'effet : 9 septembre 2002. Précédent propriétaire : DEFIVET S.A.R.L. RCS Rennes B 385219910 Publication légale: Le Paysan breton du 20 septembre 2002. Oppositions : M e Jeunet (Jean-Pierre), notaire, Centre juridique, 14 boulevard Patrice-Dumaine- de-la-Josserie, Pacé.

02/10/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Evry B 305154262 RC 96-B 2510 JULES. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : pret- à-porter pour hommes et accessoires. Adresse : Centre commercial, local n° 135, niveau n° 84, 91000 Evry Etablissement secondaire acquis par achat Date de début d'activité: 1 e r mai 2002 Date du premier avis publié au BODACC: 6 juin 2002.

27/09/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 305154262 RC 96-B 259 JULES. Forme : S.A.S. Capital : 31 390 600 euros. Adresse : 152 avenue Alfred- Motte, 59100 Roubaix Nouvelle situation du siège social. Capital : 31 505 890 euros Etablissement principal: Activité : vente en gros et au détail, ainsi que la fabrication de tous articles textiles. Adresse : 152 avenue Alfred- Motte, 59100 Roubaix. Date d'effet : 15 juillet 2002.

06/06/2002

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 305154262 RC AP-B 660 JULES. Forme : S.A.S. Capital : 31 390 600 euros. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred- Motte, 59100 Roubaix Etablissement principal: Activité : vente au détail d' articles chaussants, d'accessoires et de bonneterie. Adresse : centre commercial Evry 2, 91000 Evry Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 762 245,09 euros. Date d'effet : 30 avril 2002. Précédent propriétaire : K.C.P. MYRYS S.A. RCS 417594777 Publication légale: La Semaine de l'Ile-de-France du 14 mai 2002. Oppositions : M e Level (P.), immeuble Le Mazière, rue des Mazières, 91000 Evry, pour la validité et la correspondance.

02/06/2002

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Rodez B 305154262 RC 02-B 123 JULES. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : pret- à-porter pour hommes et accessoires. Adresse : 20 rue Neuve, 12000 Rodez Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 518 326,66 euros Date de début d'activité: 1 e r février 2002. Précédent propriétaire : S.A. R.L. S.T.N. RCS B 393991260 Publication légale: La Dépeche du Midi du 3 février 2002. Oppositions : M e Galtier (Daniel), notaire, 7 place de la Cité, 12000 Rodez.

17/04/2002

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 305154262 JULES. Forme : S.A.S. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix ETABLISSEMENT SECONDAIRE. RCS Rodez 305 154 262. A dater du : 29 mars 2002. Activité : vente de pret-à-porter masculin ou féminin et en cuirs, de chaussures et d'accessoires retouches et confection. Adresse : 20-20 bis rue Neuve, 12000 Rodez Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 518 326,66 euros. Date d'effet : 1 e r février 2002. Précédent propriétaire : S.A.R.L. S.T.N. RCS Rodez B 393991260 RC 94-B 61 Publication légale: La Dépeche du Midi du 3 février 2002. Oppositions : M e Galtier (Daniel), notaire, 7 place de la Cité, 12000 Rodez.

03/03/2002

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 305154262 RC 96-B 259 JULES. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 29 084 269,24 euros. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix. Administration : commissaire aux comptes titulaire : MONFRAIX (Paul). Commissaire aux comptes suppléant : LIPOVAC (Yvan). Anciens administrateurs : MULLIEZ (Jean) MULLIEZ (Gonzague) THOMAS (Guy). Ancien président du conseil d' administration : MULLIEZ (Marc) Nouvelle situation du siège social. Forme : S.A.S. Capital : 31 390 600 euros Etablissement principal: Activité : fabrication, vente en gros et au détail de tous articles textiles. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix. Date d'effet : 23 novembre 2001.

04/09/2001

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix B 429638786 A dater du: 17 aout 2001 X.M.F. Forme : S.A.S. Capital : 2 000 000 euros. Adresse du siège social : Z.I., 59960 Neuville-en-Ferrain Etablissement principal: Activité : pret- à-porter, vetements pour hommes et accessoires. Adresse : Z.I., 59960 Neuville-en-Ferrain ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Enseigne : Jules. Activité : pret-à-porter, vetements pour hommes et accessoires. Adresse : galerie marchande du centre commercial Auchan, Semecourt, local n° 51, 57280 Semecourt Etablissements principale et secondaire acquis par achat au prix stipulé de 1 900 000 F. Date d'effet : 1 e r aout 2001. Précédent propriétaire : JULES. RCS Roubaix B 305154262 RC 98-B 562 Publication légale: Les Affiches moniteur des soumissions du 10 aout 2001. Oppositions : M e Lombardi, 10 rue Henri-Maret, 57000 Metz.

14/06/2001

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 305154262 RC 96-B 259 JULES. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 160 780 300 F. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix Nouvelle situation du siège social. Capital : 190 780 300 F Etablissement principal: Activité : commerce en gros ou au détail et fabrication de tous articles textiles. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix. Commentaires : augmentation du capital et conversion en euros. Date d'effet : 30 décembre 2000.

08/05/2001

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix-Tourcoing B 305154262 JULES. Forme : S.A. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, B.P. 565, 59060 Roubaix ETABLISSEMENT SECONDAIRE. RCS Valence RC 01-B 72. Enseigne : Jules. Activité : vente d'articles textiles pour hommes. Adresse : 54 rue Prenne- Julien, 26200 Montélimar Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 2 000 000 de F Date de début d'activité: 2 janvier 2001. Précédent propriétaire : MENEROUD Jean S.A.R.L. MEN' VET. RCS 417627361 Publication légale: Le Dauphiné libéré du 26 décembre 2000. Oppositions : Etude de Mes Flandin et Roux, notaires associés, 3 rue du Général-Chareton, 26200 Montélimar.

09/03/2001

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix B 305154262 A dater du: 20 février 2001 JULES. Forme : S.A. Capital : 190 780 300 F. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Enseigne : City. Activité : vente de pret-à-porter pour femmes, hommes et enfants. Adresse : galerie du centre commercial Atlantis, 44800 Saint-Herblain Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 3 500 000 F. Date d'effet : 1er février 2001. Précédent propriétaire : C.Q.F.D. RCS Nantes B 351388269 Publication légale: L'Informateur judiciaire du 9 février 2001. Oppositions : Me Pinson (Jean), 22 rue des Halles, Nantes.

09/03/2001

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix B 305154262 A dater du: 20 février 2001 JULES. Forme : S.A. Capital : 190 780 300 F. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Enseigne : Old River. Activité : vente de pret-à-porter pour femmes, hommes et enfants. Adresse : galerie du centre commercial Atlantis, 44800 Saint-Herblain Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 3 500 000 F. Date d'effet : 1er février 2001. Précédent propriétaire : S.A.R.L. HERBLAND. RCS Nantes B 351360581 Publication légale: L' Informateur judiciaire du 9 février 2001. Oppositions : Me Pinson (Jean), 22 rue des Halles, Nantes.

30/01/2001

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix-Tourcoing B 305154262 S.A. JULES. Forme : S.A. Adresse du siège social : 54 rue Pierre-Julien, 26200 Montélimar Etablissement principal: Activité : vente de vetements. Adresse : 54 rue Pierre-Julien, 26200 Montélimar Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 2 000 000 de F. Date d'effet : 2 janvier 2001. Précédent propriétaire : MENEROUD Jean ,conjoint RIVIER (Françoise). RCS Valence A 321595217 RC 81-A 65 Publication légale: Le Dauphiné libéré du 26 décembre 2000. Oppositions : S.C.P. Flandin Roux, 3 rue du Général-Chareton, B.P. 1, 26201 Montélimar Cedex.

24/10/2000

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Bordeaux B 305154262 RC AP-B 00399 JULES. Forme : S.A. Capital : 160 780 300 F. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix Etablissement principal: Activité : vente de pret-à-porter masculin et d' accessoires. Adresse : centre commercial Ouest, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Etablissement principal acquis par cession au prix stipulé de 1 150 000 F. Date d'effet : 16 aout 2000. Précédent propriétaire : HORIZON 2. RCS B 353724511 Publication légale: Les Echos judiciaires girondins du 15 aout 2000. Oppositions : Me Adréano (Martial), 10 cours de Gourgue, 33000 Bordeaux.

17/08/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 305154262 RC 96-B 259 CAMAIEU HOMME. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 160 780 300 F. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix Nouvelle situation du siège social dénomination: JULES Etablissement principal: Activité : vente en gros et au détail ainsi que la fabrication de tous articles textiles. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix. Date d'effet : 1er juillet 2000.

22/06/2000

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Créteil B 305154262 CAMAIEU HOMME. Forme : S.A. Capital : 160780300 F. Adresse du siège social : 152, avenue Alfred- Motte 59100 Roubaix Etablissement principal: Activité : droit au bail. Adresse : centre commercial régional Créteil-Soleil 94000 Créteil Droit au bail acquis par achat au prix stipulé de 10 000 000 de F. Date d'effet : 3 mai 2000. Précédent propriétaire : PIER IMPORT EUROPE. RCS B 702013921 Publication légale: La Loi du 10 mai 2000. Oppositions : au bail : centre commercial régional Créteil-Soleil, 94000 Créteil et pour la correspondance M e Attal Jean-Michel, 2, avenue Hoche, 75008 Paris.

02/06/2000

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 305154262 RC 99-B 00116 CAMAIEU HOMME. Forme : S.A. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : pret-à-porter. Adresse : 21 rue des Granges, 25 - Besançon Droit au bail dépendant de l'établissement secondaire, acquis par achat au prix stipulé de 2 950 000 F. Précédent propriétaire : JOLY Yvette. Oppositions : au siège de la société.

30/04/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 305154262 RC 96-B 259 CAMAIEU HOMME. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 120 780 300 F. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix Nouvelle situation du siège social. Capital : 160 780 300 F Etablissement principal: Activité : commerce en gros ou au détail et fabrication de tous articles textiles. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix. Date d'effet : 31 décembre 1999.

07/04/2000

Bodacc A

Vente et cession

RCS non encore inscrit. CAMAIEU HOMME. Forme : S.A. Capital : 120 780 300 F. Adresse du siège social : 152 avenue Motte, 59100 Roubaix Etablissement principal: Activité : droit au bail. Adresse : Z.A.C. de Venette, emplacements nos 39 et 40, 6 avenue de l'Europe, 60200 Venette Droit au bail pour le temps qui en reste à courir acquis moyennant le prix de 3 500 000 F. Date d'effet : 24 février 2000. Précédent propriétaire : BRUNE. RCS Compiègne B 380884056 RC 91-B 46 Publication légale: Picardie-la gazette du 15 mars 2000. Oppositions : Fidal, Z.A.C. de Mercières, rue du Fonds-Pernant, 60200 Compiègne et ce par voie d'huissier.

31/03/2000

Bodacc A

Création d'établissement

RCS 305154262 RC 98-B 1210 CAMAIEU HOMME. Forme : S.A. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Grenoble 98-B 1210. A dater du : 24 décembre 1998. Activité : vente au détail de pret-à-porter masculin. Adresse : 10 rue de la Poste, 38000 Grenoble Cette société, précédemment locataire-gérante, acquiert par achat un établissement secondaire au prix stipulé de 2 500 000 F. Date d'effet : 1er février 2000. Précédent propriétaire : S.A.R.L. TEXTILES CREATIONS. RCS Grenoble 055502728 Publication légale: Les Affiches de Grenoble du 25 février 2000. Oppositions : Me Fonti, notaire associé, 6 rue Denfert-Rochereau, 38000 Grenoble.

17/03/2000

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix-Tourcoing B 305154262 CAMAIEU HOMME. Forme : S.A. Capital : 120 780 300 F. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente d'articles textiles, de vetements, de confection pour hommes, femmes et enfants. Adresse : 23-25 rue Gambetta, 86000 Poitiers Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 6 900 000 F. Date d'effet : 21 octobre 1999. Précédent propriétaire : S.A.R.L. L.Y.D.H. RCS Poitiers B 353938012 Publication légale: Le Courrier français du 29 octobre 1999. Oppositions : Me Allain, notaire, 27 rue de la Marne, 86000 Poitiers.

24/04/1999

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix-Tourcoing B 305 154 262 CAMA¥EU HOMME. Forme : S.A. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte 59100 Roubaix ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Besançon 99-B 116. A dater du : 16 mars 1999. Enseigne : Camaieu Homme. Activité : achat, vente, négoce, commercialisation, distribution, représentation, fabrication de tous produits, d'articles d'habillement et de confection. Adresse : Centre commercial, rue de Chatillon 25480 Ecole-Valentin Etablissement secondaire acquis par fusion-absorption au montant évalué à 237 463,98 F Date de début d' activité: 30 décembre 1998. Précédent propriétaire : CAM ADAM RC 94-B 239 Publication légale: La Gazette du 30 janvier 1999 déclaration de créances: au tribunal de commerce de Roubaix- Tourcoing.

11/04/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Roubaix-Tourcoing B 305 154 262 RC 96-B 259 CAMAIEU HOMME. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 120 780 300 F. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte 59100 Roubaix Etablissement principal: Activité : commerce en gros et au détail, ainsi que fabrication de tous articles textiles. Adresse : 152 avenue Alfred- Motte 59100 Roubaix. Commentaires : fusion-absorption de la STE CAM ADAM. Date d'effet : 30 décembre 1998.

10/11/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix B 305 154 262 A dater du: 16 septembre 1998 CAMAIEU HOMME. Forme : S.A. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix Fonds secondaire acquis par achat dans le cadre d'une liquidation judiciaire, au prix stipulé de 1 264 450 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Metz 98-B 562. Activité : articles textiles hommes. Adresse : centre commercial Auchan, 57280 Semecourt Date de début d' activité: 1er novembre 1997 Précédente propriétaire PRENATAL. RCS B 380 022 459 RC 91-B 890 Publication légale: Les Affiches Moniteur des Soumissions du 5 février 1997.

25/08/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix-Tourcoing B 305 154 262 CAMAIEU HOMME. Forme : S.A. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Avignon 97-B 39. Adresse : 17 place du Change, 84000 Avignon Fonds complémentaire acquis par achat au prix stipulé de 835 840 F Etablissement Complémentaire. Activité : articles textiles hommes. Adresse : centre commercial Avignon-Nord, 84130 Le Pontet. Date d'effet : 1er novembre 1997 Précédente propriétaire SODISPER. RCS B 343 443 875 Publication légale: La Gazette provençale du 3 décembre 1997. Oppositions : Me Mandin, représentant des créanciers, 23 rue Victor-Hugo à Pontoise (95).

10/05/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix B 305 154 262 CAMAIEU HOMME. Forme : S.A. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix Fonds secondaire acquis par fusion- absorption au montant évalué à 288 341, 90 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Enseigne : Camaieu Homme. Activité : vente de pret-à -porter. Adresse : centre commercial Le Polygone, 34000 Montpellier. Date d'effet : 30 décembre 1997 Précédente propriétaire S.A.R.L. MONTPEFER. RCS Montpellier B 344 754 254 RC 88-B 473 Publication légale: L'Hérault judiciaire et commercial du 27 novembre 1997.

16/04/1998

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix B 305 154 262 CAMAIEU HOMME. Forme : S.A. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix Fonds secondaire acquis par fusion- absorption au montant évalué à 52 147, 98 F net négatif ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Sète 98-B 72. Enseigne : Camaieu Homme. Activité : vente en France et dans tous pays de tous articles textiles homme. Adresse : 19 rue Gambetta, 34200 Sète Date de début d' activité: 30 décembre 1997 Précédente propriétaire CAMAIEU. RCS B 712 680 255 RC 71-B 25 Publication légale: L' Hérault judiciaire et commercial du 27 novembre 1997 déclaration de créances: au greffe du tribunal de commerce de Roubaix.

27/03/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS o. RCS Roubaix-Tourcoing B 305 154 262 RC RC 96-B 259 CAMAIEU HOMME. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 120 780 300 F. Adresse du siège social : 152, avenue Alfred-Motte 59100 Roubaix. Commentaires : fusion-absorption des sociétés suivantes : CAMAIEU,. RCS B 712 680 255 et MONTPEFER,. RCS B 344 754 254 Etablissement principal: Activité : commerce en gros et au détail, ainsi que la fabrication de tous articles textiles. Adresse : 152, avenue Alfred- Motte 59100 Roubaix Date de début d' activité: 20 décembre 1995. Date d'effet : 1er janvier 1997.

01/10/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix B 305 154 262 S.A. CAMAIEU HOMME. Forme : S.A. Capital : 120 780 300 F. Adresse du siège social : 152 avenue Motte, 59100 Roubaix Etablissement principal: Adresse : 152 avenue Motte, 59100 Roubaix Fonds secondaire acquis par achat, au prix stipulé de 1 294 340 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Enseigne : Camaieu Hommes. Activité : pret-à-porter masculin. Adresse : 70 rue du Maréchal- Foch, 65000 Tarbes. Date d'effet : 1er aout 1997 Précédente propriétaire- exploitante PASSY. RCS Tarbes B 398 374 793 RC 94-B 231 Publication légale: La Dépeche du Midi du 16 aout 1997. Oppositions : S.C.P. Blanc, Carnejac, Toulouse, notaires associés, 7 place Jean-Jaurès, 65000 Tarbes.

13/07/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS *. RCS Brive B 305 154 262 RC RC 97- B 110 CAMAIEU HOMME. Forme : S.A. Adresse du siège social : 152, avenue Alfred- Motte 59100 Roubaix Etablissement principal: Activité : vente de tous articles textiles pour hommes. Adresse : centre commercial Continent 19100 Brive Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 1 200 000 F Date de début d'activité: 1er avril 1997. Précédent propriétaire : : ELIJO. RCS RCS B 389 376 294 Publication légale: La Montagne du 12 avril 1997. Oppositions : Me Coussirat, 52, boulevard Koenig, 19100 Brive.

14/06/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix B 305 154 262 A dater du: 31 décembre 1996 CAMAIEU HOMME. Forme : S. A. Adresse du siège social : 152, avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente de tous articles textiles pour homme en France et dans tous pays. Enseigne : Camaieu. Adresse : 17, rue des Clefs, 68000 Colmar Fonds secondaire acquis par apport au montant évalué à 286 958 868 F Date de début d'activité: 1er avril 1996 Précédente propriétaire CAMAIEU INTERNATIONAL. RCS Roubaix B 345 086 177 Publication légale: La Gazette du 8 mai 1996 déclaration de créances: au tribunal de commerce de Roubaix- Tourcoing.

08/04/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix B 305 154 262 A dater du: 14 janvier 1997 CAMAIEU HOMME. Forme : S. A. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix Fonds secondaire acquis par apport au montant global évalué à 112 171 841 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Annecy 97-B 29. Activité : vente d'articles textiles masculins. Adresse : centre commercial Annecy-Epagny, lot 36, 74330 Epagny. Date d'effet : 1er avril 1996 Précédente propriétaire CAMAIEU INTERNATIONAL. RCS B 345 086 177 RC 93-B 483 Publication légale: La Gazette du 11 mai 1996.

02/04/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix B 305 154 262 A dater du: 17 février 1997 CAMAIEU HOMME. Forme : S. A. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix Fonds secondaire acquis par fusion-absorption au montant évalué à 207 070,46 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Alençon 97- B 17. Enseigne : Camaieu Homme. Activité : vente en France et dans tous pays de tous articles textiles homme. Adresse : route de Rennes, centre commercial Continent, Condé-sur-Sarthe 61250 Damigni Date de début d'activité: 30 décembre 1996 Précédente propriétaire S. A.R.L. CAP 61. RCS Alençon B 392 751 251 Publication légale: Ouest-France du 29 novembre 1996 déclaration de créances: au greffe du tribunal de commerce d' Alençon.

25/03/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix B 305 154 262 A dater du: 27 janvier 1997 CAMAIEU HOMME. Forme : S. A. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix Fonds secondaire acquis par apport au montant évalué à 174 787 027 F ETABLISSEMENT SECONDAIRE RC Carpentras 97-B 23. Enseigne : Camaieu. Activité : vente en France et dans tous pays de tous articles textiles pour homme. Adresse : 16 place Clemenceau, 84100 Orange Date de début d'activité: 1er avril 1996 Précédente propriétaire CAMAIEU INTERNATIONAL. RCS Carpentras B 345 086 177 RC 93-B 131 Publication légale: La Gazette Nord du 8 mai 1996 déclaration de créances: au greffe de tribunal de grande instance de Carpentras.

23/03/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 305 154 262 RC 97-B 00046 CAMAIEU HOMME S.A. Forme : S.A. Capital : . Adresse du siège social : 152 avenue Alfred- Motte 59100 Roubaix ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente, en France et dans tous pays, de tous articles textiles pour hommes. Adresse : centre commercial Le Merlan, lots n°s 7 et 8 13014 Marseille Etablissement secondaire acquis par apport au montant global évalué à 12 171 841 F Date de début d'activité: 1er janvier 1997. Précédent propriétaire : CAMAIEU INTERNATIONAL. RCS B 345 086 177 Publication légale: La Gazette du Palais du 11 mai 1996.

23/03/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS B 305 154 262 RC 97-B 00056 CAMAIEU HOMME. Forme : S.A. Capital : 120 780 300 F. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte 59100 Roubaix Etablissement principal: Adresse : centre commercial Mantes-Buchelay, lot n° 17 78200 Buchelay. Activité : vente, en France et dans tous pays, de tous articles textiles sous toute forme, pour hommes ETABLISSEMENT SECONDAIRE. Activité : vente, en France et dans tous pays, de tous articles textiles pour hommes. Adresse : Centre commercial, lot n° 17 78410 Flins-sur-Seine Etablissement secondaire acquis par apport au montant global évalué à 112 171 841 F Date de début d'activité: 1er avril 1996. Précédent propriétaire : CAMAIEU INTERNATIONAL. RCS B 345 086 177 Publication légale: La Gazette des Yvelines du 10 mai 1996. Oppositions : au fonds.

07/03/1997

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS o. RCS Roubaix-Tourcoing B 305 154 262 RC RC 96-B 259 CAMAIEU HOMME. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 120 780 300 F. Adresse du siège social : 152, avenue Alfred-Motte 59100 Roubaix. Commentaires : fusion-absorption des SOCIETES ALPAGA GAP NARBONNE PARTICIPATION et CAP 61 Etablissement principal: Activité : commerce de gros et de détail, ainsi que la fabrication de tous articles textiles. Adresse : 152, avenue Alfred-Motte 59100 Roubaix. Date d'effet : 30 décembre 1996.

01/03/1997

Bodacc A

Création d'établissement

RCS Roubaix B 305 154 262 A dater du: 17 janvier 1997 CAMAIEU HOMME. Forme : S. A. Adresse du siège social : 152, avenue Alfred-Motte, 59100 Roubaix ETABLISSEMENT SECONDAIRE Nimes B RC 97- B 51. Activité : vente de tous articles textiles pour homme, en France et dans tous pays. Enseigne : Camaieu. Adresse : centre commercial Les Halles, lot no 325, 30000 Nimes Fonds secondaire acquis par apport au montant évalué à 112 171 841 F Date de début d'activité: 1er avril 1996 Précédente propriétaire CAMAIEU INTERNATIONAL RC 92-B 258 Publication légale: La Gazette du 8 mai 1996. Oppositions : au siège social sis 59100 Roubaix.

26/09/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS o. RCS Roubaix-Tourcoing B 305 154 262 RC RC 96-B 259 CAMAIEU HOMME. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 120 780 300 F. Adresse du siège social : 152, avenue Alfred-Motte 59100 Roubaix. Administration : président du conseil d' administration : MULLIEZ (Marc) Administrateurs : MULLIEZ (Jean) MULLIEZ (Gonzague) THOMAS (Guy). Commissaire aux comptes titulaire : MONFRAIX (Paul). Commissaire aux comptes suppléant : LIPOVAC (Yvan). Ancien président du conseil d' administration : TORCK (Françoise). Ancien administrateur : TORCK (Jean- Pierre). Ancien commissaire aux comptes titulaire : CAPPELIER (Jean-Bernard). Ancien commissaire aux comptes suppléant : DELESALLE (Eric). Ancien administrateur : CAMAIEU INTRENATIONAL. Commentaires : ancienne activité : vente de tous articles textiles Etablissement principal: Activité : commerce en gros et au détail ainsi que fabrication de tous articles textiles. Adresse : 152, avenue Alfred-Motte 59100 Roubaix Date de début d'activité: 20 décembre 1995. Date d'effet : 23 avril 1996.

07/07/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Ancienne situation du siège social. RCS Roubaix-Tourcoing B 305 154 262 RC 96-B 259 CAMAIEU HOMME. Forme : S.A.R.L. Capital : 280 000 F. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte 59100 Roubaix. Administration : président du conseil d' administration : Mme TORCK, née DELPLANQUE (Françoise). Administrateurs TORCK (Jean-Pierre) CAMAIEU INTERNATIONAL. Commissaire aux comptes titulaire : CAPPELIER (Jean-Bernard). Commissaire aux comptes suppléant : DELESALLE (Eric) Nouvelle situation du siège social. Forme : S.A. Capital : 120 780 300 F Etablissement principal: Activité : vente de tous articles textiles sous toutes ses formes, pour hommes. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte 59100 Roubaix. Date d'effet : 1er avril 1996.

23/06/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Roubaix-Tourcoing B 305 154 262 RC 96-B 259 ETABLISSEMENTS MICHEL LAZOORE. Forme : S.A.R.L. Capital : 280 000 F. Adresse du siège social : 152 avenue Alfred-Motte 59100 Roubaix. Administration : gérant : TORCK (Jean, Pierre). Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire : CAPPELIER (Jean- Bernard). Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant : DELESALLE (Eric) Etablissement principal: Activité : vente de tous articles textiles pour hommes, sous toutes ses formes. Adresse : 152 avenue Alfred-Motte 59100 Roubaix. Commentaires : reprise d'activité de la société. Date d'effet : 12 mars 1996.

03/05/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS. RCS B 305 154 262 RC RC 96-B 259 ETABLISSEMENTS MICHEL LAZOORE. Forme : S. A.R.L. Capital : 280 000 F. Adresse du siège social : 152, avenue Alfred-Motte 59100 Roubaix. Administration : ancien gérant : TORCK (Jean-Pierre). Nouveau gérant : LAZOORE (Michel). Commentaires : mise en sommeil de la société. Ancien siège : route de Meteren, 59270 Bailleul. Date d'effet : 20 décembre 1995.

30/04/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Hazebrouck B 305 154 262 RC 76-B 1 ETABLISSEMENTS MICHEL LAZOORE. Forme : S. A.R.L. Capital : 280 000 F (fixe). Adresse du siège social : route de Meteren, 59270 Bailleul. Commentaires : mise en sommeil de la société, le fonds de commerce a été repris par le propriétaire suite à la fin de la location-gérance la société est mise en sommeil. Date d'effet : 31 décembre 1994.

 

 

Company events history

 

Date

Description

22/02/2018

Bodacc B: Various editing or changing

05/02/2018

Amendment

05/02/2018

Appointment/resignation of company officers

02/02/2018

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

18/12/2017

Legal Gazette: Appointment of the social representative

14/09/2017

Bodacc B: Various editing or changing

18/08/2017

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

11/08/2017

Appointment/resignation of company officers

30/06/2017

Legal Gazette: Appointment of the social representative

27/04/2017

Bodacc C : Deposit accounts notice

05/04/2017

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

18/01/2017

Bodacc C : Deposit accounts notice

21/12/2016

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

07/10/2016

New subsidiarie(s) detected

07/10/2016

New ultimate parent

15/09/2016

Bodacc A : Sale and transfer

02/04/2016

Update Rating

02/04/2016

Update Limit

31/12/2015

New accounts available

18/05/2015

Bodacc C : Deposit accounts notice

28/04/2015

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

31/03/2015

Amendment

31/03/2015

Declaration of conformity

31/03/2015

Updated articles of association

31/12/2014

New accounts available

19/12/2014

Bodacc A : Sale and transfer

27/11/2014

Planned merger

31/10/2014

Legal Gazette: Activity or goodwill cession: Buyer

15/05/2014

Bodacc C : Deposit accounts notice

04/04/2014

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

31/12/2013

New accounts available

03/08/2013

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

08/07/2013

Bodacc C : Deposit accounts notice

08/06/2013

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

03/05/2013

Disengagement of the group

03/05/2013

New subsidiarie(s) detected

03/05/2013

New ultimate parent

03/05/2013

New parent detected

11/03/2013

Updated articles of association

11/03/2013

Merger

11/03/2013

Declaration of conformity

11/03/2013

Amendment

31/12/2012

Update of Company Workforce

31/12/2012

New accounts available

31/12/2012

Formation of Establishment

20/12/2012

Audit or Management Report

28/11/2012

Merger

28/11/2012

Merger

31/10/2012

Merger

31/10/2012

Merger

11/10/2012

Bodacc B: Various editing or changing

26/09/2012

Updated articles of association

26/09/2012

Updated articles of association

26/09/2012

Minutes of general meeting of shareholders

26/09/2012

Amendment

26/09/2012

Amendment

27/08/2012

Amendment

27/08/2012

Amendment

27/08/2012

Declaration of conformity

27/08/2012

Updated articles of association

27/08/2012

Updated articles of association

27/08/2012

Declaration of conformity

04/08/2012

Legal Gazette: Resignation / Revocation of the social representative

18/07/2012

Legal Gazette: Appointment of the social representative

29/06/2012

Planned merger

29/06/2012

Planned merger

28/06/2012

Application and court order

28/06/2012

Extension of term

28/06/2012

Extension of term

28/06/2012

Application and court order

30/05/2012

Planned merger

30/05/2012

Merger

30/05/2012

Merger

30/05/2012

Planned merger

24/05/2012

Formation of Establishment

24/05/2012

Update of Company Workforce

31/12/2011

New accounts available

25/11/2011

Bodacc C : Deposit accounts notice

16/11/2011

Consideration of a balance sheet that has led to a reassessment of this company's creditworthiness

15/11/2011

Updated articles of association

15/11/2011

Amendment

15/11/2011

Amendment

15/11/2011

Declaration of conformity

15/11/2011

Declaration of conformity

15/11/2011

Minutes of general meeting of shareholders

15/11/2011

Updated articles of association

06/11/2011

Bodacc B: Various editing or changing

26/10/2011

Amendment

26/10/2011

Amendment

26/10/2011

Capital increase

26/10/2011

Capital increase

26/10/2011

Declaration of conformity

26/10/2011

Declaration of conformity

26/10/2011

Minutes of general meeting of shareholders

26/10/2011

Updated articles of association

26/10/2011

Updated articles of association

31/07/2011

Bodacc A : Sale and transfer

30/06/2011

Other modification of Establishment

30/06/2011

Update of Company Workforce

21/06/2011

Audit or Management Report

21/06/2011

Audit or Management Report

18/05/2011

Legal Gazette: Proposed merger

11/05/2011

Planned merger

11/05/2011

Planned merger

10/05/2011

Planned merger

10/05/2011

Planned merger

10/05/2011

Private document

10/05/2011

Private document

13/03/2011

Bodacc A : Sale and transfer

04/03/2011

New ultimate parent

02/03/2011

Bodacc B: Various editing or changing

18/02/2011

Updated articles of association

18/02/2011

Updated articles of association

18/02/2011

Minutes of general meeting of shareholders

18/02/2011

Minutes of general meeting of shareholders

18/02/2011

Capital increase

18/02/2011

Capital increase

01/02/2011

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

31/12/2010

New accounts available

15/09/2010

Bodacc A : Sale and transfer

08/09/2010

Update of Company Workforce

08/09/2010

Other modification of Establishment

08/09/2010

Legal Gazette: Modification of the share capital

13/08/2010

New shareholders detected

13/08/2010

New subsidiarie(s) detected

31/07/2010

Legal Gazette: Activity or goodwill cession

30/06/2010

Activation of Establishment

30/06/2010

Modification of Establishment Activity

26/06/2010

Formation of Establishment

10/05/2010

Formation of Establishment

22/02/2010

New ultimate parent

22/02/2010

New parent detected

30/12/2009

Bodacc C : Deposit accounts notice

30/11/2009

Bodacc B: Various editing or changing

17/11/2009

Amendment

17/11/2009

Updated articles of association

17/11/2009

Minutes of general meeting of shareholders

17/11/2009

Capital increase

30/09/2009

Modification to Establishment Address or Identifier

25/09/2009

Other modification of Establishment

23/09/2009

Bodacc A : Sale and transfer

15/05/2009

Bodacc A : Sale and transfer

31/12/2008

New accounts available

02/12/2008

Bodacc B: Various editing or changing

02/12/2008

New Bodacc B ads detected

18/11/2008

Minutes of general meeting of shareholders

18/11/2008

Capital increase

18/11/2008

Amendment

18/11/2008

Private document

18/11/2008

Updated articles of association

18/11/2008

Updated articles of association

18/11/2008

Capital increase

04/10/2008

Formation of Establishment

25/09/2008

Other modification of Establishment

27/07/2008

New Bodacc A ads detected

27/07/2008

Bodacc A : Sale and transfer

23/07/2008

Bodacc A : Sale and transfer

23/07/2008

New Bodacc A ads detected

07/07/2008

Private document

07/07/2008

Minutes of general meeting of shareholders

07/07/2008

Declaration of conformity

07/07/2008

Declaration of conformity

07/07/2008

Audit or Management Report

07/07/2008

Audit or Management Report

07/07/2008

Private document

14/06/2008

Formation of Establishment

28/05/2008

Planned merger

28/05/2008

Planned merger

28/05/2008

Private document

01/05/2008

Formation of Establishment

18/04/2008

Collection of preferential rights activated for this company

12/03/2008

Bodacc C : Deposit accounts notice

07/02/2008

Amendment

07/02/2008

Minutes of general meeting of shareholders

07/02/2008

Minutes of general meeting of shareholders

07/02/2008

Private document

31/12/2007

New accounts available

22/10/2007

Updated articles of association

22/10/2007

Private document

22/10/2007

New chairman (CEO, CoB)

22/10/2007

Minutes of general meeting of shareholders

22/10/2007

Capital increase

22/10/2007

Capital increase

22/10/2007

Appointment/resignation of company officers

22/10/2007

Amendment

22/10/2007

Updated articles of association

22/10/2007

Minutes of general meeting of shareholders

06/10/2007

Formation of Establishment

01/10/2007

Formation of Establishment

10/08/2007

Updated articles of association

10/08/2007

Private document

10/08/2007

Minutes of general meeting of shareholders

10/08/2007

Fund deposit certificate

10/08/2007

Updated articles of association

10/08/2007

Capital increase

10/08/2007

Amendment

10/08/2007

Capital increase

20/07/2007

Other modification of Establishment

19/05/2007

Formation of Establishment

04/05/2007

Appointment/resignation of company officers

04/05/2007

Private document

04/05/2007

New auditor

04/05/2007

New auditor

04/05/2007

Minutes of general meeting of shareholders

04/05/2007

Minutes of general meeting of shareholders

31/12/2006

New accounts available

20/07/2006

Capital increase

20/07/2006

Declaration of conformity

20/07/2006

Fund deposit certificate

20/07/2006

Minutes of general meeting of shareholders

20/07/2006

Amendment

20/07/2006

Updated articles of association

20/07/2006

Private document

30/05/2006

Planned merger

30/05/2006

Private document

31/12/2005

New accounts available

14/10/2005

Amendment

14/10/2005

Audit or Management Report

14/10/2005

Capital increase

14/10/2005

Declaration of conformity

14/10/2005

Minutes of general meeting of shareholders

14/10/2005

Private document

14/10/2005

Updated articles of association

14/10/2005

Fund deposit certificate

04/08/2005

Planned merger

04/08/2005

Private document

31/12/2004

New accounts available

30/09/2004

Updated articles of association

30/09/2004

Audit or Management Report

30/09/2004

Declaration of conformity

30/09/2004

Minutes of general meeting of shareholders

30/09/2004

Private document

26/08/2004

Planned merger

26/08/2004

Private document

26/08/2004

Updated articles of association

26/08/2004

Articles of association

26/08/2004

Capital increase

26/08/2004

Fund deposit certificate

26/08/2004

Minutes of general meeting of shareholders

31/12/2003

New accounts available

03/10/2003

Updated articles of association

03/10/2003

Minutes of general meeting of shareholders

03/10/2003

Private document

03/10/2003

Declaration of conformity

22/09/2003

Private document

22/09/2003

Audit or Management Report

15/09/2003

Capital increase

15/09/2003

Fund deposit certificate

15/09/2003

Minutes of general meeting of shareholders

15/09/2003

Private document

15/09/2003

Updated articles of association

07/08/2003

Planned merger

07/08/2003

Private document

20/06/2003

Appointment/resignation of company officers

20/06/2003

Minutes of general meeting of shareholders

20/06/2003

Private document

20/06/2003

New auditor

29/11/2002

Minutes of general meeting of shareholders

29/11/2002

Updated articles of association

29/11/2002

Declaration of conformity

29/11/2002

Audit or Management Report

29/11/2002

Private document

26/11/2002

Minutes of general meeting of shareholders

26/11/2002

Updated articles of association

26/11/2002

Private document

24/10/2002

Planned merger

24/10/2002

Private document

27/09/2002

Private document

27/09/2002

Planned merger

16/09/2002

Private document

16/09/2002

Minutes of general meeting of shareholders

16/09/2002

Fund deposit certificate

16/09/2002

Capital increase

16/09/2002

Updated articles of association

19/02/2002

Updated articles of association

19/02/2002

Capital increase

19/02/2002

Conversion of equity to euro

19/02/2002

Minutes of general meeting of shareholders

19/02/2002

New legal form – no new category

19/02/2002

Appointment/resignation of company officers

19/02/2002

Amendment

19/02/2002

Private document

30/05/2001

Capital increase

30/05/2001

Minutes of Board meeting

30/05/2001

Minutes of general meeting of shareholders

30/05/2001

Private document

30/05/2001

Updated articles of association

30/05/2001

Amendment

03/08/2000

Updated articles of association

03/08/2000

New company name

03/08/2000

Private document

03/08/2000

Minutes of general meeting of shareholders

13/04/2000

Audit or Management Report

13/04/2000

Amendment

13/04/2000

Capital increase

13/04/2000

Minutes of Board meeting

13/04/2000

Private document

13/04/2000

Updated articles of association

13/04/2000

Minutes of general meeting of shareholders

29/03/1999

Updated articles of association

29/03/1999

Declaration of conformity

29/03/1999

Minutes of general meeting of shareholders

29/03/1999

Private document

02/11/1998

Planned merger

02/11/1998

Private document

11/03/1998

Updated articles of association

11/03/1998

Private document

11/03/1998

Minutes of general meeting of shareholders

11/03/1998

Declaration of conformity

25/11/1997

Planned merger

25/11/1997

Private document

20/02/1997

Private document

20/02/1997

Minutes of general meeting of shareholders

20/02/1997

Declaration of conformity

20/02/1997

Updated articles of association

27/11/1996

Planned merger

27/11/1996

Private document

11/09/1996

New chairman (CEO, CoB)

11/09/1996

New auditor

11/09/1996

Minutes of general meeting of shareholders

11/09/1996

Minutes of Board meeting

11/09/1996

Updated articles of association

11/09/1996

Change to corporate purpose

11/09/1996

Appointment/resignation of company officers

11/09/1996

Amendment

11/09/1996

Changes to the Board of Directors

24/06/1996

Capital increase

24/06/1996

Updated articles of association

24/06/1996

New legal form – no new category

24/06/1996

New legal form – new category

24/06/1996

New chairman (CEO, CoB)

24/06/1996

Minutes of general meeting of shareholders

24/06/1996

Minutes of Board meeting

24/06/1996

Declaration of conformity

24/06/1996

Audit or Management Report

24/06/1996

Appointment/resignation of company officers

24/06/1996

Amendment

07/06/1996

Minutes of general meeting of shareholders

07/06/1996

New legal form – no new category

07/06/1996

Sale of shares

07/06/1996

Updated articles of association

07/06/1996

Amendment

07/06/1996

New auditor

07/06/1996

Appointment/resignation of company officers

07/06/1996

Change to corporate purpose

07/06/1996

Private document

05/06/1996

Minutes of general meeting of shareholders

05/06/1996

Private document

05/06/1996

Updated articles of association

05/06/1996

Sale of shares

25/03/1996

Private document

25/03/1996

New manager

25/03/1996

Minutes of general meeting of shareholders

25/03/1996

Audit or Management Report

25/03/1996

Articles of association

25/03/1996

Appointment/resignation of company officers

25/03/1996

Registered office transferred inside jurisdiction of the Commercial Court

25/03/1996

Registration after transfer

25/03/1996

Updated articles of association

25/03/1996

Amendment

25/03/1996

Sale of shares

01/03/1996

Amendment

01/01/1996

Private document

01/01/1996

Planned merger

 

 

Establishment events history

 

Date

Description

26/03/2017

Update of phone numbers

20/11/2016

Update of phone numbers

23/09/2016

Modification of Head office

02/08/2016

Update of phone numbers

01/01/2015

Modification of Head office

25/12/2014

Update of phone numbers

12/06/2014

Modification of Head office

22/02/2014

Update of phone numbers

05/09/2013

Update of phone numbers

12/01/2013

Update of phone numbers

31/12/2012

Update of Establishment Workforce

31/12/2012

Modification of Head office

24/05/2012

Modification of Head office

18/05/2012

Update of phone numbers

30/06/2011

Modification of Head office

30/06/2011

Update of Establishment Workforce

30/06/2010

Modification of Head office

26/06/2010

Modification of Head office

10/05/2010

Modification of Head office

25/09/2009

Update of Establishment Workforce

04/10/2008

Modification of Head office

14/06/2008

Modification of Head office

01/05/2008

Modification of Head office

06/10/2007

Modification of Head office

01/10/2007

Modification of Head office

19/05/2007

Modification of Head office

 

Synthesized Accounts

Annual Accounts

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

Account period (month)

12

12

12

Account Type

Normal

Normal

Normal

Date of capture

04/04/2017

20/12/2016

27/04/2015

Activity Code

4771Z

4771Z

4771Z

Employees

2017

1860

1879

 

Active account

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2015

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

127,961,800

-0.5%

128,624,418

10.3%

116,610,104

75,015

170482.8%

 Intangible assets

78,510,400

1.6%

77,240,357

17.8%

65,562,688

39,285

199748.3%

 Tangible assets

36,774,799

-5.4%

38,878,305

1.2%

38,421,096

9,466

388393.5%

 Financial assets

12,676,601

1.4%

12,505,756

-1.0%

12,626,320

1,949

650315.6%

Net current assets

114,582,565

20.9%

94,758,523

14.3%

82,917,850

88,762

128990.4%

 Stocks

39,797,364

16.4%

34,187,995

-3.4%

35,373,433

35,233

112856.4%

 Advanced payments

0

0%

0

0%

0

0

0%

 Receivables

63,837,740

35.0%

47,291,495

16.0%

40,785,732

9,432

676756.7%

 Securities and cash

10,947,461

-17.6%

13,279,034

96.5%

6,758,685

14,819

73774.5%

 Prepaid expenses

-

-

-

-

-

288

-

Accounts of regularization

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total Assets

242,544,365

8.6%

223,382,941

12.0%

199,527,954

189,016

128219.5%

 

Passive Account

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2015

Shareholders' equity

113,130,684

9.2%

103,632,266

0.6%

102,974,296

44,140

256202.6%

Share capital

30,990,501

0%

30,990,501

0%

30,990,501

8,000

387281.3%

Other capital resources

0

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

7,269,237

26.9%

5,728,941

-18.8%

7,054,531

0

0%

Liabilities

122,144,444

7.1%

114,021,733

27.4%

89,499,126

118,556

102926.8%

 Financial liabilities

12,456,934

17.5%

10,603,870

-25.2%

14,180,916

34,832

35663.4%

 Advanced payments received

0

0%

0

0%

0

0

0%

 Trade account payables

50,096,233

18.3%

42,364,363

-0.6%

42,622,927

22,833

219307.6%

 Tax and social liabilities

21,507,396

-1.9%

21,929,827

20.0%

18,278,100

19,218

111812.8%

 Other debts and fixed assets liabilities

34,579,237

-4.3%

36,137,419

153.6%

14,247,733

5,550

623005.5%

Account regularization

3,504,643

17.4%

2,986,254

1662.3%

169,450

0

0%

Total liabilities

242,544,365

8.6%

223,382,941

12.0%

199,527,953

188,980

128244.3%

 

Results

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2015

Sales of Goods

373,327,180

3.2%

361,822,573

9.6%

330,069,698

223,780

166728.1%

Net turnover

354,306,011

0.8%

351,599,803

9.4%

321,388,603

219,447

161354.0%

 of which net export turnover

26,957,268

10.2%

24,453,276

24.2%

19,689,427

0

0%

Operating charges

331,865,486

2.7%

323,017,411

8.7%

297,236,520

219,796

150888.0%

Operating profit/loss

41,461,693

6.8%

38,805,161

18.2%

32,833,178

4,577

905770.5%

Financial income

2,866,998

-52.6%

6,051,339

225.9%

1,856,614

0

0%

Financial charges

2,163,869

-67.0%

6,559,768

128.6%

2,869,269

981

220590.4%

Financial profit/loss

703,129

238.3%

-508,429

49.8%

-1,012,655

-669

105201.5%

Pretax net operating income

42,164,823

10.1%

38,296,732

20.4%

31,820,523

3,412

1235861.4%

Extraordinary income

659,036

-15.9%

783,948

2286.5%

32,849

0

0%

Extraordinary charges

870,049

-77.3%

3,832,900

137.1%

1,616,888

60

1449981.7%

Extraordinary profit/loss

-211,013

93.1%

-3,048,952

-92.5%

-1,584,039

0

0%

Net result

28,006,413

51.3%

18,507,995

3.7%

17,850,025

3,513

797235.6%

 

Accounts - Active

Normal Account

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

Months

12

12

12

 

Grand Total - Active Accounts (I to VI)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Grand Total (I to VI)

Net

242,544,365

8.6%

223,382,941

12.0%

199,527,954

Gross

CO

352,284,320

7.1%

329,039,535

11.9%

294,064,777

Amortisation

1A

109,739,955

3.9%

105,656,594

11.8%

94,536,823

 

Non declared distributed capital (I)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

Gross

AA

0

0%

0

0%

0

 

Active fixed asset (II)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total Active fixed asset (II)

Net

127,961,800

-0.5%

128,624,418

10.3%

116,610,104

Gross

BJ

234,877,753

1.6%

231,070,731

12.0%

206,351,254

Amortisation

BK

106,915,953

4.4%

102,446,313

14.2%

89,741,150

 

Intangible fixed assets

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R&D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CQ

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

919,769

31.4%

699,726

28.1%

546,391

Gross

AF

1,833,077

32.0%

1,388,315

23.1%

1,127,893

Amortisation

AG

913,308

32.6%

688,589

18.4%

581,502

Goodwill

Net

77,590,631

1.4%

76,540,631

17.7%

65,016,297

Gross

AH

87,794,631

1.3%

86,674,631

16.9%

74,124,297

Amortisation

AI

10,204,000

0.7%

10,134,000

11.3%

9,108,000

Other intangible fixed assets

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AJ

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AK

0

0%

0

0%

0

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible asset

Net

78,510,400

1.6%

77,240,357

17.8%

65,562,688

 

Tangible fixed assets

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Lands

Net

177,022

0%

177,022

0%

177,022

Gross

AN

177,022

0%

177,022

0%

177,022

Amortisation

AO

0

0%

0

0%

0

Buildings

Net

24,508

-49.4%

48,482

-33.8%

73,223

Gross

AP

823,953

0%

823,953

0%

823,953

Amortisation

AQ

799,445

3.1%

775,470

3.3%

750,730

Plant

Net

4,677,772

11.6%

4,189,966

15.4%

3,630,712

Gross

AR

12,867,365

12.4%

11,445,830

17.6%

9,735,789

Amortisation

AS

8,189,593

12.9%

7,255,864

18.8%

6,105,077

Other tangible fixed assets

Net

31,387,721

-2.6%

32,211,773

-3.1%

33,245,195

Gross

AT

112,709,328

2.3%

110,194,162

6.7%

103,252,036

Amortisation

AU

81,321,607

4.3%

77,982,390

11.4%

70,006,841

Fixed assets in construction

Net

181,308

-84.1%

1,142,537

495.6%

191,842

Gross

AV

181,308

-84.1%

1,142,537

495.6%

191,842

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

326,468

-70.5%

1,108,525

0.5%

1,103,102

Gross

AX

326,468

-70.5%

1,108,525

0.5%

1,103,102

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

Sub Total Tangible asset

Net

36,774,799

-5.4%

38,878,305

1.2%

38,421,096

 

Financial assets

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

4,699,847

2.7%

4,577,847

34.9%

3,394,618

Gross

CU

10,187,847

0%

10,187,847

88.9%

5,394,618

Amortisation

CV

5,488,000

-2.2%

5,610,000

180.5%

2,000,000

Inter-company receivables

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BC

0

0%

0

0%

0

Other investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BD

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BE

0

0%

0

0%

0

Loans

Net

0

0%

0

0%

2,151,000

Gross

BF

0

0%

0

0%

3,340,000

Amortisation

BG

0

0%

0

0%

1,189,000

Other financial assets

Net

7,976,754

0.6%

7,927,909

12.0%

7,080,702

Gross

BH

7,976,754

0.6%

7,927,909

12.0%

7,080,702

Amortisation

BI

0

0%

0

0%

0

Sub Total Financial assets

Net

12,676,601

1.4%

12,505,756

-1.0%

12,626,320

 

Current Assets (III)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total Current Assets

Net

114,582,565

20.9%

94,758,523

14.3%

82,917,850

Gross

CJ

117,406,567

19.8%

97,968,804

11.7%

87,713,523

Amortisation

CK

2,824,002

-12.0%

3,210,281

-33.1%

4,795,673

 

Stocks

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Raw materials

Net

858,405

153.2%

338,989

78.6%

189,842

Gross

BL

858,405

153.2%

338,989

78.6%

189,842

Amortisation

BM

0

0%

0

0%

0

Work in progress (goods)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BN

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

0

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BR

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BS

0

0%

0

0%

0

Goods for resale

Net

38,938,959

15.0%

33,849,006

-3.8%

35,183,591

Gross

BT

41,356,784

13.1%

36,571,152

-2.9%

37,664,910

Amortisation

BU

2,417,825

-11.2%

2,722,146

9.7%

2,481,319

Sub Total Stocks

Net

39,797,364

16.4%

34,187,995

-3.4%

35,373,433

 

Advance payments to suppliers

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Advance payments to suppliers

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BV

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0

 

Debtors

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Trade accounts receivable

Net

17,356,872

-29.1%

24,484,507

119.7%

11,143,201

Gross

BX

17,551,709

-29.1%

24,761,302

110.0%

11,792,215

Amortisation

BY

194,837

-29.6%

276,795

-57.4%

649,014

Other debtors

Net

35,348,081

229.7%

10,720,905

-35.3%

16,577,249

Gross

BZ

35,348,081

229.7%

10,720,905

-40.5%

18,031,249

Amortisation

CA

0

0%

0

0%

1,454,000

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

Sub Total debtors

Net

52,704,953

49.7%

35,205,412

27.0%

27,720,450

 

Divers

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CD

211,340

0%

211,340

0%

211,340

Amortisation

CE

211,340

0%

211,340

0%

211,340

Cash and cash equivalents

Net

10,947,461

-17.6%

13,279,034

96.5%

6,758,685

Gross

CF

10,947,461

-17.6%

13,279,034

96.5%

6,758,685

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

Sub Total Divers

Net

10,947,461

-17.6%

13,279,034

96.5%

6,758,685

 

Prepaid expenses

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Prepaid expenses

Net

11,132,787

-7.9%

12,086,083

-7.5%

13,065,282

Gross

CH

11,132,787

-7.9%

12,086,083

-7.5%

13,065,282

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts (IV to VI)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Expenses of loan issue to be spread

CW3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Currency differential gain

CN3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

 

References

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

Due after one year

CR

3,902,118

0%

0

0%

0

 

Accounts - Passive

Grand Total - Passive Accounts (I to V)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Grand Total (I to V)

EE

242,544,365

8.6%

223,382,941

12.0%

199,527,953

 

Shareholder Equity (I)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total shareholders' equity (Total I)

DL

113,130,684

9.2%

103,632,266

0.6%

102,974,296

Equity and shareholders' equity

DA

30,990,501

0%

30,990,501

0%

30,990,501

Issue and merger premiums

DB

0

0%

0

0%

0

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

Legal reserve

DD

3,361,957

0%

3,361,957

0%

3,361,957

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

Special regulated reserves

DF

4,447

0%

4,447

0%

4,447

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

Other reserves

DG

50,767,366

0%

50,767,366

0%

50,767,366

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

0%

0

0%

0

Profits or losses brought forward

DH

0

0%

0

0%

0

Profit or loss for the period

DI

28,006,413

51.3%

18,507,995

3.7%

17,850,025

Investment grants

DJ

0

0%

0

0%

0

Special tax-allowable reserves

DK

0

0%

0

0%

0

 

Other capital resources (II)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

 

Provisions for risks and charges (III)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

7,269,237

26.9%

5,728,941

-18.8%

7,054,531

Risk provisions

DP

5,116,332

23.1%

4,155,605

-32.1%

6,121,531

Reserves for charges

DQ

2,152,905

36.8%

1,573,336

68.6%

933,000

 

Liabilities (IV)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total Liabilities (Total IV)

EC

122,144,444

7.1%

114,021,733

27.4%

89,499,126

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

Bank loans and liabilities

DU

7,633,783

-23.1%

9,929,257

-25.9%

13,393,458

Sundry loans and financial liabilities

DV

4,823,151

615.0%

674,613

-14.3%

787,458

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

Advance payments received for current orders

DW

0

0%

0

0%

0

Trade accounts payables

DX

50,096,233

18.3%

42,364,363

-0.6%

42,622,927

Tax and social security liabilities

DY

21,507,396

-1.9%

21,929,827

20.0%

18,278,100

Fixed asset liabilities

DZ

489,187

1.0%

484,133

-2.9%

498,500

Other debts

EA

34,090,050

-4.4%

35,653,286

159.3%

13,749,233

 

Translation loss (V)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Translation loss (Total V)

ED

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Deferred income

EB

3,504,643

17.4%

2,986,254

1662.3%

169,450

 

References

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

Deferred income and liabilities

EG

118,268,016

0%

0

0%

0

Of which current bank facilities

EH

3,040,033

0%

0

0%

0

 

Result account

1 - Operating result (I-II)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Operating result (Total I-II)

GG

41,461,693

6.8%

38,805,161

18.2%

32,833,178

 

2 - Financial result (V-VI)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Financial result (Total V-VI)

GV

703,129

238.3%

-508,429

49.8%

-1,012,655

 

3 - Pre-tax net operating income result (I to VI)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

42,164,823

10.1%

38,296,732

20.4%

31,820,523

 

4 - Extraordinary result (VII-VIII)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

-211,013

93.1%

-3,048,952

-92.5%

-1,584,039

 

Profit or loss

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Profit or loss

HN

28,006,413

51.3%

18,507,995

3.7%

17,850,025

 

Total Income (I+III+V+VII)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total Income (Total I+III+V+VII)

HL

376,853,214

2.2%

368,657,859

11.1%

331,959,161

 

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

348,846,801

-0.4%

350,149,865

11.5%

314,109,138

 

Operating income (I)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total operating income (Total I)

FR

373,327,180

3.2%

361,822,573

9.6%

330,069,698

 

Operating income (details)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Sale of goods for resale

FC

341,813,916

0.6%

339,644,101

9.9%

308,963,634

France

FA

317,215,819

-0.2%

317,845,030

9.1%

291,362,381

Export

FB

24,598,098

12.8%

21,799,071

23.8%

17,601,253

Sale of goods produced

FF

0

0%

0

0%

0

France

FD

0

0%

0

0%

0

Export

FE

0

0%

0

0%

0

Sale of services

FI

12,492,094

4.5%

11,955,701

-3.8%

12,424,969

France

FG

10,132,924

8.9%

9,301,497

-10.0%

10,336,795

Export

FH

2,359,171

-11.1%

2,654,204

27.1%

2,088,174

Net turnover

FL

354,306,011

0.8%

351,599,803

9.4%

321,388,603

France

FJ

327,348,743

0.1%

327,146,527

8.4%

301,699,177

Export

FK

26,957,268

10.2%

24,453,276

24.2%

19,689,427

Stocked production

FM

0

0%

0

0%

0

Self-constructed assets

FN

0

0%

0

0%

0

Operating grants

FO

0

0%

0

0%

0

Release of reserves and provisions

FP

18,176,009

96.3%

9,258,333

11.8%

8,278,674

Other income

FQ

845,159

-12.4%

964,437

139.7%

402,421

 

Operating charges (II)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total operating charges (Total II)

GF

331,865,486

2.7%

323,017,411

8.7%

297,236,520

 

Exploitation charges

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Purchase of goods for resale

FS

147,663,967

3.2%

143,024,407

8.0%

132,454,195

Change in stocks of goods for resale

FT

-5,305,049

-367.5%

1,983,079

23.3%

1,608,472

Purchase of raw materials

FU

2,464,871

23.1%

2,001,936

0.3%

1,995,241

Change in stocks of raw materials

FV

0

0%

0

0%

0

Other external purchases and charges

FW

98,419,863

1.4%

97,088,718

8.2%

89,721,963

Tax, duty and similar payments

FX

5,847,926

3.9%

5,627,987

3.3%

5,447,031

Payroll

FY

39,937,281

1.2%

39,467,706

15.3%

34,220,992

Social security costs

FZ

12,599,077

-7.8%

13,662,719

15.6%

11,819,311

 

Depreciation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Depreciation of fixed assets

GA

10,801,819

-3.6%

11,199,748

5.0%

10,669,669

Amortisation of fixed assets

GB

10,204,000

226.7%

3,123,000

21.0%

2,580,321

Depreciation/amortisation of current assets

GC

5,011,403

46.9%

3,410,763

10.4%

3,089,192

Provisions for risks and charges

GD

3,437,742

139.6%

1,434,836

-49.5%

2,843,190

 

Other charges

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Other charges

GE

782,586

-21.2%

992,514

26.1%

786,943

 

Operating charges (III-IV)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

 

Financial income (V)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total financial income (Total V)

GP

2,866,998

-52.6%

6,051,339

225.9%

1,856,614

Share financial income

GJ

0

0%

24,067

0%

0

Other investment income & capitalised receivables

GK

0

0%

0

0%

0

Other interest and similar income

GL

50,714

-42.6%

88,292

-48.5%

171,295

Released provisions and transferred charges

GM

122,000

-97.4%

4,643,000

0%

0

Exchange gains

GN

2,694,284

108.0%

1,295,469

-22.7%

1,676,092

Net income from disposal of investment securities

GO

0

0%

512

-94.5%

9,227

 

Financial charge (VI)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total financial charge (Total VI)

GU

2,163,869

-67.0%

6,559,768

128.6%

2,869,269

Financial reserves and provisions

GQ

0

0%

5,610,000

371.8%

1,189,000

Interest and similar charges

GR

355,222

-32.6%

527,253

0.0%

527,063

Exchange losses

GS

1,808,647

328.1%

422,515

-63.4%

1,153,206

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary income (VII)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total extraordinary income (Total VII)

HD

659,036

-15.9%

783,948

2286.5%

32,849

Extraordinary operating income

HA

0

0%

80,155

0%

0

Extraordinary income from capital transactions

HB

395,353

-43.8%

703,793

2042.5%

32,849

Released provisions and transferred charges

HC

263,683

0%

0

0%

0

 

Extraordinary charges (VIII)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

870,049

-77.3%

3,832,900

137.1%

1,616,888

Extraordinary operating charges

HE

49,096

-93.0%

697,020

281.5%

182,725

Extraordinary charges from capital transactions

HF

543,953

-81.1%

2,880,881

100.9%

1,434,163

Extraordinary reserves and provisions

HG

277,000

8.6%

255,000

0%

0

 

Employee profit sharing (IX)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

1,927,061

-33.9%

2,917,312

38.1%

2,112,712

 

Tax on profits (X)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Tax on profits (Total X)

HK

12,020,336

-13.0%

13,822,473

34.5%

10,273,749

 

References

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

Of which transferred charges

A1

724,882

0%

0

0%

0

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

0

0%

0

 

Other incomes tax return forms

Fixed Assets

Grand Total Fixed Assets (I to IV)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

OK1

3,352,777

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

OK2

7,058,707

-79.2%

33,934,620

188.6%

11,760,286

Gross value at the end of period

OL

234,877,753

1.6%

231,070,731

12.0%

206,351,252

 

Research and development Charge (Total I)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

CO1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

CO2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

DO

0

0%

0

0%

0

 

Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Gross value at begin of period

KD

88,062,946

17.0%

75,252,189

0.1%

75,183,596

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

1,565,677

-88.9%

14,078,337

20288.3%

69,051

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

LV2

915

-99.9%

1,267,580

277269.8%

457

Gross value at the end of period

LW

89,627,708

1.8%

88,062,946

17.0%

75,252,190

 

Tangible fixed assets (Total III)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Gross value at begin of period

LN

124,892,029

8.3%

115,283,743

4.3%

110,507,212

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

12,367,628

-37.8%

19,874,560

23.1%

16,138,517

Decreasess by budget item transfer

NG1

3,352,778

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NG2

6,821,436

-33.6%

10,266,273

-9.6%

11,361,987

Gross value at the end of period

NH

127,085,444

1.8%

124,892,030

8.3%

115,283,742

 

Financial assets (Total IV)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Gross value at begin of period

LQ

18,115,755

14.5%

15,815,320

5.0%

15,061,501

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

285,202

-98.8%

24,701,203

2044.8%

1,151,661

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NJ2

236,356

-98.9%

22,400,767

5530.6%

397,842

Gross value at the end of period

NK

18,164,601

0.3%

18,115,756

14.5%

15,815,320

 

Reserve for depreciation

Situation and movement of reserve for depreciation - Grand total (I-II-III)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Reserve for depreciation value at begin of period

ON

0

0%

0

0%

0

Increases

OP

0

0%

0

0%

0

Decreasess

OQ

0

0%

0

0%

0

Reserve for depreciation value at the end of period

OR

0

0%

0

0%

0

 

Research and development charge (Total I)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0

 

Other intangible assets (Total II)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

688,589

12.3%

613,367

16.0%

528,707

Increases

PF

225,634

198.1%

75,679

42.1%

53,252

Decreasess

PG

915

100.2%

457

0%

457

Decreasess by budget item transfer

PH

913,308

32.6%

688,589

18.4%

581,502

 

Total fixed assets amotisation (Total III)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

86,013,724

6.4%

80,872,715

10.8%

73,012,469

Increases

QV

10,576,186

-4.9%

11,124,068

4.8%

10,616,416

Decreases

QW

6,279,265

5.0%

5,983,059

-11.6%

6,766,236

Decreasess by budget item transfer

QX

90,310,645

5.0%

86,013,724

11.9%

76,862,649

 

Movements during period affecting charge allocated over several period

Deferred charges and debt issuance costs

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0

 

Premium refund of obligations

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Net value at begin of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

 

Provisions included in balance sheet

Grand Total (I-II-III)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Value at begining of period

7C

24,683,222

2.2%

24,149,204

7.3%

22,498,055

Increases

UB

18,930,145

36.8%

13,833,662

21.2%

11,409,601

Decreases

UC

17,828,128

34.1%

13,297,644

36.2%

9,760,456

Value at the end of period

UD

25,785,239

4.5%

24,685,222

2.2%

24,147,200

 

Includes Total allocations

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Operating

UE

18,653,145

134.1%

7,968,662

-22.0%

10,220,601

Financial

UG

0

0%

5,610,000

371.8%

1,189,000

Exceptional

UJ

277,000

8.6%

255,000

0%

0

 

Includes Total Withdrawal

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Operating

UF

17,451,128

101.6%

8,654,644

-11.3%

9,760,453

Financial

UH

122,000

-92.6%

1,643,000

0%

0

Exceptional

UK

255,000

0%

0

0%

0

 

Total regulated provisions (Total I)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Value at begining of period

3Z

0

0%

0

0%

0

Increases

TS

0

0%

0

0%

0

Decreases

TT

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

TU

0

0%

0

0%

0

 

Total risk and charge provisions (Total II)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Value at begining of period

5Z

5,728,941

-18.8%

7,056,531

-13.6%

8,167,764

Increases

TV

6,175,742

241.0%

1,810,836

-60.2%

4,551,088

Decreases

TW

4,635,446

47.8%

3,136,426

-44.6%

5,664,322

Value at the end of period

TX

7,269,237

26.8%

5,730,941

-18.8%

7,054,530

 

Total Provision for depreciation (Total III)

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Value at begining of period

7B

18,954,281

10.9%

17,092,673

19.3%

14,330,291

Increases

TY

12,754,403

6.1%

12,022,826

75.3%

6,858,513

Decreases

TZ

13,192,682

29.8%

10,161,218

148.1%

4,096,134

Value at the end of period

UA

18,516,002

-2.3%

18,954,281

10.9%

17,092,670

 

State deadlines claims and debts at the end of period

State claims

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Gross value

VT

72,009,331

29.8%

55,496,200

4.1%

53,309,446

1 year at most

VU

60,130,459

26.4%

47,568,291

10.9%

42,888,744

More than one year

VV

11,878,872

49.8%

7,927,909

-23.9%

10,420,702

 

State of loans

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Claims related to holdings (gross)

UL

0

0%

0

0%

0

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0

0%

0

0%

0

Loans (gross)

UP

0

0%

0

0%

3,340,000

Loans (1 year at most)

UR

0

0%

0

0%

0

Other financial assets (gross)

UT

7,976,754

0.6%

7,927,909

12.0%

7,080,702

Other financial assets (1 year at most)

UV

0

0%

0

0%

0

 

Receivables statement of assets

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Customers doubtful or disputed

VA

237,001

-9.7%

262,391

2.6%

255,786

Other claims customer

UX

17,314,708

-29.3%

24,498,911

112.4%

11,536,428

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts

UY

67,730

2.3%

66,182

36.5%

48,501

Social Security and other social organizations

UZ

63,709

46.1%

43,605

30.9%

33,322

Income taxes

VM

14,232

-96.1%

369,511

2496.5%

14,231

Value added tax

VB

5,240,030

25.6%

4,173,106

9.7%

3,803,949

Other taxes and payments assimilated

VN

0

0%

0

0%

0

State and other public - Miscellaneous

VP

114,528

-56.1%

260,775

-85.8%

1,832,576

Group and Associates

VC

25,687,430

1245.7%

1,908,868

-78.4%

8,842,901

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

4,160,421

6.7%

3,898,859

12.8%

3,455,768

 

Prepaid

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Prepaid

VS

11,132,787

-7.9%

12,086,083

-7.5%

13,065,282

 

State Debt

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Total debt (gross)

VY

122,144,444

7.1%

114,021,734

27.4%

89,499,126

1 year at most

VZ2

118,268,016

8.7%

108,753,371

30.1%

83,592,876

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

3,281,250

-28.6%

4,593,750

-12.5%

5,250,000

More than 5 years

VZ4

595,178

-11.8%

674,613

2.8%

656,250

 

Details

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

3,040,033

-24.4%

4,023,007

-34.8%

6,174,708

1 year at most

VG2

3,040,033

-24.4%

4,023,007

-34.8%

6,174,708

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

4,593,750

-22.2%

5,906,250

-18.2%

7,218,750

1 year at most

VH2

1,312,500

0%

1,312,500

0%

1,312,500

More than 1 year and 5 years at most

VH3

3,281,250

-28.6%

4,593,750

-12.5%

5,250,000

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

4,823,151

615.0%

674,613

-14.3%

787,458

1 year at most

8A2

4,227,973

0%

0

0%

787,458

More than 1 year and 5 years at most

8A3

0

0%

0

0%

0

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

50,096,233

18.3%

42,364,363

-0.6%

42,622,927

1 year at most

8B2

50,096,233

18.3%

42,364,363

-0.6%

42,622,927

More than 1 year and 5 years at most

8B3

50,096,233

18.3%

42,364,363

-0.6%

42,622,927

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

8,559,877

4.5%

8,193,405

24.9%

6,561,440

1 year at most

8C2

8,559,877

4.5%

8,193,405

24.9%

6,561,440

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

5,270,389

-17.3%

6,374,433

7.0%

5,956,907

1 year at most

8D2

5,270,389

-17.3%

6,374,433

7.0%

5,956,907

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

46,901

0%

46,901

-65.5%

135,880

1 year at most

8E2

46,901

0%

46,901

-65.5%

135,880

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (Gross)

VW1

6,020,798

-4.4%

6,297,493

21.6%

5,180,063

1 year at most

VW2

6,020,798

-4.4%

6,297,493

21.6%

5,180,063

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

1,609,432

58.2%

1,017,596

129.3%

443,810

1 year at most

VQ2

1,609,432

58.2%

1,017,596

129.3%

443,810

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

489,187

1.0%

484,133

-2.9%

498,500

1 year at most

8J2

489,187

1.0%

484,133

-2.9%

498,500

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VI2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

V14

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

30,625,110

-14.1%

35,653,286

159.3%

13,749,233

1 year at most

8K2

30,625,110

-14.1%

35,653,286

159.3%

13,749,233

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

3,464,940

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

3,464,940

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

3,504,643

17.4%

2,986,254

1662.3%

169,450

1 year at most

8L2

3,504,643

17.4%

2,986,254

1662.3%

169,450

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

0

0%

0

 

References

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Loans made during the period

VJ

0

0%

0

0%

4,285,714

Debt repaid during the period

VK

0

0%

1,312,500

0%

0

 

Table allocation results and other information

Dividends distributed

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0

 

Commitments

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0

 

Other charges Externes

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0

 

Taxes and Fees

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0

 

VAT

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0

 

Average number of employees

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Average number of employees

YP

2,017

8.4%

1,860

-1.0%

1,879

 

Groups and Shareholders

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Groups and Shareholders

ZR

0

-

-

-

-

 

Ratios

Synthetic financial performance indicators

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

Score

Situation

Score

Situation

Score

Situation

HideAFDCC 2

-

-

-

-

-

-

Description

The AFDCC 2 score uses sectors of activity and company sizes for companies with a turnover of 150 000 to 75 million euros. This calculation allows a classification of the companies in three levels:

-

Healthy: the higher the score value is, the more the company is healthy.

-

Undetermined: it’s impossible to determine the situation.

-

Fragility/Failure: the lower the score value is, the more the company is in danger.

The status are completed which “+/-“ signs.

HideConan & Holder

0.18

0%

0.17

0%

0.20

0%

Description

The Conan and Holder (1979) is a recommended method for industrial companies with a turnover of 150 000 to 75 million euros. It is based only on a balance sheet. This calculation allows a classification of the most perilous situation (Score lower than 0.002) to the healthiest situation (score greater than 0.16):

-

Healthy situation: companies which maintain or develop their activity level.

-

Situation to monitor: companies which has to follow remedial measures or find a new strategy.

-

Perilous situation: companies which could have important cash difficulties and have a failure risk.

HideAltman

-

-

-

-

-

-

Description

The Altman score is a method based only on a complete balance sheet, this calculation allows a classification of the companies in three levels:

-

Good shape: companies which have a low risk (with a score value higher than 2.99).

-

Warning signs: companies which should be approached with caution and with a high risk in the next two years for bankruptcy (with a score value between 2.99 and 1.81).

-

Bankruptcy: companies which are in immediate risk (with a score value lower than 1.81).

 

Structure and Liquidity

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2015

Fixed Asset Financing

1.01

5.2%

0.96

-7.7%

1.04

1.23

-17.9%

Global Debt

124 days

6.0%

117 days

17.0%

100 days

179 days

-30.7%

Working Capital Fund overall net

2 days

122.2%

-9 days

-200.0%

9 days

39 days

-94.9%

Financial independence

908.17 %

-7.1%

977.31 %

34.6%

726.15 %

61.41 %

1378.9%

Solvability

46.64 %

0.5%

46.39 %

-10.1%

51.61 %

27.50 %

69.6%

Capacity debt futures

2,599.19 %

33.8%

1,942.31 %

41.2%

1,375.34 %

769.10 %

238.0%

Coverage of current assets by net working capital overall

1.74 %

117.3%

-10.06 %

-199.1%

10.15 %

31.60 %

-94.5%

General Liquidity

0.51

15.9%

0.44

-13.7%

0.51

0.10

410.0%

Restricted Liquidity

0.60

7.1%

0.56

-6.7%

0.60

0.35

71.4%

 

Management or rotation

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2015

Need background in operating working capital

-15 days

-150.0%

-6 days

62.5%

-16 days

15 days

-200.0%

Treasury

8 days

-42.9%

14 days

75.0%

8 days

2 days

300.0%

Inventory turnover of goods

105 days

15.4%

91 days

-9.9%

101 days

147 days

-28.6%

Average length of credit granted to customers

18 days

-28.0%

25 days

92.3%

13 days

0 days

0%

Average length of credit obtained suppliers

74 days

19.4%

62 days

-8.8%

68 days

48 days

54.2%

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

11 days

120.0%

5 days

66.7%

3 days

0 days

0%

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

-

-

-

-

-

432 days

-

Rotation tangible assets

278.79 %

-1.0%

281.52 %

1.0%

278.78 %

494.55 %

-43.6%

 

Profitability of the business

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2015

Margin trading

56.29 %

1.7%

55.36 %

1.7%

54.42 %

43.17 %

30.4%

Profitability of the business

14.87 %

7.3%

13.86 %

0.9%

13.73 %

4.07 %

265.4%

Net profit

7.90 %

50.2%

5.26 %

-5.2%

5.55 %

1.71 %

362.0%

Growth rate of turnover (excluding VAT)

0.77 %

-91.8%

9.40 %

286.5%

-5.04 %

-1.66 %

146.4%

Rates integration

31.35 %

2.5%

30.58 %

2.8%

29.75 %

24.17 %

29.7%

Rate leasing furniture

0.00 %

0%

0.00 %

0%

0.00 %

0.00 %

0%

Work Factor

47.30 %

-4.3%

49.42 %

2.6%

48.15 %

71.79 %

-34.1%

Weight interests

0.61 %

-67.4%

1.87 %

110.1%

0.89 %

0.44 %

38.6%

 

Return on capital

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2015

Cash flow from the overall profitability

8.92 %

2.5%

8.70 %

16.8%

7.45 %

3.95 %

125.8%

Rates of economic profitability

42.00 %

-2.3%

43.00 %

13.2%

38.00 %

9.89 %

324.7%

Financial profitability

113,130,684.00 %

9.2%

103,632,266.00 %

0.6%

102,974,296.00 %

3,556.00 %

3181302.8%

Return on investment

24.02 %

9.5%

21.94 %

24.0%

17.69 %

6.14 %

291.2%

 

Management intermediate balances

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2015

Turnover

354,306,011

0.8%

351,599,803

9.4%

321,388,603

219,447

161354.0%

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2015

Sales of goods

341,813,916

0.6%

339,644,101

9.9%

308,963,634

-

- Purchase of goods

147,663,967

3.2%

143,024,407

8.0%

132,454,195

-

+/- Stock of goods variation

-5,305,049

-367.5%

1,983,079

23.3%

1,608,472

-

Trading margin

199,454,998 €

2.5%

194,636,615 €

11.3%

174,900,967 €

88,139 €

226197.2%

56.29 % CA

1.7%

55.36 % CA

1.7%

54.42 % CA

43.60 % CA

29.1%

 

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2015

Sale of goods produced

12,492,094

4.5%

11,955,701

-3.8%

12,424,969

-

+/- Stocked production

0

0%

0

0%

0

-

+ Self-constructed assets

0

0%

0

0%

0

-

Period production

12,492,094 €

4.5%

11,955,701 €

-3.8%

12,424,969 €

0 €

0%

3.53 % CA

3.8%

3.40 % CA

-12.1%

3.87 % CA

0.00 % CA

0%

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2015

Trading margin

199,454,998

2.5%

194,636,615

11.3%

174,900,967

88,139

226197.2%

+ Period Production

12,492,094

4.5%

11,955,701

-3.8%

12,424,969

0

0%

- Purchase of raw materials

2,464,871

23.1%

2,001,936

0.3%

1,995,241

-

+/- Change in stocks of raw materiels

0

0%

0

0%

0

-

- Other external purchases and charges

98,419,863

1.4%

97,088,718

8.2%

89,721,963

-

Added value

111,062,358 €

3.3%

107,501,662 €

12.4%

95,608,732 €

56,295 €

197188.1%

31.35 % CA

2.5%

30.58 % CA

2.8%

29.75 % CA

24.17 % CA

29.7%

 

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2015

Added value

111,062,358 €

3.3%

107,501,662 €

12.4%

95,608,732 €

56,295 €

197188.1%

+ Operating grants

0

0%

0

0%

0

-

- Tax, duty and similar payments

5,847,926

3.9%

5,627,987

3.3%

5,447,031

-

- Personal charges

52,536,358

-1.1%

53,130,425

15.4%

46,040,303

-

Gross operating surplus

52,678,074 €

8.1%

48,743,250 €

10.5%

44,121,398 €

8,053 €

654042.2%

14.87 % CA

7.3%

13.86 % CA

0.9%

13.73 % CA

4.07 % CA

265.4%

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2015

Gross operating surplus

52,678,074 €

8.1%

48,743,250 €

10.5%

44,121,398 €

8,053 €

654042.2%

+ Release of reserves and provisions

18,176,009

96.3%

9,258,333

11.8%

8,278,674

-

+ Other operating income

845,159

-12.4%

964,437

139.7%

402,421

-

- Depreciation/ Amortisation

29,454,964

53.7%

19,168,347

-0.1%

19,182,372

-

- Other charges

782,586

-21.2%

992,514

26.1%

786,943

-

Operating result

41,461,692 €

6.8%

38,805,159 €

18.2%

32,833,178 €

4,577 €

905869.5%

11.70 % CA

6.0%

11.04 % CA

8.0%

10.22 % CA

2.27 % CA

415.4%

 

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2015

Operating result

41,461,692 €

6.8%

38,805,159 €

18.2%

32,833,178 €

4,577 €

905869.5%

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

-

+ Financial income

2,866,998

-52.6%

6,051,339

225.9%

1,856,614

-

- Financial charges

2,163,869

-67.0%

6,559,768

128.6%

2,869,269

-

Pre-tax result

42,164,821 €

10.1%

38,296,730 €

20.4%

31,820,523 €

3,412 €

1235861.3%

11.90 % CA

9.3%

10.89 % CA

10.0%

9.90 % CA

1.72 % CA

591.9%

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2015

Extraordinary income

659,036

-15.9%

783,948

2286.5%

32,849

0

0%

- Extraordinary charges

870,049

-77.3%

3,832,900

137.1%

1,616,888

-

Extraordinary result

-211,013 €

93.1%

-3,048,952 €

-92.5%

-1,584,039 €

0 €

0%

-0.06 % CA

93.1%

-0.87 % CA

-77.6%

-0.49 % CA

0.00 % CA

0%

 

31/12/2015

Variation

31/12/2014

Variation

31/12/2013

SECTOR MEDIAN 2015

Pre-tax result

42,164,821 €

10.1%

38,296,730 €

20.4%

31,820,523 €

3,412 €

1235861.3%

Extraordinary result

-211,013 €

93.1%

-3,048,952 €

-92.5%

-1,584,039 €

0 €

0%

- Employee profit sharing

1,927,061

-33.9%

2,917,312

38.1%

2,112,712

-

- Tax on profits

12,020,336

-13.0%

13,822,473

34.5%

10,273,749

-

Net result

28,006,411 €

51.3%

18,507,993 €

3.7%

17,850,023 €

3,513 €

797235.5%

7.90 % CA

50.2%

5.26 % CA

-5.2%

5.55 % CA

1.71 % CA

362.0%

 

 

Key Performance Indicators

 

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

Company Result

354,306,011 €

351,599,803 €

321,388,603 €

Sector Average

1,410,032 €

1,419,358 €

1,423,473 €

 

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

Company Result

28,006,413 €

18,507,995 €

17,850,025 €

Sector Average

7,686 €

6,350 €

17,118 €

 

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

Company Result

26,957,268 €

24,453,276 €

19,689,427 €

Sector Average

93,620 €

92,059 €

89,550 €

 

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

Company Result

242,544,365 €

223,382,941 €

199,527,953 €

Sector Average

1,004,508 €

1,020,807 €

1,008,480 €

 

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

Company Result

113,130,684 €

103,632,266 €

102,974,296 €

Sector Average

359,687 €

350,186 €

349,673 €

 

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

Company Result

122,144,444 €

114,021,733 €

89,499,126 €

Sector Average

630,112 €

658,542 €

646,183 €

 

 

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

Company Result

-15 €

-6 €

-16 €

Sector Average

46 €

-20 €

-225 €

 

 

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

Company Result

52,678,074 €

48,743,250 €

44,121,398 €

Sector Average

70,427 €

70,813 €

85,375 €

Description: \\vivek-pc\123 Foreign Report Raw\JULES_files\PdfDelayPixel


 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency

Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

INR 67.83

UK Pound

1

INR 91.68

Euro

1

INR 80.29

Euro

1

INR 80.16

 

Note : Above are approximate rates obtained from sources believed to be correct

 

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

NIS

 

 

Report Prepared by :

KET

 


 

RATING EXPLANATIONS

 

Credit Rating

 

Explanation

Rating Comments

A++

Minimum Risk

Business dealings permissible with minimum risk of default

A+

Low Risk

Business dealings permissible with low risk of default

A

Acceptable Risk

Business dealings permissible with moderate risk of default

B

Medium Risk

Business dealings permissible on a regular monitoring basis

C

Medium High Risk

Business dealings permissible preferably on secured basis

D

High Risk

Business dealing not recommended or on secured terms only

NB

New Business

No recommendation can be done due to business in infancy stage

NT

No Trace

No recommendation can be done as the business is not traceable

 

NB is stated where there is insufficient information to facilitate rating. However, it is not to be considered as unfavourable.

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors are as follows:

 

·         Financial condition covering various ratios

·         Company background and operations size

·         Promoters / Management background

·         Payment record

·         Litigation against the subject

·         Industry scenario / competitor analysis

·         Supplier / Customer / Banker review (wherever available)

 

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

This report is issued at your request without any risk and responsibility on the part of MIRA INFORM PRIVATE LIMITED (MIPL) or its officials.